WYNDEHAM HUBBARD LIMITED

  • Vue d'ensemble
  • Résumé
  • Objet social
  • Adresse
  • Dénominations sociales précédentes
  • Comptes
  • Dépôts
  • Dirigeants
  • Personnes ayant un contrôle significatif
  • Charges
  • Source de données
  • Vue d'ensemble

    Nom de la sociétéWYNDEHAM HUBBARD LIMITED
    Statut de la sociétéDissoute
    Forme juridiqueSociété à responsabilité limitée
    Numéro de société 00685005
    JuridictionAngleterre/Pays de Galles
    Date de création
    Date de cessation d'activité

    Résumé

    A des PSCs super sécurisésNon
    A des chargesOui
    A un historique d'insolvabilitéNon
    Le siège social est contestéNon

    Quel est l'objet de WYNDEHAM HUBBARD LIMITED ?

    • Société inactive (99999) / Activités des organisations et organismes extraterritoriaux

    Où se situe WYNDEHAM HUBBARD LIMITED ?

    Adresse du siège social
    18 Westside Centre London Road
    Stanway
    CO3 8PH Colchester
    England
    Adresse du siège social non livrableNon

    Quels étaient les noms précédents de WYNDEHAM HUBBARD LIMITED ?

    Dénominations sociales précédentes
    Nom de la sociétéDeJusqu'au
    B.R.HUBBARD PRINTERS LIMITED01 mars 196101 mars 1961

    Quels sont les derniers comptes de WYNDEHAM HUBBARD LIMITED ?

    Derniers comptes
    Derniers comptes arrêtés au31 déc. 2020

    Quels sont les derniers dépôts pour WYNDEHAM HUBBARD LIMITED ?

    Dépôts
    DateDescriptionDocumentType

    Bulletin officiel final dissous par radiation volontaire

    1 pagesGAZ2(A)

    Premier avis au Bulletin officiel pour la radiation volontaire

    1 pagesGAZ1(A)

    Demande de radiation de la société du registre du commerce

    3 pagesDS01

    Comptes de micro-entité établis au 31 déc. 2020

    3 pagesAA

    Changement d'adresse du siège social de 18 London Road Stanway Colchester CO3 8PH England à 18 Westside Centre London Road Stanway Colchester CO3 8PH le 20 juil. 2021

    1 pagesAD01

    Déclaration de confirmation établie le 30 juin 2021 sans mise à jour

    3 pagesCS01

    Comptes de micro-entité établis au 31 déc. 2019

    3 pagesAA

    Changement d'adresse du siège social de 22 Westside Centre London Road Colchester Essex CO3 8PH England à 18 London Road Stanway Colchester CO3 8PH le 02 oct. 2020

    1 pagesAD01

    Déclaration de confirmation établie le 30 juin 2020 sans mise à jour

    3 pagesCS01

    Cessation de la nomination de Zoe Repman en tant que secrétaire le 19 sept. 2019

    1 pagesTM02

    Comptes de micro-entité établis au 31 déc. 2018

    2 pagesAA

    Satisfaction de la charge 11 en totalité

    1 pagesMR04

    Déclaration de confirmation établie le 30 juin 2019 sans mise à jour

    3 pagesCS01

    Comptes de micro-entité établis au 31 déc. 2017

    2 pagesAA

    Déclaration de confirmation établie le 30 juin 2018 sans mise à jour

    3 pagesCS01

    Comptes de micro-entité établis au 31 déc. 2016

    2 pagesAA

    Déclaration de confirmation établie le 30 juin 2017 sans mise à jour

    3 pagesCS01

    Comptes d'exonération totale pour petite entreprise établis au 31 déc. 2015

    3 pagesAA

    Déclaration de confirmation établie le 30 juin 2016 avec mises à jour

    5 pagesCS01

    Changement d'adresse du siège social de Bentalls Complex Colchester Road Heybridge Essex CM9 4NW à 22 Westside Centre London Road Colchester Essex CO3 8PH le 24 août 2016

    1 pagesAD01

    Modification des coordonnées de l'administrateur Mr Paul George Utting le 22 juin 2016

    2 pagesCH01

    Comptes d'exonération totale pour petite entreprise établis au 31 déc. 2014

    3 pagesAA

    Déclaration annuelle jusqu'au 30 juin 2015 avec liste complète des actionnaires

    3 pagesAR01
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    capital19 août 2015

    État du capital au 19 août 2015

    • Capital: GBP 235,950
    SH01

    Comptes d'exonération totale établis au 31 déc. 2013

    5 pagesAA

    Déclaration annuelle jusqu'au 30 juin 2014 avec liste complète des actionnaires

    3 pagesAR01
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    capital18 juil. 2014

    État du capital au 18 juil. 2014

    • Capital: GBP 235,950
    SH01

    Qui sont les dirigeants de WYNDEHAM HUBBARD LIMITED ?

    Dirigeants
    NomNommé leDate de démissionRôleAdresseIdentification de la sociétéPays de résidenceNationalitéDate de naissanceProfessionNuméro
    UTTING, Paul George
    Westside Centre, London Road
    CO3 8PH Colchester
    22
    Essex
    England
    Administrateur
    Westside Centre, London Road
    CO3 8PH Colchester
    22
    Essex
    England
    EnglandBritishDirector65550960005
    HOLLEBONE, Paul Stephen
    Old Orchard Dog Lane
    BN44 3GE Steyning
    West Sussex
    Secrétaire
    Old Orchard Dog Lane
    BN44 3GE Steyning
    West Sussex
    BritishChartered Accountant15201600002
    HUBBARD, Barrie Weymouth
    Sickle Cottage Ridgeway Moor Farm
    Ridgeway
    S12 3XW Sheffield
    South Yorkshire
    Secrétaire
    Sickle Cottage Ridgeway Moor Farm
    Ridgeway
    S12 3XW Sheffield
    South Yorkshire
    British2012700001
    REPMAN, Zoe
    Westside Centre
    London Road
    CO3 8PH Colchester
    22
    Essex
    England
    Secrétaire
    Westside Centre
    London Road
    CO3 8PH Colchester
    22
    Essex
    England
    147370870001
    UTTING, Paul George
    2 Walpole Gardens
    Strawberry Hill
    TW2 5SJ Twickenham
    Secrétaire
    2 Walpole Gardens
    Strawberry Hill
    TW2 5SJ Twickenham
    British65550960004
    BEDSON, Bryan Stanley
    The Old Rectory
    Patching
    BN13 3XF Arundel
    West Sussex
    Administrateur
    The Old Rectory
    Patching
    BN13 3XF Arundel
    West Sussex
    United KingdomBritishCompany Director18576770001
    COPPOCK, Lawrence Patrick
    The Close
    Church Lane
    SO51 0QH Braishfield
    Hampshire
    Administrateur
    The Close
    Church Lane
    SO51 0QH Braishfield
    Hampshire
    EnglandUnited KingdomChartered Accountant152718990001
    EDWARDS, Michael Ian
    42 Petworth Close
    CM77 7XS Great Notley
    Essex
    Administrateur
    42 Petworth Close
    CM77 7XS Great Notley
    Essex
    BritishChartered Accountant115842570001
    FOX, Colin Charles
    18 Mount Crescent
    Broadmeadows
    DE55 3NS Alfreton
    Derbyshire
    Administrateur
    18 Mount Crescent
    Broadmeadows
    DE55 3NS Alfreton
    Derbyshire
    BritishPrinter77114410001
    HERON, Edward Richard
    3 The Granaries
    Station Road
    CM9 4LQ Maldon
    Essex
    Administrateur
    3 The Granaries
    Station Road
    CM9 4LQ Maldon
    Essex
    BritishPrinter4125100002
    HOLLEBONE, Paul Stephen
    Old Orchard Dog Lane
    BN44 3GE Steyning
    West Sussex
    Administrateur
    Old Orchard Dog Lane
    BN44 3GE Steyning
    West Sussex
    EnglandBritishChartered Accountant15201600002
    HUBBARD, Barrie Weymouth
    Sickle Cottage Ridgeway Moor Farm
    Ridgeway
    S12 3XW Sheffield
    South Yorkshire
    Administrateur
    Sickle Cottage Ridgeway Moor Farm
    Ridgeway
    S12 3XW Sheffield
    South Yorkshire
    United KingdomBritishPrinter2012700001
    HUBBARD, John
    20 Morley Close
    Dronfield Woodhouse
    S18 5YQ Sheffield
    Administrateur
    20 Morley Close
    Dronfield Woodhouse
    S18 5YQ Sheffield
    United KingdomBritishPrinter26988890001
    MYLES, Malcolm
    4 Longcroft Avenue
    Dronfield Woodhouse
    S18 8PJ Dronfield Sheffield
    Administrateur
    4 Longcroft Avenue
    Dronfield Woodhouse
    S18 8PJ Dronfield Sheffield
    BritishPrinter29348250003
    OWEN, Jonathan Spencer
    42 Woodland Avenue
    BN3 6BL Hove
    East Sussex
    Administrateur
    42 Woodland Avenue
    BN3 6BL Hove
    East Sussex
    BritishChartered Accountant92040070002
    PAGE, Andrew Stephen
    29 Russell Avenue
    MK40 3TD Bedford
    Bedfordshire
    Administrateur
    29 Russell Avenue
    MK40 3TD Bedford
    Bedfordshire
    EnglandBritishDirector86557080001

    Qui sont les personnes ayant un contrôle significatif sur WYNDEHAM HUBBARD LIMITED ?

    Personnes ayant un contrôle significatif
    NomNotifié leAdresseCessé
    Wyndeham Press Group Limited
    Westside Centre, London Road
    CO3 8PH Colchester
    22
    England
    06 avr. 2016
    Westside Centre, London Road
    CO3 8PH Colchester
    22
    England
    Non
    Forme juridiqueLimited Company
    Pays d'enregistrementEngland
    Autorité légaleCompanies Act 2006
    Lieu d'enregistrementUk Companies House
    Numéro d'enregistrement933418
    Nature du contrôle
    • La personne détient, directement ou indirectement, plus de 75 % des actions de la société.

    WYNDEHAM HUBBARD LIMITED a-t-elle des charges ?

    Charges
    ClassificationDatesStatutDétails
    Full form debenture
    Créé le 05 déc. 2008
    Livré le 19 déc. 2008
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, fixtures, fixed plant & machinery. See image for full details.
    Personnes ayant droit
    • Leumi Abl Limited
    Transactions
    • 19 déc. 2008Enregistrement d'une charge (395)
    • 26 mai 2011Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (MG02)
    Debenture
    Créé le 01 déc. 2006
    Livré le 08 déc. 2006
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Landsbanki Commercial Finance
    Transactions
    • 08 déc. 2006Enregistrement d'une charge (395)
    • 02 août 2019Satisfaction d'une charge (MR04)
    Chattels mortgage
    Créé le 01 déc. 2006
    Livré le 08 déc. 2006
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    Assigns by way of security the mortgaged chattels,the benefit of any obligations,guarantees and warranties undertaken or given,all maintenance or support agreements,all authorisations,the benefit of the insurance proceeds. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Landsbanki Commercial Finance
    Transactions
    • 08 déc. 2006Enregistrement d'une charge (395)
    • 11 déc. 2008Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Deed of accession and restatement
    Créé le 07 juin 2006
    Livré le 13 juin 2006
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee and/or the other security beneficiaries (or any of them) on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    Property being, the bentalls complex, colchester road, maldon, essex t/no EX443872. Castle press, 371, victoria street,grimsby t/no HS165423. Unit 11/12 grange industrial estate, grange road, southwick, west sussex t/no WSX142782. For details of further property charged please R. fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Landsbanki Islands Hf (As Security Trustee for the Security Beneficiaries) the Security Trustee
    Transactions
    • 13 juin 2006Enregistrement d'une charge (395)
    • 03 févr. 2007Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Debenture
    Créé le 20 juil. 2005
    Livré le 02 août 2005
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personnes ayant droit
    • Barclays Bank PLC
    Transactions
    • 02 août 2005Enregistrement d'une charge (395)
    • 19 déc. 2006Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Chattel mortgage
    Créé le 20 nov. 1995
    Livré le 24 nov. 1995
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Assignment of komori lithrone L44011 four colour offset printing press serial number 1063 ("the equipment") including any part or parts thereto and all additions alterations and accessories replacements and renewals of component parts thereto together with the benefit of all obligations and warranties given by any manufacturer or supplier of the equipment and all other obligations and warranties given by any other party in respect of the equipment to or in favour of the company and without prejudice to the generality of the foregoing the benefit of all maintenance agreements entered into between the company and any such third party.
    Personnes ayant droit
    • National Westminster Bank PLC
    Transactions
    • 24 nov. 1995Enregistrement d'une charge (395)
    • 04 mars 1998Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Legal mortgage
    Créé le 12 août 1993
    Livré le 16 août 1993
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    F/H-callywhite lane dronfield in the county of derby and/or the proceeds of sale thereof and assigns the goodwill of the business and the full benefit of all licences. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Personnes ayant droit
    • National Westminster Bank PLC
    Transactions
    • 16 août 1993Enregistrement d'une charge (395)
    • 05 déc. 1994Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Mortgage debenture
    Créé le 23 juil. 1993
    Livré le 30 juil. 1993
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    A specific equitable charge over all freehold and leasehold properties and/or the proceeds of sale thereof fixed and floating charges over undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts and the benefits of any licences.
    Personnes ayant droit
    • National Westminster Bank PLC
    Transactions
    • 30 juil. 1993Enregistrement d'une charge (395)
    • 06 août 1999Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Deed
    Créé le 21 sept. 1982
    Livré le 30 sept. 1982
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to williams & glyn's bank PLC supplemental to a debenture dated 15 jan. 1965.
    Brèves mentions
    All book debts & other debts present & future.
    Personnes ayant droit
    • Mosley Street Nominees Limited.
    Transactions
    • 30 sept. 1982Enregistrement d'une charge
    • 16 sept. 1994Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Legal charge
    Créé le 25 juin 1980
    Livré le 07 juil. 1980
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    F/Hold land and buildings fronting callywhite lane, dronfield, north east derbyshire together with all fixtures whatsoever now or at any time there after affixed or attached to the property or any part thereof other than trade machinery as defined by section 5 of the bills of sale act 1878. all fixed and moveable plant, machinery and fixtures implements and utensils.
    Personnes ayant droit
    • Williams & Glyn's Bank Limited
    Transactions
    • 07 juil. 1980Enregistrement d'une charge
    • 16 sept. 1994Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Legal charge
    Créé le 11 nov. 1976
    Livré le 22 nov. 1976
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All moneys due etc. to williams beacon's bank LTD.
    Brèves mentions
    1. f/h piece or parcel of land situate fronting to callywhite lane dronfield derbyshire containing 943 sq yds approx: excepting therefrom 200 sq. Yards. 2. and further pieces of land situate nr to gallywhite lane aforesaid. Together with all fixtures whatsoever, defined by sect 5 of the bills of sale act 1878. all fixed & movable plant machinery & fixtures, implements & utensils from time to time therein or thereon.
    Personnes ayant droit
    • Williams & Glyn's Bank LTD.
    Transactions
    • 22 nov. 1976Enregistrement d'une charge
    • 16 sept. 1994Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Mortgage debenture
    Créé le 15 janv. 1965
    Livré le 20 janv. 1965
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All moneys due etc. to williams beacon's bank LTD.
    Brèves mentions
    Undertaking and goodwill all property and assets present and future including uncalled capital with all buildings & fixtures (see doc. 20).
    Personnes ayant droit
    • Mosley Street Nominees LTD.
    Transactions
    • 20 janv. 1965Enregistrement d'une charge
    • 15 oct. 1993Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)

    Source de données

    • Companies House du Royaume-Uni
      Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers.
    • Licence: CC0