BIRCH CONSTRUCTION DIVISION LIMITED

BIRCH CONSTRUCTION DIVISION LIMITED

  • Vue d'ensemble
  • Résumé
  • Objet social
  • Adresse
  • Dénominations sociales précédentes
  • Comptes
  • Dépôts
  • Dirigeants
  • Personnes ayant un contrôle significatif
  • Charges
  • Source de données
  • Vue d'ensemble

    Nom de la sociétéBIRCH CONSTRUCTION DIVISION LIMITED
    Statut de la sociétéDissoute
    Forme juridiqueSociété à responsabilité limitée
    Numéro de société 00688041
    JuridictionAngleterre/Pays de Galles
    Date de création
    Date de cessation d'activité

    Résumé

    A des PSCs super sécurisésNon
    A des chargesOui
    A un historique d'insolvabilitéNon
    Le siège social est contestéNon

    Quel est l'objet de BIRCH CONSTRUCTION DIVISION LIMITED ?

    • Construction de bâtiments commerciaux (41201) / Construction

    Où se situe BIRCH CONSTRUCTION DIVISION LIMITED ?

    Adresse du siège social
    Blake House 3 Frayswater Place
    Cowley
    UB8 2AD Uxbridge
    Middlesex
    United Kingdom
    Adresse du siège social non livrableNon

    Quels étaient les noms précédents de BIRCH CONSTRUCTION DIVISION LIMITED ?

    Dénominations sociales précédentes
    Nom de la sociétéDeJusqu'au
    GRANITE CONSTRUCTION LIMITED08 mars 198808 mars 1988
    GRANITE CONSTRUCTION (DERBY) LIMITED27 mars 196127 mars 1961

    Quels sont les derniers comptes de BIRCH CONSTRUCTION DIVISION LIMITED ?

    Derniers comptes
    Derniers comptes arrêtés au30 juin 2020

    Quels sont les derniers dépôts pour BIRCH CONSTRUCTION DIVISION LIMITED ?

    Dépôts
    DateDescriptionDocumentType

    Bulletin officiel final dissous par radiation volontaire

    1 pagesGAZ2(A)

    La procédure de radiation volontaire a été suspendue.

    1 pagesSOAS(A)

    Premier avis au Bulletin officiel pour la radiation volontaire

    1 pagesGAZ1(A)

    Demande de radiation de la société du registre du commerce

    1 pagesDS01

    Cessation de Galliford Try Building 2014 Limited en tant que personne disposant d'un contrôle significatif le 27 juil. 2021

    1 pagesPSC07

    Modification des détails de Galliford Try Construction (Uk) Limited en tant que personne disposant d'un contrôle significatif le 23 déc. 2019

    2 pagesPSC05

    Modification des détails de Galliford Try Construction (Uk) Limited en tant que personne disposant d'un contrôle significatif le 06 avr. 2016

    2 pagesPSC05

    Notification de Galliford Try Corporate Holdings Limited en tant que personne disposant d'un contrôle significatif le 27 juil. 2021

    2 pagesPSC02

    Comptes pour une société dormante établis au 30 juin 2020

    8 pagesAA

    Modification des coordonnées du secrétaire Galliford Try Secretariat Services Limited le 18 janv. 2021

    1 pagesCH04

    Changement d'adresse du siège social de Cowley Business Park Cowley Uxbridge Middlesex UB8 2AL à Blake House 3 Frayswater Place Cowley Uxbridge Middlesex UB8 2AD le 18 janv. 2021

    1 pagesAD01

    Déclaration de confirmation établie le 30 oct. 2020 sans mise à jour

    3 pagesCS01

    Comptes pour une société dormante établis au 30 juin 2019

    8 pagesAA

    Déclaration de confirmation établie le 30 oct. 2019 sans mise à jour

    3 pagesCS01

    Nomination de Neil David Cocker en tant qu'administrateur le 30 juin 2019

    2 pagesAP01

    Cessation de la nomination de Martin Cooper en tant que directeur le 30 juin 2019

    1 pagesTM01

    Comptes pour une société dormante établis au 30 juin 2018

    8 pagesAA

    Déclaration de confirmation établie le 30 oct. 2018 sans mise à jour

    3 pagesCS01

    Résolutions

    Resolutions
    2 pagesRESOLUTIONS
    Résolutions
    CatégorieDateDescriptionType
    capital

    Résolutions

    Chairmans report directrs change director or secretary to sign report 16/03/2018
    RES13

    Comptes pour une société dormante établis au 30 juin 2017

    8 pagesAA

    Déclaration de confirmation établie le 26 oct. 2017 avec mises à jour

    4 pagesCS01

    Modification des coordonnées de l'administrateur Martin Cooper le 15 mai 2017

    2 pagesCH01

    Comptes pour une société dormante établis au 30 juin 2016

    7 pagesAA

    Déclaration de confirmation établie le 11 oct. 2016 avec mises à jour

    5 pagesCS01

    Modification des coordonnées de l'administrateur Mr Ian Thomas Jubb le 22 avr. 2016

    2 pagesCH01

    Qui sont les dirigeants de BIRCH CONSTRUCTION DIVISION LIMITED ?

    Dirigeants
    NomNommé leDate de démissionRôleAdresseIdentification de la sociétéPays de résidenceNationalitéDate de naissanceProfessionNuméro
    GALLIFORD TRY SECRETARIAT SERVICES LIMITED
    3 Frayswater Place
    Cowley
    UB8 2AD Uxbridge
    Blake House
    Middlesex
    United Kingdom
    Secrétaire
    3 Frayswater Place
    Cowley
    UB8 2AD Uxbridge
    Blake House
    Middlesex
    United Kingdom
    Type d'identificationSociété à responsabilité limitée du Royaume-Uni
    Numéro d'enregistrement07970508
    167168750001
    COCKER, Neil David
    Rossett Close
    Northwich
    CW9 8WP Cheshire
    5
    United Kingdom
    Administrateur
    Rossett Close
    Northwich
    CW9 8WP Cheshire
    5
    United Kingdom
    EnglandBritishCompany Director260158230001
    JUBB, Ian Thomas
    3 Frayswater Place
    Cowley
    UB8 2AD Uxbridge
    Blake House
    Middlesex
    United Kingdom
    Administrateur
    3 Frayswater Place
    Cowley
    UB8 2AD Uxbridge
    Blake House
    Middlesex
    United Kingdom
    United KingdomBritishSenior Management162269970002
    COX, John Andrew
    9 Premier Avenue
    DE6 1LH Ashbourne
    Derbyshire
    Secrétaire
    9 Premier Avenue
    DE6 1LH Ashbourne
    Derbyshire
    British30901630004
    DONALDSON, Euan James
    28 Trainers Brae
    EH39 4NR North Berwick
    East Lothian
    Secrétaire
    28 Trainers Brae
    EH39 4NR North Berwick
    East Lothian
    BritishDirector41273760002
    MACKINNON, Iain Lachlan
    1 Hermitage Drive
    EH10 6DE Edinburgh
    Secrétaire
    1 Hermitage Drive
    EH10 6DE Edinburgh
    British66282570001
    SMYTH, Pamela June
    6060 Knights Court, Solihull Parkway
    Birmingham Business Park
    B37 7WY Birmingham
    C/O Miller Construction (Uk) Limited
    West Midland
    Secrétaire
    6060 Knights Court, Solihull Parkway
    Birmingham Business Park
    B37 7WY Birmingham
    C/O Miller Construction (Uk) Limited
    West Midland
    British65057960002
    WILSON, Mark William
    18 Silverdale Close
    Ecclesall
    S11 9JN Sheffield
    South Yorkshire
    Secrétaire
    18 Silverdale Close
    Ecclesall
    S11 9JN Sheffield
    South Yorkshire
    British78419380001
    COOPER, Martin
    Cowley
    UB8 2AL Uxbridge
    Cowley Business Park
    Middlesex
    England
    Administrateur
    Cowley
    UB8 2AL Uxbridge
    Cowley Business Park
    Middlesex
    England
    ScotlandBritishChartered Accountant156200280002
    COX, John Andrew
    9 Premier Avenue
    DE6 1LH Ashbourne
    Derbyshire
    Administrateur
    9 Premier Avenue
    DE6 1LH Ashbourne
    Derbyshire
    BritishChartered Accountant30901630004
    ENDSOR, Christopher John
    Maple Croft
    Dalbury Lees
    DE6 5BE Ashbourne
    Derbyshire
    England
    Administrateur
    Maple Croft
    Dalbury Lees
    DE6 5BE Ashbourne
    Derbyshire
    England
    United KingdomBritishManaging Director86411120001
    FINNEGAN, Thomas Gerard
    6 Swallow Close
    Mickleover
    DE3 5XD Derby
    Administrateur
    6 Swallow Close
    Mickleover
    DE3 5XD Derby
    BritishQuantity Surveyor6043480003
    GADSBY, Peter James
    Burley Grange
    Burley Lane Quarndon
    DE22 5JR Derby
    Derbyshire
    Administrateur
    Burley Grange
    Burley Lane Quarndon
    DE22 5JR Derby
    Derbyshire
    EnglandBritishChairman93167510001
    GIBSON, Neil Calum
    139 Overlane
    DE56 0HN Belper
    Derbyshire
    Administrateur
    139 Overlane
    DE56 0HN Belper
    Derbyshire
    BritishEstimating Director33685320001
    GOODWIN, Roger Charles
    50 Green Lane
    Ockbrook
    DE72 3SE Derby
    Administrateur
    50 Green Lane
    Ockbrook
    DE72 3SE Derby
    BritishDevelopment Director - Design33685310001
    HODSDEN, Richard David
    6060 Knights Court, Solihull Parkway
    Birmingham Business Park
    B37 7WY Birmingham
    C/O Miller Construction (Uk) Limited
    West Midland
    Administrateur
    6060 Knights Court, Solihull Parkway
    Birmingham Business Park
    B37 7WY Birmingham
    C/O Miller Construction (Uk) Limited
    West Midland
    EnglandBritishFinance Director183337930001
    LITTING, Kevin George Wedgwood
    Cedar House 15 Hollies Road
    Allestree
    DE22 2HX Derby
    Administrateur
    Cedar House 15 Hollies Road
    Allestree
    DE22 2HX Derby
    United KingdomBritishFinancial Director41497590002
    MCBRIDE, Garry
    12 Cumberhills Road
    Duffield
    DE56 4HA Derby
    Derbyshire
    Administrateur
    12 Cumberhills Road
    Duffield
    DE56 4HA Derby
    Derbyshire
    BritishCompany Director53509590001
    MILLER, Keith Manson
    6060 Knights Court, Solihull Parkway
    Birmingham Business Park
    B37 7WY Birmingham
    C/O Miller Construction (Uk) Limited
    West Midland
    Administrateur
    6060 Knights Court, Solihull Parkway
    Birmingham Business Park
    B37 7WY Birmingham
    C/O Miller Construction (Uk) Limited
    West Midland
    ScotlandBritishCompany Director546650002
    RICHARDS, John Steel
    6060 Knights Court, Solihull Parkway
    Birmingham Business Park
    B37 7WY Birmingham
    C/O Miller Construction (Uk) Limited
    West Midland
    Administrateur
    6060 Knights Court, Solihull Parkway
    Birmingham Business Park
    B37 7WY Birmingham
    C/O Miller Construction (Uk) Limited
    West Midland
    United KingdomBritishFinancial Director1318380002
    SMALLEY, William Anthony
    Furnace Pond Farm
    Dale Road
    DE7 4PF Dale Abbey
    Derbyshire
    Administrateur
    Furnace Pond Farm
    Dale Road
    DE7 4PF Dale Abbey
    Derbyshire
    BritishContracts Director84234000001
    TURNER, Charles Robert
    45 Charlecote Drive
    NG8 2SD Nottingham
    Nottinghamshire
    Administrateur
    45 Charlecote Drive
    NG8 2SD Nottingham
    Nottinghamshire
    BritishMarketing Director21893200001
    WHEATCROFT, Mitchell
    17 Bakers Hill
    Heage
    DE56 2BL Belper
    Derbyshire
    Administrateur
    17 Bakers Hill
    Heage
    DE56 2BL Belper
    Derbyshire
    BritishEstimator6043510001
    WILSON, Mark William
    18 Silverdale Close
    Ecclesall
    S11 9JN Sheffield
    South Yorkshire
    Administrateur
    18 Silverdale Close
    Ecclesall
    S11 9JN Sheffield
    South Yorkshire
    BritishFinance78419380001

    Qui sont les personnes ayant un contrôle significatif sur BIRCH CONSTRUCTION DIVISION LIMITED ?

    Personnes ayant un contrôle significatif
    NomNotifié leAdresseCessé
    2 Lochside View
    EH12 1LB Edinburgh
    PO BOX 17452
    Scotland
    Scotland
    27 juil. 2021
    2 Lochside View
    EH12 1LB Edinburgh
    PO BOX 17452
    Scotland
    Scotland
    Non
    Forme juridiqueLimited By Shares
    Pays d'enregistrementScotland
    Autorité légaleUnited Kingdom (Scotland)
    Lieu d'enregistrementCompanies House
    Numéro d'enregistrementSc288228
    Nature du contrôle
    • La personne détient, directement ou indirectement, plus de 75 % des actions de la société.
    • La personne détient, directement ou indirectement, plus de 75 % des droits de vote dans la société.
    • La personne détient, directement ou indirectement, le droit de nommer ou de révoquer une majorité des membres du conseil d'administration de la société.
    Galliford Try Building 2014 Limited
    Lochside View
    17452
    EH12 1LB Edinburgh
    2
    Scotland
    06 avr. 2016
    Lochside View
    17452
    EH12 1LB Edinburgh
    2
    Scotland
    Oui
    Forme juridiqueListed By Shares
    Pays d'enregistrementScotland
    Autorité légaleCompanies Act 1985
    Lieu d'enregistrementCompanies House Edinburgh
    Numéro d'enregistrementSc209666
    Nature du contrôle
    • La personne détient, directement ou indirectement, plus de 75 % des actions de la société.
    • La personne détient, directement ou indirectement, plus de 75 % des droits de vote dans la société.
    • La personne détient, directement ou indirectement, le droit de nommer ou de révoquer une majorité des membres du conseil d'administration de la société.

    BIRCH CONSTRUCTION DIVISION LIMITED a-t-elle des charges ?

    Charges
    ClassificationDatesStatutDétails
    Mortgage debenture
    Créé le 19 déc. 1996
    Livré le 30 déc. 1996
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    A specific equitable charge over all freehold and leasehold properties and/or the proceeds of sale thereof fixed and floating charges over undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts and the benefits of any licences.
    Personnes ayant droit
    • National Westminster Bank PLC
    Transactions
    • 30 déc. 1996Enregistrement d'une charge (395)
    • 20 juin 2001Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Floating charge
    Créé le 16 mars 1989
    Livré le 23 mars 1989
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Undertaking and all property and assets present and future.
    Personnes ayant droit
    • Barclays Bank PLC
    Transactions
    • 23 mars 1989Enregistrement d'une charge
    • 20 juin 2001Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Debenture
    Créé le 19 janv. 1988
    Livré le 27 janv. 1988
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personnes ayant droit
    • The Royal Bank of Scotland PLC.
    Transactions
    • 27 janv. 1988Enregistrement d'une charge
    • 20 juin 2001Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Charge
    Créé le 08 oct. 1982
    Livré le 13 oct. 1982
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Fixed & floating charge on undertaking and all property and assets present and future including book debts & other debts & uncalled capital.
    Personnes ayant droit
    • Midland Bank PLC
    Transactions
    • 13 oct. 1982Enregistrement d'une charge

    Source de données

    • Companies House du Royaume-Uni
      Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers.
    • Licence: CC0