INORGANIC PIGMENTS LIMITED
Vue d'ensemble
| Nom de la société | INORGANIC PIGMENTS LIMITED |
|---|---|
| Statut de la société | Active |
| Forme juridique | Société à responsabilité limitée |
| Numéro de société | 00688762 |
| Juridiction | Angleterre/Pays de Galles |
| Date de création |
Résumé
| A des PSCs super sécurisés | Non |
|---|---|
| A des charges | Non |
| A un historique d'insolvabilité | Non |
| Le siège social est contesté | Non |
Où se situe INORGANIC PIGMENTS LIMITED ?
| Adresse du siège social | Oxerra Uk Limited Liverpool Road East Kidsgrove ST7 3AA Stoke-On-Trent Staffordshire England |
|---|---|
| Adresse du siège social non livrable | Non |
Quels sont les derniers comptes de INORGANIC PIGMENTS LIMITED ?
| En retard | Non |
|---|---|
| Prochains comptes | |
| Fin de la prochaine période comptable le | 31 déc. 2025 |
| Date d'échéance des prochains comptes | 30 sept. 2026 |
| Derniers comptes | |
| Derniers comptes arrêtés au | 31 déc. 2024 |
Quel est le statut de la dernière déclaration de confirmation pour INORGANIC PIGMENTS LIMITED ?
| Dernière déclaration de confirmation établie jusqu'au | 24 janv. 2027 |
|---|---|
| Date d'échéance de la prochaine déclaration de confirmation | 07 févr. 2027 |
| Dernière déclaration de confirmation | |
| Prochaine déclaration de confirmation établie jusqu'au | 24 janv. 2026 |
| En retard | Non |
Quels sont les derniers dépôts pour INORGANIC PIGMENTS LIMITED ?
| Date | Description | Document | Type | |
|---|---|---|---|---|
Déclaration de confirmation établie le 24 janv. 2026 avec mises à jour | 4 pages | CS01 | ||
Comptes pour une société dormante établis au 31 déc. 2024 | 4 pages | AA | ||
Modification des coordonnées de l'administrateur Mr Kwan Yau Yu le 12 mars 2025 | 2 pages | CH01 | ||
Modification des coordonnées de l'administrateur Mr Kwan Ping David Yu le 12 mars 2025 | 2 pages | CH01 | ||
Déclaration de confirmation établie le 24 janv. 2025 avec mises à jour | 4 pages | CS01 | ||
Comptes de micro-entité établis au 31 déc. 2023 | 4 pages | AA | ||
Comptes de filiale exemptée d'audit établis au 31 déc. 2022 | 16 pages | AA | ||
legacy | 262 pages | PARENT_ACC | ||
legacy | 3 pages | GUARANTEE2 | ||
legacy | 1 pages | AGREEMENT2 | ||
Déclaration de confirmation établie le 24 janv. 2024 avec mises à jour | 5 pages | CS01 | ||
L'adresse d'inspection du registre a été modifiée de C/O Womble Bond Dickinson (Uk) Llp the Spark Draymans Way, Newcastle Helix Newcastle upon Tyne NE4 5DE United Kingdom à Liverpool Road East Kidsgrove Stoke-on-Trent Staffordshire ST7 3AA | 1 pages | AD02 | ||
Déclaration des objets de la société | 2 pages | CC04 | ||
Déclaration des objets de la société | 2 pages | CC04 | ||
Changement d'adresse du siège social de Liverpool Road East Kidsgrove Stoke-on-Trent Staffordshire ST7 3AA England à Oxerra Uk Limited Liverpool Road East Kidsgrove Stoke-on-Trent Staffordshire ST7 3AA le 15 juin 2023 | 1 pages | AD01 | ||
Modification des détails de Creambay Limited en tant que personne disposant d'un contrôle significatif le 31 mars 2023 | 2 pages | PSC05 | ||
Cessation de la nomination de Richard Justin James Phillipson en tant que directeur le 31 mars 2023 | 1 pages | TM01 | ||
Cessation de la nomination de Richard Justin James Phillipson en tant que secrétaire le 31 mars 2023 | 1 pages | TM02 | ||
Cessation de la nomination de Bertrand Maurice Andre Defoort en tant que directeur le 31 mars 2023 | 1 pages | TM01 | ||
Cessation de la nomination de John Jeffrey Pehrson en tant que directeur le 31 mars 2023 | 1 pages | TM01 | ||
Cessation de la nomination de Kurt David Ogden en tant que directeur le 31 mars 2023 | 1 pages | TM01 | ||
Nomination de Mr Timothy Michael John Southgate en tant qu'administrateur le 31 mars 2023 | 2 pages | AP01 | ||
Nomination de Mr Kwan Ping David Yu en tant qu'administrateur le 31 mars 2023 | 2 pages | AP01 | ||
Nomination de Mr Timothy Michael John Southgate en tant que secrétaire le 31 mars 2023 | 2 pages | AP03 | ||
Nomination de Mr Kwan Yau Yu en tant qu'administrateur le 31 mars 2023 | 2 pages | AP01 | ||
Qui sont les dirigeants de INORGANIC PIGMENTS LIMITED ?
| Nom | Nommé le | Date de démission | Rôle | Adresse | Identification de la société | Pays de résidence | Nationalité | Date de naissance | Profession | Numéro | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SOUTHGATE, Timothy Michael John | Secrétaire | Kidsgrove ST7 3AA Stoke-On-Trent Liverpool Road East Staffordshire England | 307770910001 | |||||||||||
| SOUTHGATE, Timothy Michael John | Administrateur | Kidsgrove ST7 3AA Stoke-On-Trent Liverpool Road East Staffordshire England | United Kingdom | British | 248364230001 | |||||||||
| YU, Kwan Ping David | Administrateur | Kidsgrove ST7 3AA Stoke-On-Trent Liverpool Road East Staffordshire England | Hong Kong | British | 307770930002 | |||||||||
| YU, Kwan Yau | Administrateur | Kidsgrove ST7 3AA Stoke-On-Trent Liverpool Road East Staffordshire England | Hong Kong | British | 307770920002 | |||||||||
| BEASLEY, Christopher Ernest | Secrétaire | 213a Archway Road Highgate N6 5BN London | British | 513720003 | ||||||||||
| PHILLIPSON, Richard Justin James | Secrétaire | Kidsgrove ST7 3AA Stoke-On-Trent Liverpool Road East Staffordshire England | 191478180001 | |||||||||||
| SMITH, Nicholas Handran | Secrétaire | Flat 5 24 Warrington Crescent W9 1EL London | Australian | 50914130002 | ||||||||||
| WHALLEY, Amanda | Secrétaire | 12 Merchant Court 61 Wapping Wall Wapping E1W 3SD London | British | 124348320001 | ||||||||||
| CLIFFORD CHANCE SECRETARIES LIMITED | Secrétaire | 10 Upper Bank Street E14 5JJ London | 38508390004 | |||||||||||
| TMF CORPORATE ADMINISTRATION SERVICES LIMITED | Secrétaire | 6 St Andrew Street EC4A 3AE London 5th Floor England |
| 140723560001 | ||||||||||
| ABRUNZO, Donna Marie | Administrateur | 55 Baird Road FOREIGN Englishtown New Jersey 07726 United States | American | 74452290001 | ||||||||||
| BEASLEY, Christopher Ernest | Administrateur | 213a Archway Road Highgate N6 5BN London | British | 513720003 | ||||||||||
| BOLLAND, John Clive | Administrateur | Laburnam Cottage 28 Agden Park Lane WA13 0TS Lymm Cheshire | British | 2794670001 | ||||||||||
| BRIAN, Patrick Raymond | Administrateur | Saltersford Cottage Saltersford Lane ST10 4AU Alton Staffordshire | England | British | 174760980001 | |||||||||
| BROWN, John Allan | Administrateur | 37 Observatory Road SW14 7QB London | England | British | 45956440002 | |||||||||
| DEFOORT, Bertrand Maurice Andre | Administrateur | Kidsgrove ST7 3AA Stoke-On-Trent Liverpool Road East Staffordshire England | United Kingdom | French | 300717170001 | |||||||||
| DIXON, Michael Christopher | Administrateur | Hanzard Drive Wynyard Park TS22 5FD Stockton On Tees Titanium House | England | British | 57794200002 | |||||||||
| HOUGHTON, Richard Charles | Administrateur | 12 Paddock Close Castle Donington DE74 2JW Derby | British | 126001380001 | ||||||||||
| IBBOTSON, Stephen Duncan Julian, M | Administrateur | Hanzard Drive Wynyard Park TS22 5FD Stockton On Tees Titanium House | England | British | 256614360001 | |||||||||
| LAW, John Derek | Administrateur | 44 Camlet Way AL3 4TL St Albans Hertfordshire | British | 513710002 | ||||||||||
| LETMAN, George Edward | Administrateur | 11 Saint Mellion Close Mickleover DE3 5YL Derby Derbyshire | British | 70052610001 | ||||||||||
| MASON, John Martin | Administrateur | Finchwood Wood Lane, Aspley Guise MK17 8EL Milton Keynes | British | 108947690001 | ||||||||||
| NIXON, Paul Andrew | Administrateur | Diamond Avenue Kidsgrove ST7 4XZ Stoke-On-Trent 7 Staffordshire | England | British | 133429340001 | |||||||||
| OGDEN, Kurt David | Administrateur | Kidsgrove ST7 3AA Stoke-On-Trent Liverpool Road East Staffordshire England | United Kingdom | American | 215432750002 | |||||||||
| PEHRSON, John Jeffrey | Administrateur | Kidsgrove ST7 3AA Stoke-On-Trent Liverpool Road East Staffordshire England | United Kingdom | American | 235327380001 | |||||||||
| PEMBERTON, Keith Stuart | Administrateur | 12 Greenfield Way Cuddington CW8 2YH Northwich Cheshire | British | 28465670001 | ||||||||||
| PHILLIPSON, Richard Justin James | Administrateur | Kidsgrove ST7 3AA Stoke-On-Trent Liverpool Road East Staffordshire England | Singapore | British | 191543710001 | |||||||||
| RAPPAPORT, Ronald Lee | Administrateur | 9604 Sotweed Drive Potomac Maryland 20854 Usa | American | 85162230001 | ||||||||||
| RIORDAN, Thomas James | Administrateur | 522 Waterview Place New Hope Pennyslyvania 18938 United States | United States | American | 73559050002 | |||||||||
| ROSS, Andrew Martin | Administrateur | Corey Place Nw DC 20016 Washington 3714 Usa | United States | Us Citizen | 65632080004 | |||||||||
| SCULL, Andrew James | Administrateur | 2 The Granary Brickwall Farm Kiln Lane Clophill MK45 4DA Bedford Bedfordshire | British | 53961740001 | ||||||||||
| SMITH, Nicholas Handran | Administrateur | Flat 5 24 Warrington Crescent W9 1EL London | Australian | 50914130002 | ||||||||||
| STOLLE, Russell Robert | Administrateur | Woodloch Forest Drive TX 77380 The Woodlands 10003 Texas United States | United States | American | 215432740001 | |||||||||
| TURNER, Simon | Administrateur | Hanzard Drive Wynyard Park TS22 5FD Stockton On Tees Titanium House | United Kingdom | British | 215432710001 | |||||||||
| TWENTYMAN, Judith | Administrateur | 17 Theberton Street N1 0QY London | British | 59204580002 |
Qui sont les personnes ayant un contrôle significatif sur INORGANIC PIGMENTS LIMITED ?
| Nom | Notifié le | Adresse | Cessé | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Creambay Limited | 29 juin 2016 | Kidsgrove ST7 3AA Stoke-On-Trent Liverpool Road East Staffordshire England | Non | ||||||||||
| |||||||||||||
Nature du contrôle
| |||||||||||||
Source de données
- Companies House du Royaume-Uni
Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers. - Licence: CC0