NORFOLK SPRING LIMITED

  • Vue d'ensemble
  • Résumé
  • Objet social
  • Adresse
  • Dénominations sociales précédentes
  • Comptes
  • Dépôts
  • Dirigeants
  • Charges
  • Insolvabilité
  • Source de données
  • Vue d'ensemble

    Nom de la sociétéNORFOLK SPRING LIMITED
    Statut de la sociétéDissoute
    Forme juridiqueSociété à responsabilité limitée
    Numéro de société 00694351
    JuridictionAngleterre/Pays de Galles
    Date de création
    Date de cessation d'activité

    Résumé

    A des PSCs super sécurisésNon
    A des chargesOui
    A un historique d'insolvabilitéOui
    Le siège social est contestéNon

    Quel est l'objet de NORFOLK SPRING LIMITED ?

    • Activités des sièges sociaux (70100) / Activités spécialisées, scientifiques et techniques

    Où se situe NORFOLK SPRING LIMITED ?

    Adresse du siège social
    Four
    Brindleyplace
    B1 2HZ Birmingham
    West Midlands
    Adresse du siège social non livrableNon

    Quels étaient les noms précédents de NORFOLK SPRING LIMITED ?

    Dénominations sociales précédentes
    Nom de la sociétéDeJusqu'au
    MATTHEWS TURKEY BREEDING FARMS LIMITED02 juin 196102 juin 1961

    Quels sont les derniers comptes de NORFOLK SPRING LIMITED ?

    Derniers comptes
    Derniers comptes arrêtés au28 juin 2015

    Quels sont les derniers dépôts pour NORFOLK SPRING LIMITED ?

    Dépôts
    DateDescriptionDocumentType

    Gazette finale dissoute à la suite d'une liquidation

    1 pagesGAZ2

    Avis de transition de l'administration à la dissolution

    24 pagesAM23

    Cessation de la nomination de Zaliha Williamson en tant que directeur le 30 juin 2017

    1 pagesTM01

    Cessation de la nomination de Robert Burnett en tant que directeur le 30 juin 2017

    1 pagesTM01

    Rapport d'avancement de l'administrateur jusqu'à 19 mars 2017

    20 pages2.24B

    Déclaration des affaires avec le formulaire 2.14B

    5 pages2.16B

    Avis d'approbation réputée des propositions

    42 pagesF2.18

    Déclaration de la proposition de l'administrateur

    44 pages2.17B

    Changement d'adresse du siège social de Four Brindley Place Birmingham West Midlands B1 2HZ à Four Brindleyplace Birmingham West Midlands B1 2HZ le 04 oct. 2016

    2 pagesAD01

    Changement d'adresse du siège social de Great Witchingham Hall Norwich Norfolk NR9 5QD à Four Brindley Place Birmingham West Midlands B1 2HZ le 04 oct. 2016

    2 pagesAD01

    Nomination d'un administrateur

    1 pages2.12B

    Nomination de Mr Alan Rae Dalziel Jamieson en tant qu'administrateur le 18 sept. 2016

    2 pagesAP01

    Cessation de la nomination de Yvonne Catherine Mary Goldingham en tant que secrétaire le 18 août 2016

    1 pagesTM02

    Déclaration annuelle jusqu'au 24 mai 2016 avec liste complète des actionnaires

    4 pagesAR01
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    capital20 juin 2016

    État du capital au 20 juin 2016

    • Capital: GBP 8,822,866
    SH01

    Période comptable actuelle prolongée du 30 juin 2016 au 31 déc. 2016

    1 pagesAA01

    Cessation de la nomination de Yvonne Catherine Mary Goldingham en tant que directeur le 12 mai 2016

    1 pagesTM01

    Cessation de la nomination de David John Joll en tant que directeur le 06 avr. 2016

    1 pagesTM01

    Comptes pour une société dormante établis au 28 juin 2015

    2 pagesAA

    Inscription de la charge 006943510008, créée le 28 août 2015

    81 pagesMR01

    Déclaration annuelle jusqu'au 24 mai 2015 avec liste complète des actionnaires

    5 pagesAR01
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    capital17 juin 2015

    État du capital au 17 juin 2015

    • Capital: GBP 8,822,866
    SH01

    Comptes pour une société dormante établis au 29 juin 2014

    2 pagesAA

    Nomination de Mr Robert Burnett en tant qu'administrateur

    2 pagesAP01

    Déclaration annuelle jusqu'au 24 mai 2014 avec liste complète des actionnaires

    4 pagesAR01
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    capital05 juin 2014

    État du capital au 05 juin 2014

    • Capital: GBP 8,822,866
    SH01

    Nomination de Mrs Zaliha Williamson en tant qu'administrateur

    2 pagesAP01

    Cessation de la nomination de Andrew Simpson en tant que directeur

    1 pagesTM01

    Qui sont les dirigeants de NORFOLK SPRING LIMITED ?

    Dirigeants
    NomNommé leDate de démissionRôleAdresseIdentification de la sociétéPays de résidenceNationalitéDate de naissanceProfessionNuméro
    JAMIESON, Alan Rae Dalziel
    Great Witchingham
    NR9 5QD Norwich
    Great Witchingham Hall
    England
    Administrateur
    Great Witchingham
    NR9 5QD Norwich
    Great Witchingham Hall
    England
    United KingdomBritishCompany Director31138330004
    BROWN, John Granger
    Rose Cottage
    32 West End Old Costessey
    NR8 5AG Norwich
    Norfolk
    Secrétaire
    Rose Cottage
    32 West End Old Costessey
    NR8 5AG Norwich
    Norfolk
    British11486660001
    GOLDINGHAM, Yvonne Catherine Mary
    Great Witchingham Hall
    Norwich
    NR9 5QD Norfolk
    Secrétaire
    Great Witchingham Hall
    Norwich
    NR9 5QD Norfolk
    170475300001
    REGER, David Michael
    Great Witchingham Hall
    Norwich
    NR9 5QD Norfolk
    Secrétaire
    Great Witchingham Hall
    Norwich
    NR9 5QD Norfolk
    BritishCompany Secretary151343430001
    BARTRAM, Noel Frederick
    Great Witchingham Hall
    Norwich
    NR9 5QD Norfolk
    Administrateur
    Great Witchingham Hall
    Norwich
    NR9 5QD Norfolk
    EnglandBritishDirector37442010003
    BROWN, John Granger
    Rose Cottage
    32 West End Old Costessey
    NR8 5AG Norwich
    Norfolk
    Administrateur
    Rose Cottage
    32 West End Old Costessey
    NR8 5AG Norwich
    Norfolk
    United KingdomBritishChartered Accountant11486660001
    BURNETT, Robert
    Brindleyplace
    B1 2HZ Birmingham
    Four
    West Midlands
    Administrateur
    Brindleyplace
    B1 2HZ Birmingham
    Four
    West Midlands
    ScotlandBritishGroup Ceo86190250002
    GOLDINGHAM, Yvonne Catherine Mary
    Great Witchingham Hall
    Norwich
    NR9 5QD Norfolk
    Administrateur
    Great Witchingham Hall
    Norwich
    NR9 5QD Norfolk
    United KingdomBritishDirector170465830001
    HARRISON, Neil Charles
    Bramley House
    The Loke Cringleford
    NR4 6XA Norwich
    Norfolk
    Administrateur
    Bramley House
    The Loke Cringleford
    NR4 6XA Norwich
    Norfolk
    United KingdomBritishAccountant111081410001
    JOLL, David John
    Great Witchingham Hall
    Norwich
    NR9 5QD Norfolk
    Administrateur
    Great Witchingham Hall
    Norwich
    NR9 5QD Norfolk
    United KingdomBritishDirector178372710001
    JOLL, David John
    Irmingland Hall
    Corpusty
    NR11 6QF Holt
    Norfolk
    Administrateur
    Irmingland Hall
    Corpusty
    NR11 6QF Holt
    Norfolk
    United KingdomBritishManaging Director178372710001
    MATTHEWS, Bernard Trevor
    Great Witchingham Hall
    NR9 5QD Norwich
    Norfolk
    Administrateur
    Great Witchingham Hall
    NR9 5QD Norwich
    Norfolk
    United KingdomBritishCompany Director10918210001
    REGER, David Michael
    Great Witchingham Hall
    Norwich
    NR9 5QD Norfolk
    Administrateur
    Great Witchingham Hall
    Norwich
    NR9 5QD Norfolk
    EnglandBritishCompany Secretary151343430001
    SIMPSON, Andrew John
    Great Witchingham Hall
    Norwich
    NR9 5QD Norfolk
    Administrateur
    Great Witchingham Hall
    Norwich
    NR9 5QD Norfolk
    EnglandBritishDirector105165150001
    WILLIAMSON, Zaliha
    Brindleyplace
    B1 2HZ Birmingham
    Four
    West Midlands
    Administrateur
    Brindleyplace
    B1 2HZ Birmingham
    Four
    West Midlands
    EnglandBritishDirector323983980001

    NORFOLK SPRING LIMITED a-t-elle des charges ?

    Charges
    ClassificationDatesStatutDétails
    A registered charge
    Créé le 28 août 2015
    Livré le 03 sept. 2015
    En cours
    Brève description
    As more particularly described in clause 3 of the debenture, a debenture creating fixed and floating charges over all the assets and undertakings (present and future) of norfolk spring limited.
    La charge flottante couvre tout: Oui
    Contient une promesse négative: Oui
    Contient une charge flottante: Oui
    Contient une charge fixe: Oui
    Personnes ayant droit
    • Rutland Partners LLP as Security Trustee
    Transactions
    • 03 sept. 2015Enregistrement d'une charge (MR01)
    A registered charge
    Créé le 30 août 2013
    Livré le 05 sept. 2013
    En cours
    Brève description
    As more particularly described in clause 3 of the debenture, a debenture taking fixed and floating charges over all the assets and undertaking (present and future) of norfolk spring limited.. Notification of addition to or amendment of charge.
    La charge flottante couvre tout: Oui
    Contient une charge flottante: Oui
    Contient une charge fixe: Oui
    Personnes ayant droit
    • Rutland Partners LLP as Security Trustee
    Transactions
    • 05 sept. 2013Enregistrement d'une charge (MR01)
    Deed of amendment and accession
    Créé le 20 janv. 2011
    Livré le 03 févr. 2011
    En cours
    Montant garanti
    All monies due or to become due up to a liability of £12,500,000 from the company to bernard matthews pensions fund
    Brèves mentions
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    Personnes ayant droit
    • Burdale Financial Limited
    Transactions
    • 03 févr. 2011Enregistrement d'une charge (MG01)
    Deed of debenture
    Créé le 11 juin 2007
    Livré le 21 juin 2007
    En cours
    Montant garanti
    The first ranking secured liabilities and the second ranking secured liabilities under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    For details of property charged please R. fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Burdale Financial Limited
    Transactions
    • 21 juin 2007Enregistrement d'une charge (395)
    Agreement and deed of pledge
    Créé le 08 déc. 2006
    Livré le 20 déc. 2006
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from any obligor or by some other person to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    The present and future shares and the related assets. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Barclays Bank PLC
    Transactions
    • 20 déc. 2006Enregistrement d'une charge (395)
    • 26 juin 2007Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Debenture
    Créé le 05 déc. 2006
    Livré le 15 déc. 2006
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from any chargor to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • De Lage Landen Ireland Company
    Transactions
    • 15 déc. 2006Enregistrement d'une charge (395)
    • 26 juin 2007Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Security agreement
    Créé le 05 déc. 2006
    Livré le 08 déc. 2006
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from any chargor to any secured creditor on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Barclays Bank PLC (In Its Capacity as Security Agent)
    Transactions
    • 08 déc. 2006Enregistrement d'une charge (395)
    • 26 juin 2007Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Deed of pledge of registered shares
    Créé le 10 avr. 2001
    Livré le 19 avr. 2001
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee pursuant to the side letter (as defined) as joint and several creditor of each and every obligation of the borrower towards each of the finance parties (as defined) under the facility agreement (as defined)
    Brèves mentions
    A first priority right of pledge on the shares and all rights thereon. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Hsbc Investment Bank PLC
    Transactions
    • 19 avr. 2001Enregistrement d'une charge (395)
    • 23 mai 2003Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)

    NORFOLK SPRING LIMITED a-t-elle des procédures d'insolvabilité ?

    Numéro de dossierDatesTypePraticiensAutre
    1
    DateType
    20 sept. 2016Administration started
    30 oct. 2017Administration ended
    In administration
    NomRôleAdresseNommé leCessé le
    Paul James Meadows
    4 Brindley Place
    B1 2HZ Birmingham
    practitioner
    4 Brindley Place
    B1 2HZ Birmingham
    Richard Michael Hawes
    5 Callaghan Square
    CF10 5BT Cardiff
    practitioner
    5 Callaghan Square
    CF10 5BT Cardiff
    Daniel Francis Butters
    1 City Square
    LS1 2AL Leeds
    West Yorkshire
    practitioner
    1 City Square
    LS1 2AL Leeds
    West Yorkshire

    Source de données

    • Companies House du Royaume-Uni
      Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers.
    • Licence: CC0