NORFOLK SPRING LIMITED
Vue d'ensemble
Nom de la société | NORFOLK SPRING LIMITED |
---|---|
Statut de la société | Dissoute |
Forme juridique | Société à responsabilité limitée |
Numéro de société | 00694351 |
Juridiction | Angleterre/Pays de Galles |
Date de création | |
Date de cessation d'activité |
Résumé
A des PSCs super sécurisés | Non |
---|---|
A des charges | Oui |
A un historique d'insolvabilité | Oui |
Le siège social est contesté | Non |
Où se situe NORFOLK SPRING LIMITED ?
Adresse du siège social | Four Brindleyplace B1 2HZ Birmingham West Midlands |
---|---|
Adresse du siège social non livrable | Non |
Quels sont les derniers comptes de NORFOLK SPRING LIMITED ?
Derniers comptes | |
---|---|
Derniers comptes arrêtés au | 28 juin 2015 |
Quels sont les derniers dépôts pour NORFOLK SPRING LIMITED ?
Date | Description | Document | Type | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gazette finale dissoute à la suite d'une liquidation | 1 pages | GAZ2 | ||||||||||
Avis de transition de l'administration à la dissolution | 24 pages | AM23 | ||||||||||
Cessation de la nomination de Zaliha Williamson en tant que directeur le 30 juin 2017 | 1 pages | TM01 | ||||||||||
Cessation de la nomination de Robert Burnett en tant que directeur le 30 juin 2017 | 1 pages | TM01 | ||||||||||
Rapport d'avancement de l'administrateur jusqu'à 19 mars 2017 | 20 pages | 2.24B | ||||||||||
Déclaration des affaires avec le formulaire 2.14B | 5 pages | 2.16B | ||||||||||
Avis d'approbation réputée des propositions | 42 pages | F2.18 | ||||||||||
Déclaration de la proposition de l'administrateur | 44 pages | 2.17B | ||||||||||
Changement d'adresse du siège social de Four Brindley Place Birmingham West Midlands B1 2HZ à Four Brindleyplace Birmingham West Midlands B1 2HZ le 04 oct. 2016 | 2 pages | AD01 | ||||||||||
Changement d'adresse du siège social de Great Witchingham Hall Norwich Norfolk NR9 5QD à Four Brindley Place Birmingham West Midlands B1 2HZ le 04 oct. 2016 | 2 pages | AD01 | ||||||||||
Nomination d'un administrateur | 1 pages | 2.12B | ||||||||||
Nomination de Mr Alan Rae Dalziel Jamieson en tant qu'administrateur le 18 sept. 2016 | 2 pages | AP01 | ||||||||||
Cessation de la nomination de Yvonne Catherine Mary Goldingham en tant que secrétaire le 18 août 2016 | 1 pages | TM02 | ||||||||||
Déclaration annuelle jusqu'au 24 mai 2016 avec liste complète des actionnaires | 4 pages | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Période comptable actuelle prolongée du 30 juin 2016 au 31 déc. 2016 | 1 pages | AA01 | ||||||||||
Cessation de la nomination de Yvonne Catherine Mary Goldingham en tant que directeur le 12 mai 2016 | 1 pages | TM01 | ||||||||||
Cessation de la nomination de David John Joll en tant que directeur le 06 avr. 2016 | 1 pages | TM01 | ||||||||||
Comptes pour une société dormante établis au 28 juin 2015 | 2 pages | AA | ||||||||||
Inscription de la charge 006943510008, créée le 28 août 2015 | 81 pages | MR01 | ||||||||||
Déclaration annuelle jusqu'au 24 mai 2015 avec liste complète des actionnaires | 5 pages | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Comptes pour une société dormante établis au 29 juin 2014 | 2 pages | AA | ||||||||||
Nomination de Mr Robert Burnett en tant qu'administrateur | 2 pages | AP01 | ||||||||||
Déclaration annuelle jusqu'au 24 mai 2014 avec liste complète des actionnaires | 4 pages | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Nomination de Mrs Zaliha Williamson en tant qu'administrateur | 2 pages | AP01 | ||||||||||
Cessation de la nomination de Andrew Simpson en tant que directeur | 1 pages | TM01 | ||||||||||
Qui sont les dirigeants de NORFOLK SPRING LIMITED ?
Nom | Nommé le | Date de démission | Rôle | Adresse | Identification de la société | Pays de résidence | Nationalité | Date de naissance | Profession | Numéro |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JAMIESON, Alan Rae Dalziel | Administrateur | Great Witchingham NR9 5QD Norwich Great Witchingham Hall England | United Kingdom | British | Company Director | 31138330004 | ||||
BROWN, John Granger | Secrétaire | Rose Cottage 32 West End Old Costessey NR8 5AG Norwich Norfolk | British | 11486660001 | ||||||
GOLDINGHAM, Yvonne Catherine Mary | Secrétaire | Great Witchingham Hall Norwich NR9 5QD Norfolk | 170475300001 | |||||||
REGER, David Michael | Secrétaire | Great Witchingham Hall Norwich NR9 5QD Norfolk | British | Company Secretary | 151343430001 | |||||
BARTRAM, Noel Frederick | Administrateur | Great Witchingham Hall Norwich NR9 5QD Norfolk | England | British | Director | 37442010003 | ||||
BROWN, John Granger | Administrateur | Rose Cottage 32 West End Old Costessey NR8 5AG Norwich Norfolk | United Kingdom | British | Chartered Accountant | 11486660001 | ||||
BURNETT, Robert | Administrateur | Brindleyplace B1 2HZ Birmingham Four West Midlands | Scotland | British | Group Ceo | 86190250002 | ||||
GOLDINGHAM, Yvonne Catherine Mary | Administrateur | Great Witchingham Hall Norwich NR9 5QD Norfolk | United Kingdom | British | Director | 170465830001 | ||||
HARRISON, Neil Charles | Administrateur | Bramley House The Loke Cringleford NR4 6XA Norwich Norfolk | United Kingdom | British | Accountant | 111081410001 | ||||
JOLL, David John | Administrateur | Great Witchingham Hall Norwich NR9 5QD Norfolk | United Kingdom | British | Director | 178372710001 | ||||
JOLL, David John | Administrateur | Irmingland Hall Corpusty NR11 6QF Holt Norfolk | United Kingdom | British | Managing Director | 178372710001 | ||||
MATTHEWS, Bernard Trevor | Administrateur | Great Witchingham Hall NR9 5QD Norwich Norfolk | United Kingdom | British | Company Director | 10918210001 | ||||
REGER, David Michael | Administrateur | Great Witchingham Hall Norwich NR9 5QD Norfolk | England | British | Company Secretary | 151343430001 | ||||
SIMPSON, Andrew John | Administrateur | Great Witchingham Hall Norwich NR9 5QD Norfolk | England | British | Director | 105165150001 | ||||
WILLIAMSON, Zaliha | Administrateur | Brindleyplace B1 2HZ Birmingham Four West Midlands | England | British | Director | 323983980001 |
NORFOLK SPRING LIMITED a-t-elle des charges ?
Classification | Dates | Statut | Détails | |
---|---|---|---|---|
A registered charge | Créé le 28 août 2015 Livré le 03 sept. 2015 | En cours | ||
Brève description As more particularly described in clause 3 of the debenture, a debenture creating fixed and floating charges over all the assets and undertakings (present and future) of norfolk spring limited. La charge flottante couvre tout: Oui Contient une promesse négative: Oui Contient une charge flottante: Oui Contient une charge fixe: Oui | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
A registered charge | Créé le 30 août 2013 Livré le 05 sept. 2013 | En cours | ||
Brève description As more particularly described in clause 3 of the debenture, a debenture taking fixed and floating charges over all the assets and undertaking (present and future) of norfolk spring limited.. Notification of addition to or amendment of charge. La charge flottante couvre tout: Oui Contient une charge flottante: Oui Contient une charge fixe: Oui | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
Deed of amendment and accession | Créé le 20 janv. 2011 Livré le 03 févr. 2011 | En cours | Montant garanti All monies due or to become due up to a liability of £12,500,000 from the company to bernard matthews pensions fund | |
Brèves mentions Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
Deed of debenture | Créé le 11 juin 2007 Livré le 21 juin 2007 | En cours | Montant garanti The first ranking secured liabilities and the second ranking secured liabilities under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Brèves mentions For details of property charged please R. fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
Agreement and deed of pledge | Créé le 08 déc. 2006 Livré le 20 déc. 2006 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from any obligor or by some other person to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Brèves mentions The present and future shares and the related assets. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
Debenture | Créé le 05 déc. 2006 Livré le 15 déc. 2006 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from any chargor to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Brèves mentions Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
Security agreement | Créé le 05 déc. 2006 Livré le 08 déc. 2006 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from any chargor to any secured creditor on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Brèves mentions Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
Deed of pledge of registered shares | Créé le 10 avr. 2001 Livré le 19 avr. 2001 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from the company to the chargee pursuant to the side letter (as defined) as joint and several creditor of each and every obligation of the borrower towards each of the finance parties (as defined) under the facility agreement (as defined) | |
Brèves mentions A first priority right of pledge on the shares and all rights thereon. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
|
NORFOLK SPRING LIMITED a-t-elle des procédures d'insolvabilité ?
Numéro de dossier | Dates | Type | Praticiens | Autre | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
| In administration |
|
Source de données
- Companies House du Royaume-Uni
Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers. - Licence: CC0