WATERLOO AIR MANAGEMENT PLC.

WATERLOO AIR MANAGEMENT PLC.

  • Vue d'ensemble
  • Résumé
  • Objet social
  • Adresse
  • Dénominations sociales précédentes
  • Comptes
  • Dépôts
  • Dirigeants
  • Charges
  • Insolvabilité
  • Source de données
  • Vue d'ensemble

    Nom de la sociétéWATERLOO AIR MANAGEMENT PLC.
    Statut de la sociétéDissoute
    Forme juridiqueSociété anonyme cotée en bourse
    Numéro de société 00697059
    JuridictionAngleterre/Pays de Galles
    Date de création
    Date de cessation d'activité

    Résumé

    A des PSCs super sécurisésNon
    A des chargesOui
    A un historique d'insolvabilitéOui
    Le siège social est contestéNon

    Quel est l'objet de WATERLOO AIR MANAGEMENT PLC. ?

    • (2923) /

    Où se situe WATERLOO AIR MANAGEMENT PLC. ?

    Adresse du siège social
    Devonshire House
    60 Goswell Road
    EC1M 7AD London
    Adresse du siège social non livrableNon

    Quels étaient les noms précédents de WATERLOO AIR MANAGEMENT PLC. ?

    Dénominations sociales précédentes
    Nom de la sociétéDeJusqu'au
    HUNTER INTERNATIONAL PLC26 juin 199526 juin 1995
    HUNTER AIR TECHNOLOGY PLC12 oct. 199312 oct. 1993
    WATERLOO AIR TECHNOLOGY LIMITED 04 sept. 198604 sept. 1986
    ALFRED A. CORRE & COMPANY LIMITED31 déc. 197631 déc. 1976
    WATERLOO GRILLE COMPANY LIMITED 30 juin 196130 juin 1961

    Quels sont les derniers comptes de WATERLOO AIR MANAGEMENT PLC. ?

    Derniers comptes
    Derniers comptes arrêtés au

    Quels sont les derniers dépôts pour WATERLOO AIR MANAGEMENT PLC. ?

    Dépôts
    DateDescriptionDocumentType

    Gazette finale dissoute à la suite d'une liquidation

    1 pagesGAZ2

    Avis de compte final avant dissolution

    1 pages4.43

    Résumé des recettes et paiements du récepteur jusqu'au 13 oct. 2009

    3 pages3.6

    legacy

    2 pagesLQ02

    Résumé des recettes et paiements du récepteur jusqu'au 28 sept. 2009

    2 pages3.6

    Résumé des recettes et paiements du récepteur jusqu'au 28 sept. 2008

    2 pages3.6

    Résumé des recettes et paiements du récepteur

    2 pages3.6

    Résumé des recettes et paiements du récepteur

    2 pages3.6

    legacy

    1 pages288b

    Résumé des recettes et paiements du récepteur

    2 pages3.6

    Résumé des recettes et paiements du récepteur

    3 pages3.6

    Avis de constitution du Comité de liquidation

    2 pages4.48

    legacy

    1 pages287

    Nomination d'un liquidateur

    1 pages4.31

    Ordonnance du tribunal pour liquider

    2 pagesCOCOMP

    Divers

    Form 3.2 - s/ment of affairs
    147 pagesMISC

    Rapport du séquestre administratif

    8 pages3.10

    legacy

    1 pages287

    legacy

    2 pages405(1)

    legacy

    3 pages395

    legacy

    1 pages288b

    Comptes annuels établis au 30 juin 2002

    22 pagesAA

    legacy

    1 pages288b

    legacy

    10 pages363s
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    annual-return21 janv. 2003

    legacy

    363(353)
    annual-return21 janv. 2003

    legacy

    363(190)

    legacy

    3 pages395

    Qui sont les dirigeants de WATERLOO AIR MANAGEMENT PLC. ?

    Dirigeants
    NomNommé leDate de démissionRôleAdresseIdentification de la sociétéPays de résidenceNationalitéDate de naissanceProfessionNuméro
    VAN ALPHEN, Ann Margaret Hunter
    31 Dunnock Road
    Manor Park Kennington
    TN25 4QJ Ashford
    Kent
    Secrétaire
    31 Dunnock Road
    Manor Park Kennington
    TN25 4QJ Ashford
    Kent
    British38558160003
    EDMONDSON, Richard Hunter
    Homefield
    Main Road Knockholt
    TN14 7LR Sevenoaks
    Kent
    Administrateur
    Homefield
    Main Road Knockholt
    TN14 7LR Sevenoaks
    Kent
    EnglandBritishEngineer6061920001
    EDMONDSON, Ronald Hunter
    Spring Lane
    Ightham
    TN15 9DR Sevenoaks
    The Tower
    Kent
    Administrateur
    Spring Lane
    Ightham
    TN15 9DR Sevenoaks
    The Tower
    Kent
    EnglandBritishChartered Accountant10824160003
    NUTLEY, Royston Charles
    Avondale Boxley Road
    Walderslade
    ME5 9JE Chatham
    Kent
    Administrateur
    Avondale Boxley Road
    Walderslade
    ME5 9JE Chatham
    Kent
    BritishDirector61417040001
    OSMANT, John Lloyd
    Farley Lodge
    Colliers Green
    TN17 2LS Cranbrook
    Kent
    Administrateur
    Farley Lodge
    Colliers Green
    TN17 2LS Cranbrook
    Kent
    BritishProduction Director74209510002
    PERKINS, Ian Lea
    4 Mays Cottages
    St Helens Lane East Farleigh
    ME15 0LA Maidstone
    Kent
    Administrateur
    4 Mays Cottages
    St Helens Lane East Farleigh
    ME15 0LA Maidstone
    Kent
    BritishFinance Director97287640001
    FAHY, John Martin
    Little Partridges Pinesfield Lane
    Trottiscliffe
    ME19 5EN West Malling
    Kent
    Secrétaire
    Little Partridges Pinesfield Lane
    Trottiscliffe
    ME19 5EN West Malling
    Kent
    IrishAccountant6061900001
    FAHY, John Martin
    Little Partridges Pinesfield Lane
    Trottiscliffe
    ME19 5EN West Malling
    Kent
    Secrétaire
    Little Partridges Pinesfield Lane
    Trottiscliffe
    ME19 5EN West Malling
    Kent
    IrishAccountant6061900001
    VAN ALPHEN, Ann Margaret Hunter
    Mannering Farmhouse
    Biddenden
    TN27 8BY Ashford
    Kent
    Secrétaire
    Mannering Farmhouse
    Biddenden
    TN27 8BY Ashford
    Kent
    British38558160001
    BAILEY, John Robert
    8 Crosier Court
    ME9 7AR Upchurch
    Kent
    Administrateur
    8 Crosier Court
    ME9 7AR Upchurch
    Kent
    BritishCommercial Director76851710001
    COOKE, Gary
    44 Grazeley Road
    Three Mile Cross
    RG7 1BJ Reading
    Berkshire
    Administrateur
    44 Grazeley Road
    Three Mile Cross
    RG7 1BJ Reading
    Berkshire
    BritishDirector61416720001
    CURRY, Martin James
    48 Wellesley Road
    Wanstead
    E11 2HF London
    Administrateur
    48 Wellesley Road
    Wanstead
    E11 2HF London
    EnglandBritishDirector15510130001
    EDMONDSON, Raymond Hunter
    New Place
    Framfield
    TN22 3RH Uckfield
    Sussex
    Administrateur
    New Place
    Framfield
    TN22 3RH Uckfield
    Sussex
    EnglandBritishPlastics Engineer6061910001
    FAHY, John Martin
    Little Partridges Pinesfield Lane
    Trottiscliffe
    ME19 5EN West Malling
    Kent
    Administrateur
    Little Partridges Pinesfield Lane
    Trottiscliffe
    ME19 5EN West Malling
    Kent
    IrishCertified Accoutant6061900001
    HUGHES, Leonard John
    Moonraker 4 Longlands Glade
    BN14 9NR Worthing
    West Sussex
    Administrateur
    Moonraker 4 Longlands Glade
    BN14 9NR Worthing
    West Sussex
    BritishDirector6565140001
    LEECH, Keith
    Pippins
    Hareplains Road
    TN27 8LL Biddenden
    Kent
    Administrateur
    Pippins
    Hareplains Road
    TN27 8LL Biddenden
    Kent
    BritishDirector6494040001
    ROBINSON, Ronald Paul
    5 Hoads Wood Gardens
    Sandyhurst Green
    TN25 4QB Ashford
    Kent
    Administrateur
    5 Hoads Wood Gardens
    Sandyhurst Green
    TN25 4QB Ashford
    Kent
    BritishDirector61416920001
    YULE, Neil Peter
    4 Hayes Walk
    Kings Hill
    ME19 4HJ West Malling
    Kent
    Administrateur
    4 Hayes Walk
    Kings Hill
    ME19 4HJ West Malling
    Kent
    BritishDirector73726090002

    WATERLOO AIR MANAGEMENT PLC. a-t-elle des charges ?

    Charges
    ClassificationDatesStatutDétails
    Charge of deposit
    Créé le 08 sept. 2003
    Livré le 13 sept. 2003
    En cours
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    All deposits now and in the future credited to account designation NO39054411 with the bank and any deposit or account of any other currency description or designation which derives in whole or in part from such deposit or account.
    Personnes ayant droit
    • National Westminster Bank PLC
    Transactions
    • 13 sept. 2003Enregistrement d'une charge (395)
    All assets debenture
    Créé le 20 sept. 2002
    Livré le 25 sept. 2002
    En cours
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    All assets.
    Personnes ayant droit
    • Eurofactor (UK) Limited
    Transactions
    • 25 sept. 2002Enregistrement d'une charge (395)
    • 01 oct. 2003Nomination d'un administrateur ou d'un gestionnaire (405 (1))
    • 115 oct. 2009Avis de cessation d'exercer en tant qu'administrateur ou gestionnaire (LQ02)
      • Numéro de dossier 1
    Debenture
    Créé le 25 oct. 2001
    Livré le 27 oct. 2001
    En cours
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Venture Finance PLC
    Transactions
    • 27 oct. 2001Enregistrement d'une charge (395)
    Debenture deed
    Créé le 08 déc. 1999
    Livré le 09 déc. 1999
    En cours
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Venture Finance PLC
    Transactions
    • 09 déc. 1999Enregistrement d'une charge (395)
    Deposit deed
    Créé le 27 août 1999
    Livré le 02 sept. 1999
    En cours
    Montant garanti
    The obligations of the company (as tenant) to the bishop centre limited under a lease of even date and the deposit deed
    Brèves mentions
    The sum of £3,495 maintained in an interest earning account maintained at a clearing bank or building society together with the amount from time to time standing to the credit of such account including accrued interest not paid to the company.
    Personnes ayant droit
    • The Bishop Centre Limited
    Transactions
    • 02 sept. 1999Enregistrement d'une charge (395)
    Mortgage debenture
    Créé le 21 avr. 1998
    Livré le 05 mai 1998
    En cours
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    A specific equitable charge over all freehold and leasehold properties and/or the proceeds of sale thereof fixed and floating charges over undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts and the benefits of any licences.
    Personnes ayant droit
    • National Westminster Bank PLC
    Transactions
    • 05 mai 1998Enregistrement d'une charge (395)
    Mortgage debenture
    Créé le 22 déc. 1988
    Livré le 03 janv. 1989
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    A specific equitable charge over all freehold and leasehold properties and/or the proceeds of sale thereof fixed and floating charges over undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts and the benefits of any licences.
    Personnes ayant droit
    • National Westminster Bank PLC
    Transactions
    • 03 janv. 1989Enregistrement d'une charge
    • 01 oct. 1996Déclaration que tout ou partie de la propriété d'une charge flottante a été libérée (403b)
    • 05 déc. 1996Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Collateral debenture
    Créé le 08 juin 1988
    Livré le 14 juin 1988
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from hunter international limited to the chargee on any account whatsoever under the terms of the charge.
    Brèves mentions
    Stock-in-trade, work-in-progress prepayments, investments.. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personnes ayant droit
    • 3I PLC
    Transactions
    • 14 juin 1988Enregistrement d'une charge

    WATERLOO AIR MANAGEMENT PLC. a-t-elle des procédures d'insolvabilité ?

    Numéro de dossierDatesTypePraticiensAutre
    1
    DateType
    20 sept. 2002Instrument date
    Administrative receiver appointed
    NomRôleAdresseNommé leCessé le
    Anthony Murphy
    Bartlett House
    9-12 Basinghall Street
    EC2V 5NS London
    practitioner
    Bartlett House
    9-12 Basinghall Street
    EC2V 5NS London
    Stephen Robert Leslie Cork
    Smith & Williamson
    Bartlett House
    EC2V 5NS 9-12 Basinghall Street
    London
    practitioner
    Smith & Williamson
    Bartlett House
    EC2V 5NS 9-12 Basinghall Street
    London
    2
    DateType
    29 nov. 2012Conclusion of winding up
    01 déc. 2003Petition date
    28 janv. 2004Commencement of winding up
    25 août 2021Dissolved on
    Compulsory liquidation
    NomRôleAdresseNommé leCessé le
    Ian Robert
    Kingston Smith & Partners Llp
    Devonshire House
    EC1M 7AD 60 Goswell Road
    London
    practitioner
    Kingston Smith & Partners Llp
    Devonshire House
    EC1M 7AD 60 Goswell Road
    London
    The Official Receiver Or London
    21 Bloomsbury Street
    London
    WC1B 3SS
    practitioner
    21 Bloomsbury Street
    London
    WC1B 3SS
    Nicholas John Miller
    Kingston Smith & Partners Llp
    Devonshire House
    EC1M 7AD 60 Goswell Road
    London
    practitioner
    Kingston Smith & Partners Llp
    Devonshire House
    EC1M 7AD 60 Goswell Road
    London

    Source de données

    • Companies House du Royaume-Uni
      Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers.
    • Licence: CC0