INDALEX LIMITED
Vue d'ensemble
Nom de la société | INDALEX LIMITED |
---|---|
Statut de la société | Dissoute |
Forme juridique | Société à responsabilité limitée |
Numéro de société | 00698957 |
Juridiction | Angleterre/Pays de Galles |
Date de création | |
Date de cessation d'activité |
Résumé
A des PSCs super sécurisés | Non |
---|---|
A des charges | Oui |
A un historique d'insolvabilité | Non |
Le siège social est contesté | Non |
Où se situe INDALEX LIMITED ?
Adresse du siège social | c/o C/O SAPA BUILDING SYSTEMS LTD 5300 Severn Drive Tewkesbury Business Park GL20 8TX Tewkesbury Gloucestershire United Kingdom |
---|---|
Adresse du siège social non livrable | Non |
Quels sont les derniers comptes de INDALEX LIMITED ?
Derniers comptes | |
---|---|
Derniers comptes arrêtés au | 31 déc. 2009 |
Quels sont les derniers dépôts pour INDALEX LIMITED ?
Date | Description | Document | Type | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bulletin officiel final dissous par radiation d'office | 1 pages | GAZ2 | ||||||||||
Premier avis au Bulletin officiel pour la radiation d'office | 1 pages | GAZ1 | ||||||||||
Restauration par ordonnance du tribunal | 3 pages | AC92 | ||||||||||
Bulletin officiel final dissous par radiation volontaire | 1 pages | GAZ2(A) | ||||||||||
Changement d'adresse du siège social de * C/O Sapa Building Systems Unit 1 Alexandra Way, Ashchurch Tewkesbury Gloucestershire GL20 8NB* le 22 juin 2011 | 1 pages | AD01 | ||||||||||
Premier avis au Bulletin officiel pour la radiation volontaire | 1 pages | GAZ1(A) | ||||||||||
Demande de radiation de la société du registre du commerce | 3 pages | DS01 | ||||||||||
Déclaration annuelle jusqu'au 16 mars 2011 avec liste complète des actionnaires | 5 pages | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Comptes pour une société dormante établis au 31 déc. 2009 | 6 pages | AA | ||||||||||
Déclaration annuelle jusqu'au 16 mars 2010 avec liste complète des actionnaires | 5 pages | AR01 | ||||||||||
Modification des coordonnées de l'administrateur Mr Nigel Keith Sissons le 18 mars 2010 | 2 pages | CH01 | ||||||||||
Comptes pour une société dormante établis au 31 déc. 2008 | 6 pages | AA | ||||||||||
legacy | 3 pages | 363a | ||||||||||
Comptes pour une société dormante établis au 31 déc. 2007 | 6 pages | AA | ||||||||||
legacy | 3 pages | 363a | ||||||||||
Comptes pour une société dormante établis au 31 déc. 2006 | 6 pages | AA | ||||||||||
legacy | 7 pages | 363s | ||||||||||
Comptes pour une société dormante établis au 31 déc. 2005 | 6 pages | AA | ||||||||||
legacy | 7 pages | 363s | ||||||||||
Comptes pour une société dormante établis au 31 déc. 2004 | 6 pages | AA | ||||||||||
legacy | 7 pages | 363s | ||||||||||
| ||||||||||||
Comptes pour une société dormante établis au 31 déc. 2003 | 6 pages | AA | ||||||||||
legacy | 7 pages | 363s | ||||||||||
Comptes pour une société dormante établis au 31 déc. 2002 | 6 pages | AA | ||||||||||
legacy | 7 pages | 363s |
Qui sont les dirigeants de INDALEX LIMITED ?
Nom | Nommé le | Date de démission | Rôle | Adresse | Identification de la société | Pays de résidence | Nationalité | Date de naissance | Profession | Numéro |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DANIELS, Anthony Patrick | Secrétaire | Derwent 26 Sydenham Road GL52 6EA Cheltenham Gloucestershire | British | Business Area Controller | 24297480001 | |||||
DANIELS, Anthony Patrick | Administrateur | Derwent 26 Sydenham Road GL52 6EA Cheltenham Gloucestershire | England | British | Business Area Controller | 24297480001 | ||||
SISSONS, Nigel Keith | Administrateur | c/o C/O Sapa Building Systems Ltd Severn Drive Tewkesbury Business Park GL20 8TX Tewkesbury 5300 Gloucestershire United Kingdom | England | British | Managing Director | 80321870001 | ||||
DANIELS, Anthony Patrick | Secrétaire | Derwent 26 Sydenham Road GL52 6EA Cheltenham Gloucestershire | British | 24297480001 | ||||||
HARDING, Simon | Secrétaire | 1 Hillview Road GL52 5AD Cheltenham Gloucestershire | British | 51992810001 | ||||||
HEENAN, Duncan | Secrétaire | Dolphins House Boxers Lane PO38 2BH Niton Isle Of Wight | British | Chartered Accountant | 118536400001 | |||||
LIGHTOWLERS, John | Secrétaire | 3 Ribston Mews Stroud Road GL1 5EU Gloucester Gloucestershire | British | 111277770001 | ||||||
MEEUWISSEN-TRUE, Steven Michael | Secrétaire | 211 Prestbury Road GL52 3ES Cheltenham Gloucestershire | British | 61526840001 | ||||||
PARKER, Laurence | Secrétaire | Bramble Lodge 5 Vale Bank Arlingham GL2 7JT Gloucester | British | Manufacturing Director | 56038650001 | |||||
WILSON, Matthew Tennant | Secrétaire | 110 Charlton Lane GL53 9EA Cheltenham Gloucestershire | British | 6458060001 | ||||||
DEEKS, Andrew Gerald | Administrateur | 32 Henley Street B49 5QY Alcester Warwickshire | England | British | Company Director | 3779900001 | ||||
FORMAN, Christopher | Administrateur | 71 Montpellier Terrace GL50 1XA Cheltenham Gloucestershire | British | Company Director | 58933120001 | |||||
GREENSLADE, Robin Alastair | Administrateur | Avonscroft Dock Lane Bredon GL20 6LG Tewkesbury Gloucestershire | British | Company Director | 4565340001 | |||||
HEENAN, Duncan | Administrateur | Dolphins House Boxers Lane PO38 2BH Niton Isle Of Wight | England | British | Chartered Accountant | 118536400001 | ||||
HERRINGTON, Hugh Richard | Administrateur | Touchwood Grimms Hill HP16 9BG Great Missenden Buckinghamshire | United Kingdom | British | Company Director | 6360950001 | ||||
JOHANSSON, Mats Harald | Administrateur | 4 Paddocks View Long Eaton NG10 3QF Nottingham Nottinghamshire | Swedish | Manufacturing Director | 68575210001 | |||||
MEEUWISSEN-TRUE, Steven Michael | Administrateur | 211 Prestbury Road GL52 3ES Cheltenham Gloucestershire | United Kingdom | British | Finance Director | 61526840001 | ||||
MINES, Geoffrey | Administrateur | 1 Orchard Rise OX18 4SZ Burford Oxfordshire | British | Sales Director | 65989880002 | |||||
PARKER, Laurence | Administrateur | Bramble Lodge 5 Vale Bank Arlingham GL2 7JT Gloucester | England | British | Company Director | 56038650001 | ||||
PHILLIPS, Derek Edward | Administrateur | Nybrogatan FOREIGN 60 Tr.1 114 40 Stockholm Sweden | British | Company Director | 6458080002 | |||||
STUBBS, Timothy Rupert John | Administrateur | Bell House Bell Lane GL56 9ES Blockley Gloucestershire | British | Marketing Director | 60722060001 | |||||
TURNER, Brian Charles | Administrateur | Ravensworth Thirlestaine Road GL53 7AS Cheltenham Gloucestershire | British | Company Director | 5135500001 | |||||
WILSON, Matthew Tennant | Administrateur | 110 Charlton Lane GL53 9EA Cheltenham Gloucestershire | British | Company Director | 6458060001 |
INDALEX LIMITED a-t-elle des charges ?
Classification | Dates | Statut | Détails | |
---|---|---|---|---|
Deed of charge over credit balances | Créé le 14 sept. 1998 Livré le 02 oct. 1998 | En cours | Montant garanti All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brèves mentions Fixed charge over all the deposit(s) in and to the charged deposit contract with barclays bank PLC re;-indalex limited barclays treasury deposit dutch guilders deposit deal no;85232966. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
Deed of charge over credit balances | Créé le 14 sept. 1998 Livré le 02 oct. 1998 | En cours | Montant garanti All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brèves mentions Fixed charge over all deposit(s) in and to the charged deposit contract with barclays bank PLC re ;-indalex limited barclays treasury deposit deutche marks deposit deal no.85232966. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
Debenture | Créé le 04 mai 1994 Livré le 12 mai 1994 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due from the company to the chargee (as defined in the charge) on any account whatsoever | |
Brèves mentions Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
Single debenture | Créé le 04 mai 1994 Livré le 12 mai 1994 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brèves mentions Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
Debenture | Créé le 04 mai 1994 Livré le 06 mai 1994 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from the company to the chargee under or in respect of the guarantee or this debenture | |
Brèves mentions Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
|
Source de données
- Companies House du Royaume-Uni
Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers. - Licence: CC0