INDALEX LIMITED

  • Vue d'ensemble
  • Résumé
  • Objet social
  • Adresse
  • Comptes
  • Dépôts
  • Dirigeants
  • Charges
  • Source de données
  • Vue d'ensemble

    Nom de la sociétéINDALEX LIMITED
    Statut de la sociétéDissoute
    Forme juridiqueSociété à responsabilité limitée
    Numéro de société 00698957
    JuridictionAngleterre/Pays de Galles
    Date de création
    Date de cessation d'activité

    Résumé

    A des PSCs super sécurisésNon
    A des chargesOui
    A un historique d'insolvabilitéNon
    Le siège social est contestéNon

    Quel est l'objet de INDALEX LIMITED ?

    • (7499) /

    Où se situe INDALEX LIMITED ?

    Adresse du siège social
    c/o C/O SAPA BUILDING SYSTEMS LTD
    5300 Severn Drive
    Tewkesbury Business Park
    GL20 8TX Tewkesbury
    Gloucestershire
    United Kingdom
    Adresse du siège social non livrableNon

    Quels sont les derniers comptes de INDALEX LIMITED ?

    Derniers comptes
    Derniers comptes arrêtés au31 déc. 2009

    Quels sont les derniers dépôts pour INDALEX LIMITED ?

    Dépôts
    DateDescriptionDocumentType

    Bulletin officiel final dissous par radiation d'office

    1 pagesGAZ2

    Premier avis au Bulletin officiel pour la radiation d'office

    1 pagesGAZ1

    Restauration par ordonnance du tribunal

    3 pagesAC92

    Bulletin officiel final dissous par radiation volontaire

    1 pagesGAZ2(A)

    Changement d'adresse du siège social de * C/O Sapa Building Systems Unit 1 Alexandra Way, Ashchurch Tewkesbury Gloucestershire GL20 8NB* le 22 juin 2011

    1 pagesAD01

    Premier avis au Bulletin officiel pour la radiation volontaire

    1 pagesGAZ1(A)

    Demande de radiation de la société du registre du commerce

    3 pagesDS01

    Déclaration annuelle jusqu'au 16 mars 2011 avec liste complète des actionnaires

    5 pagesAR01
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    capital23 mars 2011

    État du capital au 23 mars 2011

    • Capital: GBP 3,700,000
    SH01

    Comptes pour une société dormante établis au 31 déc. 2009

    6 pagesAA

    Déclaration annuelle jusqu'au 16 mars 2010 avec liste complète des actionnaires

    5 pagesAR01

    Modification des coordonnées de l'administrateur Mr Nigel Keith Sissons le 18 mars 2010

    2 pagesCH01

    Comptes pour une société dormante établis au 31 déc. 2008

    6 pagesAA

    legacy

    3 pages363a

    Comptes pour une société dormante établis au 31 déc. 2007

    6 pagesAA

    legacy

    3 pages363a

    Comptes pour une société dormante établis au 31 déc. 2006

    6 pagesAA

    legacy

    7 pages363s

    Comptes pour une société dormante établis au 31 déc. 2005

    6 pagesAA

    legacy

    7 pages363s

    Comptes pour une société dormante établis au 31 déc. 2004

    6 pagesAA

    legacy

    7 pages363s
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    annual-return17 mai 2005

    legacy

    363(288)

    Comptes pour une société dormante établis au 31 déc. 2003

    6 pagesAA

    legacy

    7 pages363s

    Comptes pour une société dormante établis au 31 déc. 2002

    6 pagesAA

    legacy

    7 pages363s

    Qui sont les dirigeants de INDALEX LIMITED ?

    Dirigeants
    NomNommé leDate de démissionRôleAdresseIdentification de la sociétéPays de résidenceNationalitéDate de naissanceProfessionNuméro
    DANIELS, Anthony Patrick
    Derwent 26 Sydenham Road
    GL52 6EA Cheltenham
    Gloucestershire
    Secrétaire
    Derwent 26 Sydenham Road
    GL52 6EA Cheltenham
    Gloucestershire
    BritishBusiness Area Controller24297480001
    DANIELS, Anthony Patrick
    Derwent 26 Sydenham Road
    GL52 6EA Cheltenham
    Gloucestershire
    Administrateur
    Derwent 26 Sydenham Road
    GL52 6EA Cheltenham
    Gloucestershire
    EnglandBritishBusiness Area Controller24297480001
    SISSONS, Nigel Keith
    c/o C/O Sapa Building Systems Ltd
    Severn Drive
    Tewkesbury Business Park
    GL20 8TX Tewkesbury
    5300
    Gloucestershire
    United Kingdom
    Administrateur
    c/o C/O Sapa Building Systems Ltd
    Severn Drive
    Tewkesbury Business Park
    GL20 8TX Tewkesbury
    5300
    Gloucestershire
    United Kingdom
    EnglandBritishManaging Director80321870001
    DANIELS, Anthony Patrick
    Derwent 26 Sydenham Road
    GL52 6EA Cheltenham
    Gloucestershire
    Secrétaire
    Derwent 26 Sydenham Road
    GL52 6EA Cheltenham
    Gloucestershire
    British24297480001
    HARDING, Simon
    1 Hillview Road
    GL52 5AD Cheltenham
    Gloucestershire
    Secrétaire
    1 Hillview Road
    GL52 5AD Cheltenham
    Gloucestershire
    British51992810001
    HEENAN, Duncan
    Dolphins House
    Boxers Lane
    PO38 2BH Niton
    Isle Of Wight
    Secrétaire
    Dolphins House
    Boxers Lane
    PO38 2BH Niton
    Isle Of Wight
    BritishChartered Accountant118536400001
    LIGHTOWLERS, John
    3 Ribston Mews
    Stroud Road
    GL1 5EU Gloucester
    Gloucestershire
    Secrétaire
    3 Ribston Mews
    Stroud Road
    GL1 5EU Gloucester
    Gloucestershire
    British111277770001
    MEEUWISSEN-TRUE, Steven Michael
    211 Prestbury Road
    GL52 3ES Cheltenham
    Gloucestershire
    Secrétaire
    211 Prestbury Road
    GL52 3ES Cheltenham
    Gloucestershire
    British61526840001
    PARKER, Laurence
    Bramble Lodge 5 Vale Bank
    Arlingham
    GL2 7JT Gloucester
    Secrétaire
    Bramble Lodge 5 Vale Bank
    Arlingham
    GL2 7JT Gloucester
    BritishManufacturing Director56038650001
    WILSON, Matthew Tennant
    110 Charlton Lane
    GL53 9EA Cheltenham
    Gloucestershire
    Secrétaire
    110 Charlton Lane
    GL53 9EA Cheltenham
    Gloucestershire
    British6458060001
    DEEKS, Andrew Gerald
    32 Henley Street
    B49 5QY Alcester
    Warwickshire
    Administrateur
    32 Henley Street
    B49 5QY Alcester
    Warwickshire
    EnglandBritishCompany Director3779900001
    FORMAN, Christopher
    71 Montpellier Terrace
    GL50 1XA Cheltenham
    Gloucestershire
    Administrateur
    71 Montpellier Terrace
    GL50 1XA Cheltenham
    Gloucestershire
    BritishCompany Director58933120001
    GREENSLADE, Robin Alastair
    Avonscroft Dock Lane
    Bredon
    GL20 6LG Tewkesbury
    Gloucestershire
    Administrateur
    Avonscroft Dock Lane
    Bredon
    GL20 6LG Tewkesbury
    Gloucestershire
    BritishCompany Director4565340001
    HEENAN, Duncan
    Dolphins House
    Boxers Lane
    PO38 2BH Niton
    Isle Of Wight
    Administrateur
    Dolphins House
    Boxers Lane
    PO38 2BH Niton
    Isle Of Wight
    EnglandBritishChartered Accountant118536400001
    HERRINGTON, Hugh Richard
    Touchwood Grimms Hill
    HP16 9BG Great Missenden
    Buckinghamshire
    Administrateur
    Touchwood Grimms Hill
    HP16 9BG Great Missenden
    Buckinghamshire
    United KingdomBritishCompany Director6360950001
    JOHANSSON, Mats Harald
    4 Paddocks View
    Long Eaton
    NG10 3QF Nottingham
    Nottinghamshire
    Administrateur
    4 Paddocks View
    Long Eaton
    NG10 3QF Nottingham
    Nottinghamshire
    SwedishManufacturing Director68575210001
    MEEUWISSEN-TRUE, Steven Michael
    211 Prestbury Road
    GL52 3ES Cheltenham
    Gloucestershire
    Administrateur
    211 Prestbury Road
    GL52 3ES Cheltenham
    Gloucestershire
    United KingdomBritishFinance Director61526840001
    MINES, Geoffrey
    1 Orchard Rise
    OX18 4SZ Burford
    Oxfordshire
    Administrateur
    1 Orchard Rise
    OX18 4SZ Burford
    Oxfordshire
    BritishSales Director65989880002
    PARKER, Laurence
    Bramble Lodge 5 Vale Bank
    Arlingham
    GL2 7JT Gloucester
    Administrateur
    Bramble Lodge 5 Vale Bank
    Arlingham
    GL2 7JT Gloucester
    EnglandBritishCompany Director56038650001
    PHILLIPS, Derek Edward
    Nybrogatan
    FOREIGN 60 Tr.1
    114 40 Stockholm
    Sweden
    Administrateur
    Nybrogatan
    FOREIGN 60 Tr.1
    114 40 Stockholm
    Sweden
    BritishCompany Director6458080002
    STUBBS, Timothy Rupert John
    Bell House Bell Lane
    GL56 9ES Blockley
    Gloucestershire
    Administrateur
    Bell House Bell Lane
    GL56 9ES Blockley
    Gloucestershire
    BritishMarketing Director60722060001
    TURNER, Brian Charles
    Ravensworth
    Thirlestaine Road
    GL53 7AS Cheltenham
    Gloucestershire
    Administrateur
    Ravensworth
    Thirlestaine Road
    GL53 7AS Cheltenham
    Gloucestershire
    BritishCompany Director5135500001
    WILSON, Matthew Tennant
    110 Charlton Lane
    GL53 9EA Cheltenham
    Gloucestershire
    Administrateur
    110 Charlton Lane
    GL53 9EA Cheltenham
    Gloucestershire
    BritishCompany Director6458060001

    INDALEX LIMITED a-t-elle des charges ?

    Charges
    ClassificationDatesStatutDétails
    Deed of charge over credit balances
    Créé le 14 sept. 1998
    Livré le 02 oct. 1998
    En cours
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Fixed charge over all the deposit(s) in and to the charged deposit contract with barclays bank PLC re;-indalex limited barclays treasury deposit dutch guilders deposit deal no;85232966. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Barclays Bank PLC
    Transactions
    • 02 oct. 1998Enregistrement d'une charge (395)
    Deed of charge over credit balances
    Créé le 14 sept. 1998
    Livré le 02 oct. 1998
    En cours
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Fixed charge over all deposit(s) in and to the charged deposit contract with barclays bank PLC re ;-indalex limited barclays treasury deposit deutche marks deposit deal no.85232966. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Barclays Bank PLC
    Transactions
    • 02 oct. 1998Enregistrement d'une charge (395)
    Debenture
    Créé le 04 mai 1994
    Livré le 12 mai 1994
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due from the company to the chargee (as defined in the charge) on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Bredon Group Limited
    Transactions
    • 12 mai 1994Enregistrement d'une charge (395)
    • 30 juil. 1999Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Single debenture
    Créé le 04 mai 1994
    Livré le 12 mai 1994
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Lloyds Bank PLC
    Transactions
    • 12 mai 1994Enregistrement d'une charge (395)
    • 30 juil. 1999Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Debenture
    Créé le 04 mai 1994
    Livré le 06 mai 1994
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee under or in respect of the guarantee or this debenture
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personnes ayant droit
    • R.T.Z. Metals Limited
    Transactions
    • 06 mai 1994Enregistrement d'une charge (395)
    • 04 juil. 1996Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)

    Source de données

    • Companies House du Royaume-Uni
      Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers.
    • Licence: CC0