KCI MEDICAL PRODUCTS (UK) LIMITED

KCI MEDICAL PRODUCTS (UK) LIMITED

  • Vue d'ensemble
  • Résumé
  • Objet social
  • Adresse
  • Dénominations sociales précédentes
  • Comptes
  • Dépôts
  • Dirigeants
  • Personnes ayant un contrôle significatif
  • Charges
  • Source de données
  • Vue d'ensemble

    Nom de la sociétéKCI MEDICAL PRODUCTS (UK) LIMITED
    Statut de la sociétéDissoute
    Forme juridiqueSociété à responsabilité limitée
    Numéro de société 00700656
    JuridictionAngleterre/Pays de Galles
    Date de création
    Date de cessation d'activité

    Résumé

    A des PSCs super sécurisésNon
    A des chargesOui
    A un historique d'insolvabilitéNon
    Le siège social est contestéNon

    Quel est l'objet de KCI MEDICAL PRODUCTS (UK) LIMITED ?

    • Fabrication d'instruments et fournitures médicaux et dentaires (32500) / Industries manufacturières

    Où se situe KCI MEDICAL PRODUCTS (UK) LIMITED ?

    Adresse du siège social
    Belmont House
    Station Way
    RH10 1JA Crawley
    West Sussex
    Adresse du siège social non livrableNon

    Quels étaient les noms précédents de KCI MEDICAL PRODUCTS (UK) LIMITED ?

    Dénominations sociales précédentes
    Nom de la sociétéDeJusqu'au
    MEDISCUS PRODUCTS LIMITED31 déc. 197731 déc. 1977
    GEEVA ENGINEERING COMPANY LIMITED11 août 196111 août 1961

    Quels sont les derniers comptes de KCI MEDICAL PRODUCTS (UK) LIMITED ?

    Derniers comptes
    Derniers comptes arrêtés au31 déc. 2021

    Quels sont les derniers dépôts pour KCI MEDICAL PRODUCTS (UK) LIMITED ?

    Dépôts
    DateDescriptionDocumentType

    Bulletin officiel final dissous par radiation volontaire

    1 pagesGAZ2(A)

    Premier avis au Bulletin officiel pour la radiation volontaire

    1 pagesGAZ1(A)

    Demande de radiation de la société du registre du commerce

    1 pagesDS01

    Déclaration de confirmation établie le 28 nov. 2022 sans mise à jour

    3 pagesCS01

    État du capital au 05 juil. 2022

    • Capital: GBP 1
    3 pagesSH19

    legacy

    1 pagesSH20

    legacy

    1 pagesCAP-SS

    Résolutions

    Resolutions
    2 pagesRESOLUTIONS
    Résolutions
    CatégorieDateDescriptionType
    capital

    Résolutions

    Reduce share prem a/c 01/07/2022
    RES13
    capital

    Résolution de réduction du capital social émis

    RES06

    Comptes pour une société dormante établis au 31 déc. 2021

    3 pagesAA

    Déclaration de confirmation établie le 28 nov. 2021 sans mise à jour

    3 pagesCS01

    Comptes pour une société dormante établis au 31 déc. 2020

    3 pagesAA

    Cessation de la nomination de Irfan Mohammed Malik en tant que directeur le 01 déc. 2020

    1 pagesTM01

    Nomination de Jonathan Robert Lasparini en tant qu'administrateur le 01 déc. 2020

    2 pagesAP01

    Cessation de la nomination de Simla Semerciyan en tant que directeur le 01 déc. 2020

    1 pagesTM01

    Nomination de Lars Hanseid en tant qu'administrateur le 01 déc. 2020

    2 pagesAP01

    Déclaration de confirmation établie le 28 nov. 2020 sans mise à jour

    3 pagesCS01

    Comptes pour une société dormante établis au 31 déc. 2019

    3 pagesAA

    Cessation de la nomination de John Thomas Bibb en tant que directeur le 11 oct. 2019

    1 pagesTM01

    Cessation de la nomination de John Patrick Panther en tant que directeur le 11 oct. 2019

    1 pagesTM01

    Cessation de la nomination de Christiaan Jan Otto Pool en tant que directeur le 11 oct. 2019

    1 pagesTM01

    Nomination de Simla Semerciyan en tant qu'administrateur le 11 oct. 2019

    2 pagesAP01

    Nomination de Irfan Mohammed Malik en tant qu'administrateur le 11 oct. 2019

    2 pagesAP01

    La procédure de radiation d'office a été abandonnée

    1 pagesDISS40

    Premier avis au Bulletin officiel pour la radiation d'office

    1 pagesGAZ1

    Déclaration de confirmation établie le 28 nov. 2019 sans mise à jour

    3 pagesCS01

    Qui sont les dirigeants de KCI MEDICAL PRODUCTS (UK) LIMITED ?

    Dirigeants
    NomNommé leDate de démissionRôleAdresseIdentification de la sociétéPays de résidenceNationalitéDate de naissanceProfessionNuméro
    IRWIN MITCHELL SECRETARIES LIMITED
    Friary Lane
    PO19 1UF Chichester
    Thomas Eggar House
    West Sussex
    United Kingdom
    Secrétaire
    Friary Lane
    PO19 1UF Chichester
    Thomas Eggar House
    West Sussex
    United Kingdom
    37896530018
    HANSEID, Lars
    Station Way
    RH10 1JA Crawley
    Belmont House
    West Sussex
    Administrateur
    Station Way
    RH10 1JA Crawley
    Belmont House
    West Sussex
    United KingdomNorwegianManager275478440001
    LASPARINI, Jonathan Robert
    Station Way
    RH10 1JA Crawley
    Belmont House
    West Sussex
    Administrateur
    Station Way
    RH10 1JA Crawley
    Belmont House
    West Sussex
    United KingdomBritishFinance Manager270137030001
    DRAKE, Andrew Nicholas
    61 Brook Street
    W1K 4BL London
    Secrétaire
    61 Brook Street
    W1K 4BL London
    BritishAssistant Secretary48185570001
    HOLVEY, Michael Anthony John
    35 Pinewood Road
    BH22 9RP Ferndown
    Dorset
    Secrétaire
    35 Pinewood Road
    BH22 9RP Ferndown
    Dorset
    British125006650001
    LESAGE, Antoine
    De Croixlaan 2
    Berg
    1910
    Belgium
    Secrétaire
    De Croixlaan 2
    Berg
    1910
    Belgium
    BelgiumLegal Course Vplegal107191470001
    NOLL, Dennis Edward
    5 Birnam Oaks
    San Antonio
    Texas 78248
    U.S.A.
    Secrétaire
    5 Birnam Oaks
    San Antonio
    Texas 78248
    U.S.A.
    AmericanSecretary35805720003
    POLLINGTON, David
    Culmer 48 Golf Links Road
    BH22 8BZ Ferndown
    Dorset
    Secrétaire
    Culmer 48 Golf Links Road
    BH22 8BZ Ferndown
    Dorset
    British6048410001
    WEHRMEYER, Robert
    29302 Grand Coteau
    FOREIGN Boerne
    Texas 78006
    Usa
    Secrétaire
    29302 Grand Coteau
    FOREIGN Boerne
    Texas 78006
    Usa
    AmericanSenior Vice President And General Counsel12499670001
    AVERSANO, Rudolph C
    101 William Street
    FOREIGN So Dartmouth
    Ma 02748
    Usa
    Administrateur
    101 William Street
    FOREIGN So Dartmouth
    Ma 02748
    Usa
    UsaPresident & Chief Executive Officer6504120001
    BIBB, John Thomas
    Interstate 10 West
    78249 San Antonio
    12930
    Texas
    United States
    Administrateur
    Interstate 10 West
    78249 San Antonio
    12930
    Texas
    United States
    United StatesAmericanAssociate General Counsel151052470001
    BURNS, William John David
    Langford Business Park
    Langford Locks Kidlington
    OX5 1GF Oxfordshire
    Kci House
    United Kingdom
    Administrateur
    Langford Business Park
    Langford Locks Kidlington
    OX5 1GF Oxfordshire
    Kci House
    United Kingdom
    United KingdomBritishVice President Lifecell Emea129880280001
    CITO, Adriano
    1181le Amstelveen
    Van Heuven Goedhartlaan 11
    Netherlands
    Administrateur
    1181le Amstelveen
    Van Heuven Goedhartlaan 11
    Netherlands
    HungaryItalianVice-President Finance Emea Region149090240002
    DILAZZARO, Frank
    16203 Robinwood Lane
    San Antonio
    Texas 78248
    Usa
    Administrateur
    16203 Robinwood Lane
    San Antonio
    Texas 78248
    Usa
    CanadianVice-President12660610001
    HOLVEY, Michael
    34 Pinewood Road
    BH22 9RR Ferndown
    Dorset
    Administrateur
    34 Pinewood Road
    BH22 9RR Ferndown
    Dorset
    BritishCompany Director45788560002
    HOLVEY, Michael
    18 Darley Road
    BH22 8QX Ferndown
    Dorset
    Administrateur
    18 Darley Road
    BH22 8QX Ferndown
    Dorset
    BritishCompany Director45788560001
    HOWLING, Richard John
    20 Old Coastguard Road
    Sandbanks
    BH13 7RL Poole
    Dorset
    Administrateur
    20 Old Coastguard Road
    Sandbanks
    BH13 7RL Poole
    Dorset
    BritishChartered Accountant & Director40708600001
    HUNT, Kenneth William
    18 Egdon Drive
    BH21 1TY Wimborne
    Dorset
    Administrateur
    18 Egdon Drive
    BH21 1TY Wimborne
    Dorset
    BritishEngineer58965530001
    JOYCE, Mick
    74 Dewlands Way
    BH31 6JN Verwood
    Dorset
    Administrateur
    74 Dewlands Way
    BH31 6JN Verwood
    Dorset
    BritishDirector87063040001
    KASHYAP, Rohit Shrikant
    Kci House
    Langford Locks
    OX5 1GF Kidlington
    Kci Medical Limited
    Oxfordshire
    United Kingdom
    Administrateur
    Kci House
    Langford Locks
    OX5 1GF Kidlington
    Kci Medical Limited
    Oxfordshire
    United Kingdom
    United StatesAmericanSenior Vice President, Tss Europe & Global Strateg151052390001
    KUMAR, Tirunvelvchi Lakshmanaswamy Varadaraj
    Langley Road
    Merton Park
    SW19 3NZ London
    10
    Administrateur
    Langley Road
    Merton Park
    SW19 3NZ London
    10
    IndianPresident Of Kci Emea129073450001
    LEININGER, James
    8023 Vantage Drive
    San Antonio Texas
    FOREIGN Usa
    Usa
    Administrateur
    8023 Vantage Drive
    San Antonio Texas
    FOREIGN Usa
    Usa
    AmericanDoctor Of Medicine22327270002
    LESAGE, Antoine
    De Croixlaan 2
    Berg
    1910
    Belgium
    Administrateur
    De Croixlaan 2
    Berg
    1910
    Belgium
    BelgiumLegal Course Vplegal107191470001
    MALIK, Irfan Mohammed
    Centre
    Cain Road
    RG12 8HT Bracknell
    3m
    Berkshire
    United Kingdom
    Administrateur
    Centre
    Cain Road
    RG12 8HT Bracknell
    3m
    Berkshire
    United Kingdom
    United KingdomPakistaniDirector265894900001
    MATTHEWS, Michael Edward
    Station Way
    RH10 1JA Crawley
    Belmont House
    West Sussex
    Administrateur
    Station Way
    RH10 1JA Crawley
    Belmont House
    West Sussex
    United KingdomAmericanDirector172416940001
    MENTEN, Jorg Wilhelm
    Forggenstrasse 27
    Manneheim
    68279
    Germany
    Administrateur
    Forggenstrasse 27
    Manneheim
    68279
    Germany
    GermanPresident Kci Int'L109844500001
    MENTEN, Jorg Wilhelm
    Forggenstrasse 27
    Manneheim
    68279
    Germany
    Administrateur
    Forggenstrasse 27
    Manneheim
    68279
    Germany
    GermanDirector109844500001
    NOLL, Dennis Edward
    5 Birnam Oaks
    San Antonio
    Texas 78248
    U.S.A.
    Administrateur
    5 Birnam Oaks
    San Antonio
    Texas 78248
    U.S.A.
    AmericanSecretary35805720003
    PANTHER, John Patrick
    4th Floor, One Kingdom Street
    Paddington Central
    W2 6BD London
    Kci Uk Holdings Ltd
    United Kingdom
    Administrateur
    4th Floor, One Kingdom Street
    Paddington Central
    W2 6BD London
    Kci Uk Holdings Ltd
    United Kingdom
    EnglandAmericanIn-House Counsel183237410001
    PEREZ, Arthur Alejandro
    Noordlaan 32
    Bergen
    1861 Gn
    Netherlands
    Administrateur
    Noordlaan 32
    Bergen
    1861 Gn
    Netherlands
    United StatesAss General Counsel135039390001
    POLLINGTON, David
    Culmer 48 Golf Links Road
    BH22 8BZ Ferndown
    Dorset
    Administrateur
    Culmer 48 Golf Links Road
    BH22 8BZ Ferndown
    Dorset
    EnglandBritishManaging Director6048410001
    POOL, Christiaan Jan Otto
    Station Way
    RH10 1JA Crawley
    Belmont House
    West Sussex
    Administrateur
    Station Way
    RH10 1JA Crawley
    Belmont House
    West Sussex
    NetherlandsDutchDirector206646900001
    SEIDEL, Stephen Dale
    Vantage Dr.
    78230 San Antonio
    8023
    Texas
    Usa
    Administrateur
    Vantage Dr.
    78230 San Antonio
    8023
    Texas
    Usa
    UsaUsPresident166457690001
    SEIDEL, Stephen Dale
    214 Charles Road
    San Antonio
    Tx 78209
    Usa
    Administrateur
    214 Charles Road
    San Antonio
    Tx 78209
    Usa
    UsaUsGeneral Counsel166457690001
    SEMERCIYAN, Simla
    Centre
    Cain Road
    RG12 8HT Bracknell
    3m
    Berkshire
    United Kingdom
    Administrateur
    Centre
    Cain Road
    RG12 8HT Bracknell
    3m
    Berkshire
    United Kingdom
    United KingdomTurkishFinance Director246637820002

    Qui sont les personnes ayant un contrôle significatif sur KCI MEDICAL PRODUCTS (UK) LIMITED ?

    Personnes ayant un contrôle significatif
    NomNotifié leAdresseCessé
    Kci Medical Limited
    Station Way
    RH10 1JA Crawley
    Belmont House
    England
    06 avr. 2016
    Station Way
    RH10 1JA Crawley
    Belmont House
    England
    Non
    Forme juridiquePrivate Company Limited By Shares
    Pays d'enregistrementEngland & Wales
    Autorité légaleCompanies Act 2006
    Lieu d'enregistrementEngland & Wales
    Numéro d'enregistrement01130981
    Nature du contrôle
    • La personne détient, directement ou indirectement, plus de 75 % des actions de la société.
    • La personne détient, directement ou indirectement, plus de 75 % des droits de vote dans la société.
    • La personne détient, directement ou indirectement, le droit de nommer ou de révoquer une majorité des membres du conseil d'administration de la société.

    KCI MEDICAL PRODUCTS (UK) LIMITED a-t-elle des charges ?

    Charges
    ClassificationDatesStatutDétails
    Charge of deposit
    Créé le 05 juil. 2012
    Livré le 17 juil. 2012
    En cours
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    All amounts now and in the future credited to account number 90290569 with the bank.
    Personnes ayant droit
    • National Westminster Bank PLC
    Transactions
    • 17 juil. 2012Enregistrement d'une charge (MG01)
    Fixed and floating charge
    Créé le 27 mars 1990
    Livré le 17 avr. 1990
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    A fixed charge on all book & othe leets owing to the company. Floating charge over undertaking and all property and assets present and future including book debts uncalled capital (excluding those mentioned above).
    Personnes ayant droit
    • Midland Bank PLC
    Transactions
    • 17 avr. 1990Enregistrement d'une charge
    Assignment
    Créé le 20 mai 1987
    Livré le 20 mai 1987
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All moneys due or to become due from the company to nat west investment bank limited hambros bank limited and ensign trust PLC under the terms of a loan agreement dated 24/4/87 and on overdraft facility letter dated 1/5/87
    Brèves mentions
    Assigns to the cender all the rights, titles, bnefits and in terests of the company in the facility letters issued by the company on 1/5/87 (see form 395 for full details).
    Personnes ayant droit
    • Natwest Investment Bank Limited
    • Ensign Trust PLC
    • Hambros Bank Limited
    Transactions
    • 20 mai 1987Enregistrement d'une charge
    Charge
    Créé le 20 mai 1987
    Livré le 20 mai 1987
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All moneys due or to become due from the company to nat west investment bank limited hambros bank limited and ensign trust PLC under te terms of a loan agrement dated 24/4/87 and the overdroft facility letter dated 1/5/87 and under the terms of the charge
    Brèves mentions
    All dividends or interest paid on the entire issued & all otted stock of medisais products inc (the securities) (see form 395 for full details).
    Personnes ayant droit
    • National Investment Bank Limited
    • Ensign Trust PLC
    • Hambros Bank Limited
    Transactions
    • 20 mai 1987Enregistrement d'une charge
    Mortgage debenture
    Créé le 20 mai 1987
    Livré le 20 mai 1987
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of a loan agreement dated 24/4/87 and under the terms of the charge
    Brèves mentions
    A specific equitable charge over all freehold and leasehold properties fixed and floating charges over undertaking and all property and assets present and future including goodwill, bookdebts and the benefits of any licences.
    Personnes ayant droit
    • Ensign Trust PLC
    Transactions
    • 20 mai 1987Enregistrement d'une charge
    Mortgage debenture
    Créé le 20 mai 1987
    Livré le 20 mai 1987
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of a loan agreement datee 24/4/87 and a facility letter dated 1/4/87 and under the terms of the charge
    Brèves mentions
    A specific equitable charge over all freehold and leasehold properties fixed and floating charges over undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts and the benefits of any licences.
    Personnes ayant droit
    • Hambres Bank Limited
    Transactions
    • 20 mai 1987Enregistrement d'une charge
    Mortgage debenture
    Créé le 20 mai 1987
    Livré le 20 mai 1987
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of a loan agreement dated 24/4/87 and under the terms of the chargee
    Brèves mentions
    4 units known as 10 westminster road wareham, dorset a specific equitable charge over all freehold and leasehold properties fixed and floating charges over undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts and the benefits of any licences.
    Personnes ayant droit
    • Nat West Investment Bank Limited
    Transactions
    • 20 mai 1987Enregistrement d'une charge
    Further guarantee & debenture
    Créé le 30 juin 1983
    Livré le 08 juil. 1983
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    All that property undertaking and assets charges by the principal deed and further deed.
    Personnes ayant droit
    • Barclays Bank PLC
    Transactions
    • 08 juil. 1983Enregistrement d'une charge
    Guarnatee & debenture
    Créé le 18 janv. 1980
    Livré le 25 janv. 1980
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever.
    Brèves mentions
    Fixed & floating charges on the undertaking and all property and assets present and future including goodwill & bookdebts uncalled capital with all buildings fixtures fixed plant & machinery.
    Personnes ayant droit
    • Barclays Bank PLC
    Transactions
    • 25 janv. 1980Enregistrement d'une charge

    Source de données

    • Companies House du Royaume-Uni
      Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers.
    • Licence: CC0