WILLIAM ROBERTS (HAULAGE) LIMITED
Vue d'ensemble
Nom de la société | WILLIAM ROBERTS (HAULAGE) LIMITED |
---|---|
Statut de la société | Dissoute |
Forme juridique | Société à responsabilité limitée |
Numéro de société | 00702778 |
Juridiction | Angleterre/Pays de Galles |
Date de création | |
Date de cessation d'activité |
Résumé
A des PSCs super sécurisés | Non |
---|---|
A des charges | Oui |
A un historique d'insolvabilité | Non |
Le siège social est contesté | Non |
Où se situe WILLIAM ROBERTS (HAULAGE) LIMITED ?
Adresse du siège social | Kelsall House Stafford Court Stafford Park 1 TF3 3BD Telford Shropshire England |
---|---|
Adresse du siège social non livrable | Non |
Quels sont les derniers comptes de WILLIAM ROBERTS (HAULAGE) LIMITED ?
Derniers comptes | |
---|---|
Derniers comptes arrêtés au | 31 déc. 2016 |
Quels sont les derniers dépôts pour WILLIAM ROBERTS (HAULAGE) LIMITED ?
Date | Description | Document | Type | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bulletin officiel final dissous par radiation volontaire | 1 pages | GAZ2(A) | ||||||||||
Premier avis au Bulletin officiel pour la radiation volontaire | 1 pages | GAZ1(A) | ||||||||||
Demande de radiation de la société du registre du commerce | 3 pages | DS01 | ||||||||||
Déclaration de confirmation établie le 05 juin 2018 sans mise à jour | 3 pages | CS01 | ||||||||||
Déclaration de confirmation établie le 19 mai 2018 sans mise à jour | 3 pages | CS01 | ||||||||||
Comptes annuels établis au 31 déc. 2016 | 14 pages | AA | ||||||||||
Déclaration de confirmation établie le 19 mai 2017 avec mises à jour | 5 pages | CS01 | ||||||||||
Démission de l'auditeur | 1 pages | AUD | ||||||||||
Changement d'adresse du siège social de 2 Coldbath Square London EC1R 5HL à Kelsall House Stafford Court Stafford Park 1 Telford Shropshire TF3 3BD le 26 juil. 2016 | 1 pages | AD01 | ||||||||||
Nomination de Mr John Sullivan en tant que secrétaire le 21 juil. 2016 | 2 pages | AP03 | ||||||||||
Cessation de la nomination de Richard Llewelyn Milnes-James en tant que directeur le 21 juil. 2016 | 1 pages | TM01 | ||||||||||
Cessation de la nomination de Charles Nicholas Pollard en tant que directeur le 21 juil. 2016 | 1 pages | TM01 | ||||||||||
Cessation de la nomination de Alistair Myrie Holl en tant que directeur le 21 juil. 2016 | 1 pages | TM01 | ||||||||||
Cessation de la nomination de Caroline Elizabeth Allen en tant que secrétaire le 21 juil. 2016 | 1 pages | TM02 | ||||||||||
Nomination de Mr John Terence Sullivan en tant qu'administrateur le 21 juil. 2016 | 2 pages | AP01 | ||||||||||
Nomination de Mr Paul Cox en tant qu'administrateur le 21 juil. 2016 | 2 pages | AP01 | ||||||||||
Satisfaction de la charge 007027780013 en totalité | 4 pages | MR04 | ||||||||||
Comptes annuels établis au 31 déc. 2015 | 13 pages | AA | ||||||||||
Déclaration annuelle jusqu'au 19 mai 2016 avec liste complète des actionnaires | 4 pages | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Nomination de Ms Caroline Elizabeth Allen en tant que secrétaire le 01 avr. 2016 | 2 pages | AP03 | ||||||||||
Cessation de la nomination de Sophie Catherine Jane Reed en tant que secrétaire le 01 avr. 2016 | 1 pages | TM02 | ||||||||||
Cessation de la nomination de Peter Anton Gerstrom en tant que directeur le 01 déc. 2015 | 1 pages | TM01 | ||||||||||
Nomination de Mr Charles Nicholas Pollard en tant qu'administrateur le 01 déc. 2015 | 2 pages | AP01 | ||||||||||
Comptes annuels établis au 31 déc. 2014 | 13 pages | AA | ||||||||||
Statuts | 9 pages | MA | ||||||||||
Qui sont les dirigeants de WILLIAM ROBERTS (HAULAGE) LIMITED ?
Nom | Nommé le | Date de démission | Rôle | Adresse | Identification de la société | Pays de résidence | Nationalité | Date de naissance | Profession | Numéro |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SULLIVAN, John | Secrétaire | Stafford Court Stafford Park 1 TF3 3BD Telford Kelsall House Shropshire England | 210822090001 | |||||||
COX, Paul Anthony | Administrateur | Stafford Court Stafford Park 1 TF3 3BD Telford Kelsall House Shropshire England | England | British | Company Director | 153797870001 | ||||
SULLIVAN, John Terence | Administrateur | Stafford Court Stafford Park 1 TF3 3BD Telford Kelsall House Shropshire England | England | British | Chartered Accountant | 180046340001 | ||||
ALLEN, Caroline Elizabeth | Secrétaire | 2 Coldbath Square London EC1R 5HL | 207872410001 | |||||||
DIXON, Sally Veronica | Secrétaire | 2 Coldbath Square London EC1R 5HL | British | 105363350001 | ||||||
JESKE, Riga | Secrétaire | 2 Coldbath Square London EC1R 5HL | 189290260001 | |||||||
KAHVECI, Suheda | Secrétaire | 2 Coldbath Square London EC1R 5HL | 176235070001 | |||||||
PHILLIPS, Elizabeth Clare | Secrétaire | 14 Blackhill Lane WA16 9DR Knutsford Cheshire | British | 56302980001 | ||||||
REED, Sophie Catherine Jane | Secrétaire | 2 Coldbath Square London EC1R 5HL | 198173670001 | |||||||
ROBERTS, Michael William | Secrétaire | 10 Larkfield Close Greenmount BL8 4QJ Bury Lancashire | British | 3145950001 | ||||||
EXEL SECRETARIAL SERVICES LIMITED | Secrétaire | Ocean House The Ring RG12 1AN Bracknell Berkshire | 32524900007 | |||||||
DIXON, Sally Veronica | Administrateur | 22 Ardleigh Road N1 4HP London | England | British | Director | 105363350001 | ||||
GERSTROM, Peter Anton | Administrateur | 2 Coldbath Square London EC1R 5HL | England | British | Company Director | 138719750001 | ||||
HARRISON, Julian John | Administrateur | 24 Havelock Road SY3 7NE Shrewsbury Salop | England | British | Director | 123927990001 | ||||
HOLL, Alistair Myrie | Administrateur | 2 Coldbath Square London EC1R 5HL | Wales | British | Director | 138014840001 | ||||
JOHNSON, Peter Stuart | Administrateur | The Old Post Office Church Road West Peckham ME18 5JL Maidstone Kent | England | British | Director | 11159620001 | ||||
MILNES-JAMES, Richard Llewelyn | Administrateur | 2 Coldbath Square London EC1R 5HL | United Kingdom | British | Finance Director | 140753960001 | ||||
PHILLIPS, John | Administrateur | 14 Blackhill Lane WA16 9DR Knutsford Cheshire | British | Director | 343070001 | |||||
POLLARD, Charles Nicholas | Administrateur | 2 Coldbath Square London EC1R 5HL | England | British | Director | 192011710001 | ||||
RIDDLE, David Ellison | Administrateur | 3 Lovelace Road KT6 6NS Surbiton Surrey | England | British | Director | 556710002 | ||||
ROBERTS, Michael William | Administrateur | 10 Larkfield Close Greenmount BL8 4QJ Bury Lancashire | England | British | Waste Disposal Contractor | 3145950001 | ||||
ROBERTS, Richard John | Administrateur | 24 Deacon Crescent BL8 3DW Bury Lancashire | British | Waste Disposal Manager | 49437130001 | |||||
STEGGLES, Jonathan David | Administrateur | 2 Coldbath Square London EC1R 5HL | United Kingdom | British | Director | 45141530001 | ||||
TAYLOR, James | Administrateur | 4 Rivershill Drive OL10 3BJ Heywood Lancashire | British | Transport Manager | 11374050001 | |||||
WARD, Malcolm John | Administrateur | 2 Coldbath Square London EC1R 5HL | United Kingdom | British | Certified Accountant | 57775660003 | ||||
WILLACY, Richard Johannes Ormerod | Administrateur | Wraymead 158 Croydon Road RH2 0NG Reigate Surrey | United Kingdom | British | Director | 92108930002 |
Qui sont les personnes ayant un contrôle significatif sur WILLIAM ROBERTS (HAULAGE) LIMITED ?
Nom | Notifié le | Adresse | Cessé | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Waste Hire Services Limited | 06 avr. 2016 | Stafford Park 1 TF3 3BD Telford Kelsall House England | Non | ||||||||||
| |||||||||||||
Nature du contrôle
|
WILLIAM ROBERTS (HAULAGE) LIMITED a-t-elle des charges ?
Classification | Dates | Statut | Détails | |
---|---|---|---|---|
A registered charge | Créé le 20 août 2015 Livré le 27 août 2015 | Totalement satisfaite | ||
Contient une promesse négative: Oui Contient une charge flottante: Oui Contient une charge fixe: Oui | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
A supplemental common debenture | Créé le 29 nov. 2011 Livré le 08 déc. 2011 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from each obligor to any secured finance party on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Brèves mentions Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
Deed of accession | Créé le 18 mai 2007 Livré le 25 mai 2007 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from each obligor to any secured finance party on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Brèves mentions Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
Debenture | Créé le 26 avr. 2005 Livré le 11 mai 2005 | Totalement satisfaite | Montant garanti All present and future obligations and liabilities due or to become due from the company to the chargee in its capacity as security agent for the beneficiaries on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Brèves mentions Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
Debenture deed | Créé le 04 déc. 1997 Livré le 18 déc. 1997 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brèves mentions All book debts and other debts. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
Debenture | Créé le 26 juil. 1993 Livré le 30 juil. 1993 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brèves mentions Fixed charge over the goodwill of the company.fixed charge over the property at whitelegge street,bury,lancashire BL8 1SW together with a floating charge over the undertaking and all property and assets including its uncalled capital. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
Debenture | Créé le 13 déc. 1991 Livré le 23 déc. 1991 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brèves mentions (See 395 for full details). Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
Legal charge | Créé le 01 juin 1977 Livré le 15 juin 1977 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brèves mentions F/H land and buildings lying to the north east of bury greater manchester title no gm 35264. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
Legal charge | Créé le 26 mai 1977 Livré le 15 juin 1977 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brèves mentions Land in spring vale street tottington greater manchester title no gm 93602. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
Legal charge | Créé le 26 mai 1977 Livré le 15 juin 1977 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brèves mentions F/H land and buildings lying to the north east of bury road tottington bury greater manchester title no GM35264. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
Legal charge | Créé le 15 févr. 1977 Livré le 22 févr. 1977 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brèves mentions Land & buildings in whitelegge st bury greater manchester. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
Legal charge | Créé le 21 mars 1975 Livré le 26 mars 1975 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brèves mentions 11 whitelegge street bury greater manchester. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
Legal charge | Créé le 21 mars 1975 Livré le 26 mars 1975 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brèves mentions Land & buildings on north west side of whitelegge street bury greater manchester. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
|
Source de données
- Companies House du Royaume-Uni
Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers. - Licence: CC0