WILLIAM ROBERTS (HAULAGE) LIMITED

WILLIAM ROBERTS (HAULAGE) LIMITED

  • Vue d'ensemble
  • Résumé
  • Objet social
  • Adresse
  • Comptes
  • Dépôts
  • Dirigeants
  • Personnes ayant un contrôle significatif
  • Charges
  • Source de données
  • Vue d'ensemble

    Nom de la sociétéWILLIAM ROBERTS (HAULAGE) LIMITED
    Statut de la sociétéDissoute
    Forme juridiqueSociété à responsabilité limitée
    Numéro de société 00702778
    JuridictionAngleterre/Pays de Galles
    Date de création
    Date de cessation d'activité

    Résumé

    A des PSCs super sécurisésNon
    A des chargesOui
    A un historique d'insolvabilitéNon
    Le siège social est contestéNon

    Quel est l'objet de WILLIAM ROBERTS (HAULAGE) LIMITED ?

    • Collecte de déchets non dangereux (38110) / Approvisionnement en eau, assainissement, gestion des déchets et activités de dépollution
    • Collecte de déchets dangereux (38120) / Approvisionnement en eau, assainissement, gestion des déchets et activités de dépollution

    Où se situe WILLIAM ROBERTS (HAULAGE) LIMITED ?

    Adresse du siège social
    Kelsall House Stafford Court
    Stafford Park 1
    TF3 3BD Telford
    Shropshire
    England
    Adresse du siège social non livrableNon

    Quels sont les derniers comptes de WILLIAM ROBERTS (HAULAGE) LIMITED ?

    Derniers comptes
    Derniers comptes arrêtés au31 déc. 2016

    Quels sont les derniers dépôts pour WILLIAM ROBERTS (HAULAGE) LIMITED ?

    Dépôts
    DateDescriptionDocumentType

    Bulletin officiel final dissous par radiation volontaire

    1 pagesGAZ2(A)

    Premier avis au Bulletin officiel pour la radiation volontaire

    1 pagesGAZ1(A)

    Demande de radiation de la société du registre du commerce

    3 pagesDS01

    Déclaration de confirmation établie le 05 juin 2018 sans mise à jour

    3 pagesCS01

    Déclaration de confirmation établie le 19 mai 2018 sans mise à jour

    3 pagesCS01

    Comptes annuels établis au 31 déc. 2016

    14 pagesAA

    Déclaration de confirmation établie le 19 mai 2017 avec mises à jour

    5 pagesCS01

    Démission de l'auditeur

    1 pagesAUD

    Changement d'adresse du siège social de 2 Coldbath Square London EC1R 5HL à Kelsall House Stafford Court Stafford Park 1 Telford Shropshire TF3 3BD le 26 juil. 2016

    1 pagesAD01

    Nomination de Mr John Sullivan en tant que secrétaire le 21 juil. 2016

    2 pagesAP03

    Cessation de la nomination de Richard Llewelyn Milnes-James en tant que directeur le 21 juil. 2016

    1 pagesTM01

    Cessation de la nomination de Charles Nicholas Pollard en tant que directeur le 21 juil. 2016

    1 pagesTM01

    Cessation de la nomination de Alistair Myrie Holl en tant que directeur le 21 juil. 2016

    1 pagesTM01

    Cessation de la nomination de Caroline Elizabeth Allen en tant que secrétaire le 21 juil. 2016

    1 pagesTM02

    Nomination de Mr John Terence Sullivan en tant qu'administrateur le 21 juil. 2016

    2 pagesAP01

    Nomination de Mr Paul Cox en tant qu'administrateur le 21 juil. 2016

    2 pagesAP01

    Satisfaction de la charge 007027780013 en totalité

    4 pagesMR04

    Comptes annuels établis au 31 déc. 2015

    13 pagesAA

    Déclaration annuelle jusqu'au 19 mai 2016 avec liste complète des actionnaires

    4 pagesAR01
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    capital26 mai 2016

    État du capital au 26 mai 2016

    • Capital: GBP 3,265
    SH01

    Nomination de Ms Caroline Elizabeth Allen en tant que secrétaire le 01 avr. 2016

    2 pagesAP03

    Cessation de la nomination de Sophie Catherine Jane Reed en tant que secrétaire le 01 avr. 2016

    1 pagesTM02

    Cessation de la nomination de Peter Anton Gerstrom en tant que directeur le 01 déc. 2015

    1 pagesTM01

    Nomination de Mr Charles Nicholas Pollard en tant qu'administrateur le 01 déc. 2015

    2 pagesAP01

    Comptes annuels établis au 31 déc. 2014

    13 pagesAA

    Statuts

    9 pagesMA

    Qui sont les dirigeants de WILLIAM ROBERTS (HAULAGE) LIMITED ?

    Dirigeants
    NomNommé leDate de démissionRôleAdresseIdentification de la sociétéPays de résidenceNationalitéDate de naissanceProfessionNuméro
    SULLIVAN, John
    Stafford Court
    Stafford Park 1
    TF3 3BD Telford
    Kelsall House
    Shropshire
    England
    Secrétaire
    Stafford Court
    Stafford Park 1
    TF3 3BD Telford
    Kelsall House
    Shropshire
    England
    210822090001
    COX, Paul Anthony
    Stafford Court
    Stafford Park 1
    TF3 3BD Telford
    Kelsall House
    Shropshire
    England
    Administrateur
    Stafford Court
    Stafford Park 1
    TF3 3BD Telford
    Kelsall House
    Shropshire
    England
    EnglandBritishCompany Director153797870001
    SULLIVAN, John Terence
    Stafford Court
    Stafford Park 1
    TF3 3BD Telford
    Kelsall House
    Shropshire
    England
    Administrateur
    Stafford Court
    Stafford Park 1
    TF3 3BD Telford
    Kelsall House
    Shropshire
    England
    EnglandBritishChartered Accountant180046340001
    ALLEN, Caroline Elizabeth
    2 Coldbath Square
    London
    EC1R 5HL
    Secrétaire
    2 Coldbath Square
    London
    EC1R 5HL
    207872410001
    DIXON, Sally Veronica
    2 Coldbath Square
    London
    EC1R 5HL
    Secrétaire
    2 Coldbath Square
    London
    EC1R 5HL
    British105363350001
    JESKE, Riga
    2 Coldbath Square
    London
    EC1R 5HL
    Secrétaire
    2 Coldbath Square
    London
    EC1R 5HL
    189290260001
    KAHVECI, Suheda
    2 Coldbath Square
    London
    EC1R 5HL
    Secrétaire
    2 Coldbath Square
    London
    EC1R 5HL
    176235070001
    PHILLIPS, Elizabeth Clare
    14 Blackhill Lane
    WA16 9DR Knutsford
    Cheshire
    Secrétaire
    14 Blackhill Lane
    WA16 9DR Knutsford
    Cheshire
    British56302980001
    REED, Sophie Catherine Jane
    2 Coldbath Square
    London
    EC1R 5HL
    Secrétaire
    2 Coldbath Square
    London
    EC1R 5HL
    198173670001
    ROBERTS, Michael William
    10 Larkfield Close
    Greenmount
    BL8 4QJ Bury
    Lancashire
    Secrétaire
    10 Larkfield Close
    Greenmount
    BL8 4QJ Bury
    Lancashire
    British3145950001
    EXEL SECRETARIAL SERVICES LIMITED
    Ocean House
    The Ring
    RG12 1AN Bracknell
    Berkshire
    Secrétaire
    Ocean House
    The Ring
    RG12 1AN Bracknell
    Berkshire
    32524900007
    DIXON, Sally Veronica
    22 Ardleigh Road
    N1 4HP London
    Administrateur
    22 Ardleigh Road
    N1 4HP London
    EnglandBritishDirector105363350001
    GERSTROM, Peter Anton
    2 Coldbath Square
    London
    EC1R 5HL
    Administrateur
    2 Coldbath Square
    London
    EC1R 5HL
    EnglandBritishCompany Director138719750001
    HARRISON, Julian John
    24 Havelock Road
    SY3 7NE Shrewsbury
    Salop
    Administrateur
    24 Havelock Road
    SY3 7NE Shrewsbury
    Salop
    EnglandBritishDirector123927990001
    HOLL, Alistair Myrie
    2 Coldbath Square
    London
    EC1R 5HL
    Administrateur
    2 Coldbath Square
    London
    EC1R 5HL
    WalesBritishDirector138014840001
    JOHNSON, Peter Stuart
    The Old Post Office
    Church Road West Peckham
    ME18 5JL Maidstone
    Kent
    Administrateur
    The Old Post Office
    Church Road West Peckham
    ME18 5JL Maidstone
    Kent
    EnglandBritishDirector11159620001
    MILNES-JAMES, Richard Llewelyn
    2 Coldbath Square
    London
    EC1R 5HL
    Administrateur
    2 Coldbath Square
    London
    EC1R 5HL
    United KingdomBritishFinance Director140753960001
    PHILLIPS, John
    14 Blackhill Lane
    WA16 9DR Knutsford
    Cheshire
    Administrateur
    14 Blackhill Lane
    WA16 9DR Knutsford
    Cheshire
    BritishDirector343070001
    POLLARD, Charles Nicholas
    2 Coldbath Square
    London
    EC1R 5HL
    Administrateur
    2 Coldbath Square
    London
    EC1R 5HL
    EnglandBritishDirector192011710001
    RIDDLE, David Ellison
    3 Lovelace Road
    KT6 6NS Surbiton
    Surrey
    Administrateur
    3 Lovelace Road
    KT6 6NS Surbiton
    Surrey
    EnglandBritishDirector556710002
    ROBERTS, Michael William
    10 Larkfield Close
    Greenmount
    BL8 4QJ Bury
    Lancashire
    Administrateur
    10 Larkfield Close
    Greenmount
    BL8 4QJ Bury
    Lancashire
    EnglandBritishWaste Disposal Contractor3145950001
    ROBERTS, Richard John
    24 Deacon Crescent
    BL8 3DW Bury
    Lancashire
    Administrateur
    24 Deacon Crescent
    BL8 3DW Bury
    Lancashire
    BritishWaste Disposal Manager49437130001
    STEGGLES, Jonathan David
    2 Coldbath Square
    London
    EC1R 5HL
    Administrateur
    2 Coldbath Square
    London
    EC1R 5HL
    United KingdomBritishDirector45141530001
    TAYLOR, James
    4 Rivershill Drive
    OL10 3BJ Heywood
    Lancashire
    Administrateur
    4 Rivershill Drive
    OL10 3BJ Heywood
    Lancashire
    BritishTransport Manager11374050001
    WARD, Malcolm John
    2 Coldbath Square
    London
    EC1R 5HL
    Administrateur
    2 Coldbath Square
    London
    EC1R 5HL
    United KingdomBritishCertified Accountant57775660003
    WILLACY, Richard Johannes Ormerod
    Wraymead
    158 Croydon Road
    RH2 0NG Reigate
    Surrey
    Administrateur
    Wraymead
    158 Croydon Road
    RH2 0NG Reigate
    Surrey
    United KingdomBritishDirector92108930002

    Qui sont les personnes ayant un contrôle significatif sur WILLIAM ROBERTS (HAULAGE) LIMITED ?

    Personnes ayant un contrôle significatif
    NomNotifié leAdresseCessé
    Waste Hire Services Limited
    Stafford Park 1
    TF3 3BD Telford
    Kelsall House
    England
    06 avr. 2016
    Stafford Park 1
    TF3 3BD Telford
    Kelsall House
    England
    Non
    Forme juridiqueLimited Company
    Pays d'enregistrementEngland
    Autorité légaleCompanies Act 2006
    Lieu d'enregistrementCompanies House, Uk
    Numéro d'enregistrement3441128
    Nature du contrôle
    • La personne détient, directement ou indirectement, plus de 75 % des actions de la société.

    WILLIAM ROBERTS (HAULAGE) LIMITED a-t-elle des charges ?

    Charges
    ClassificationDatesStatutDétails
    A registered charge
    Créé le 20 août 2015
    Livré le 27 août 2015
    Totalement satisfaite
    Contient une promesse négative: Oui
    Contient une charge flottante: Oui
    Contient une charge fixe: Oui
    Personnes ayant droit
    • Barclays Bank PLC
    Transactions
    • 27 août 2015Enregistrement d'une charge (MR01)
    • 25 juil. 2016Satisfaction d'une charge (MR04)
    A supplemental common debenture
    Créé le 29 nov. 2011
    Livré le 08 déc. 2011
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from each obligor to any secured finance party on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    Personnes ayant droit
    • Barclays Bank PLC
    Transactions
    • 08 déc. 2011Enregistrement d'une charge (MG01)
    • 24 août 2015Satisfaction d'une charge (MR04)
    Deed of accession
    Créé le 18 mai 2007
    Livré le 25 mai 2007
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from each obligor to any secured finance party on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Barclays Bank PLC (Security Trustee)
    Transactions
    • 25 mai 2007Enregistrement d'une charge (395)
    • 24 août 2015Satisfaction d'une charge (MR04)
    Debenture
    Créé le 26 avr. 2005
    Livré le 11 mai 2005
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All present and future obligations and liabilities due or to become due from the company to the chargee in its capacity as security agent for the beneficiaries on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Cibc World Markets PLC
    Transactions
    • 11 mai 2005Enregistrement d'une charge (395)
    • 23 avr. 2007Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Debenture deed
    Créé le 04 déc. 1997
    Livré le 18 déc. 1997
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    All book debts and other debts. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Tsb Commercial Finance Limited
    Transactions
    • 18 déc. 1997Enregistrement d'une charge (395)
    • 05 mai 2005Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Debenture
    Créé le 26 juil. 1993
    Livré le 30 juil. 1993
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Fixed charge over the goodwill of the company.fixed charge over the property at whitelegge street,bury,lancashire BL8 1SW together with a floating charge over the undertaking and all property and assets including its uncalled capital.
    Personnes ayant droit
    • Mr Michael William Roberts
    Transactions
    • 30 juil. 1993Enregistrement d'une charge (395)
    • 17 janv. 1998Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Debenture
    Créé le 13 déc. 1991
    Livré le 23 déc. 1991
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    (See 395 for full details). Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personnes ayant droit
    • Barclays Bank PLC
    Transactions
    • 23 déc. 1991Enregistrement d'une charge (395)
    • 17 janv. 1998Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Legal charge
    Créé le 01 juin 1977
    Livré le 15 juin 1977
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    F/H land and buildings lying to the north east of bury greater manchester title no gm 35264.
    Personnes ayant droit
    • Barclays Bank PLC
    Transactions
    • 15 juin 1977Enregistrement d'une charge
    • 17 janv. 1998Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Legal charge
    Créé le 26 mai 1977
    Livré le 15 juin 1977
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Land in spring vale street tottington greater manchester title no gm 93602.
    Personnes ayant droit
    • Barclays Bank PLC
    Transactions
    • 15 juin 1977Enregistrement d'une charge
    • 17 janv. 1998Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Legal charge
    Créé le 26 mai 1977
    Livré le 15 juin 1977
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    F/H land and buildings lying to the north east of bury road tottington bury greater manchester title no GM35264.
    Personnes ayant droit
    • Barclays Bank PLC
    Transactions
    • 15 juin 1977Enregistrement d'une charge
    • 17 janv. 1998Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Legal charge
    Créé le 15 févr. 1977
    Livré le 22 févr. 1977
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Land & buildings in whitelegge st bury greater manchester.
    Personnes ayant droit
    • Barclays Bank PLC
    Transactions
    • 22 févr. 1977Enregistrement d'une charge
    • 17 janv. 1998Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Legal charge
    Créé le 21 mars 1975
    Livré le 26 mars 1975
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    11 whitelegge street bury greater manchester.
    Personnes ayant droit
    • Barclays Bank PLC
    Transactions
    • 26 mars 1975Enregistrement d'une charge
    • 17 janv. 1998Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Legal charge
    Créé le 21 mars 1975
    Livré le 26 mars 1975
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Land & buildings on north west side of whitelegge street bury greater manchester.
    Personnes ayant droit
    • Barclays Bank PLC
    Transactions
    • 26 mars 1975Enregistrement d'une charge
    • 17 janv. 1998Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)

    Source de données

    • Companies House du Royaume-Uni
      Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers.
    • Licence: CC0