NEWMOND (NUMBER 6) LIMITED

  • Vue d'ensemble
  • Résumé
  • Objet social
  • Adresse
  • Dénominations sociales précédentes
  • Comptes
  • Dépôts
  • Dirigeants
  • Charges
  • Source de données
  • Vue d'ensemble

    Nom de la sociétéNEWMOND (NUMBER 6) LIMITED
    Statut de la sociétéDissoute
    Forme juridiqueSociété à responsabilité limitée
    Numéro de société 00708062
    JuridictionAngleterre/Pays de Galles
    Date de création
    Date de cessation d'activité

    Résumé

    A des PSCs super sécurisésNon
    A des chargesOui
    A un historique d'insolvabilitéNon
    Le siège social est contestéNon

    Quel est l'objet de NEWMOND (NUMBER 6) LIMITED ?

    • (3162) /

    Où se situe NEWMOND (NUMBER 6) LIMITED ?

    Adresse du siège social
    Brooks House
    Coventry Road
    CV34 4LL Warwick
    Warwickshire
    Adresse du siège social non livrableNon

    Quels étaient les noms précédents de NEWMOND (NUMBER 6) LIMITED ?

    Dénominations sociales précédentes
    Nom de la sociétéDeJusqu'au
    HEATROD ELEMENTS LIMITED14 nov. 196114 nov. 1961

    Quels sont les derniers comptes de NEWMOND (NUMBER 6) LIMITED ?

    En retardOui
    Prochains comptes
    Fin de la prochaine période comptable le31 déc. 2011
    Date d'échéance des prochains comptes30 sept. 2012
    Derniers comptes
    Derniers comptes arrêtés au31 déc. 2010

    Quels sont les derniers dépôts pour NEWMOND (NUMBER 6) LIMITED ?

    Dépôts
    DateDescriptionDocumentType

    Bulletin officiel final dissous par radiation d'office

    1 pagesGAZ2

    Premier avis au Bulletin officiel pour la radiation d'office

    1 pagesGAZ1

    Restauration par ordonnance du tribunal

    3 pagesAC92

    Bulletin officiel final dissous par radiation volontaire

    1 pagesGAZ2(A)

    Premier avis au Bulletin officiel pour la radiation volontaire

    1 pagesGAZ1(A)

    Demande de radiation de la société du registre du commerce

    3 pagesDS01

    Comptes pour une société dormante établis au 31 déc. 2010

    1 pagesAA

    Déclaration annuelle jusqu'au 03 janv. 2011 avec liste complète des actionnaires

    5 pagesAR01
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    capital05 janv. 2011

    État du capital au 05 janv. 2011

    • Capital: GBP 100
    SH01

    Comptes pour une société dormante établis au 31 déc. 2009

    1 pagesAA

    Modification des coordonnées de l'administrateur John Mcfaull le 28 sept. 2010

    2 pagesCH01

    Modification des coordonnées de l'administrateur Mr Adrian Egerton Darling le 28 sept. 2010

    2 pagesCH01

    Modification des coordonnées du secrétaire Karen Roberts le 27 sept. 2010

    2 pagesCH03

    Changement d'adresse du siège social de * 16 Stanier Way Wyvern Business Park Derby Derbyshire DE21 6BF England* le 27 sept. 2010

    1 pagesAD01

    Déclaration annuelle jusqu'au 03 janv. 2010 avec liste complète des actionnaires

    5 pagesAR01

    Modification des coordonnées de l'administrateur Mr Adrian Egerton Darling le 13 janv. 2010

    2 pagesCH01

    Modification des coordonnées du secrétaire Karen Roberts le 13 janv. 2010

    1 pagesCH03

    Modification des coordonnées de l'administrateur John Mcfaull le 13 janv. 2010

    2 pagesCH01

    Comptes pour une société dormante établis au 31 déc. 2008

    1 pagesAA

    legacy

    3 pages363a

    Comptes pour une société dormante établis au 31 déc. 2007

    1 pagesAA

    legacy

    1 pages288b

    legacy

    1 pages288b

    legacy

    1 pages288b

    legacy

    2 pages288a

    legacy

    2 pages288a

    Qui sont les dirigeants de NEWMOND (NUMBER 6) LIMITED ?

    Dirigeants
    NomNommé leDate de démissionRôleAdresseIdentification de la sociétéPays de résidenceNationalitéDate de naissanceProfessionNuméro
    ROBERTS, Karen Dawn
    Coventry Road
    CV34 4LL Warwick
    Brooks House
    Warwickshire
    England
    Secrétaire
    Coventry Road
    CV34 4LL Warwick
    Brooks House
    Warwickshire
    England
    British126457090001
    DARLING, Adrian Egerton
    Coventry Road
    CV34 4LL Warwick
    Brooks House
    Warwickshire
    Administrateur
    Coventry Road
    CV34 4LL Warwick
    Brooks House
    Warwickshire
    United KingdomBritishGroup Finance Director13813980005
    MCFAULL, John
    Coventry Road
    CV34 4LL Warwick
    Brooks House
    Warwickshire
    England
    Administrateur
    Coventry Road
    CV34 4LL Warwick
    Brooks House
    Warwickshire
    England
    BritishFinancial Controller83628430003
    BOND, Sarah Caroline
    Hillside
    37 Rise End, Middleton
    DE4 4LS Wirksworth
    Derbyshire
    Secrétaire
    Hillside
    37 Rise End, Middleton
    DE4 4LS Wirksworth
    Derbyshire
    British90181180006
    CHAPMAN, Christopher John
    5 The Willows
    Walmley
    B76 2PX Sutton Coldfield
    West Midlands
    Secrétaire
    5 The Willows
    Walmley
    B76 2PX Sutton Coldfield
    West Midlands
    British50769680003
    LOWE, Tracey
    149 Smalley Drive
    Oakwood
    DE21 2SQ Derby
    Derbyshire
    Secrétaire
    149 Smalley Drive
    Oakwood
    DE21 2SQ Derby
    Derbyshire
    British86697030001
    PERKINS, Michael William
    38 Cubbington Road
    CV32 7AB Leamington Spa
    Warwickshire
    Secrétaire
    38 Cubbington Road
    CV32 7AB Leamington Spa
    Warwickshire
    British30958650001
    STRATTON, Malcolm
    Flat 40
    Manor Park Court, Uttoxeter New Road
    DE22 3NG Derby
    Derbyshire
    Secrétaire
    Flat 40
    Manor Park Court, Uttoxeter New Road
    DE22 3NG Derby
    Derbyshire
    British30601260018
    STRATTON, Malcolm
    White Rose Grange Hollington Road
    Stubwood
    ST14 5HY Uttoxeter
    Staffordshire
    Secrétaire
    White Rose Grange Hollington Road
    Stubwood
    ST14 5HY Uttoxeter
    Staffordshire
    British30601260002
    DAVIES, Michael Thomas
    11 The Rills
    LE10 1NA Hinckley
    Leicestershire
    Administrateur
    11 The Rills
    LE10 1NA Hinckley
    Leicestershire
    BritishManager50770000001
    EDWARDS, Mark John
    The Glen
    35 Hazelwood Road
    DE56 4DP Duffield
    Derby
    Administrateur
    The Glen
    35 Hazelwood Road
    DE56 4DP Duffield
    Derby
    United KingdomBritishChartered Accountant56562210001
    NASH, Robert Leslie
    12 Manor Fields Drive
    DE7 5FA Ilkeston
    Derbyshire
    Administrateur
    12 Manor Fields Drive
    DE7 5FA Ilkeston
    Derbyshire
    United KingdomBritishGroup Financial Controller83397580001
    PERKINS, Michael William
    38 Cubbington Road
    CV32 7AB Leamington Spa
    Warwickshire
    Administrateur
    38 Cubbington Road
    CV32 7AB Leamington Spa
    Warwickshire
    United KingdomBritishFinancial Director30958650001
    NEWMOND ADMINISTRATION LIMITED
    Wyvern Business Park
    Stanier Way
    DE21 6BF Derby
    Derbyshire
    Administrateur
    Wyvern Business Park
    Stanier Way
    DE21 6BF Derby
    Derbyshire
    57363930005
    NEWMOND ADMINISTRATION LIMITED
    Pentagon House
    Sir Frank Whittle Road
    DE21 4XA Derby
    Derbyshire
    Administrateur
    Pentagon House
    Sir Frank Whittle Road
    DE21 4XA Derby
    Derbyshire
    57363930002
    NEWMOND MANAGEMENT SERVICES LIMITED
    Wyvern Business Park
    Stanier Way
    DE21 6BF Derby
    Derbyshire
    Administrateur
    Wyvern Business Park
    Stanier Way
    DE21 6BF Derby
    Derbyshire
    57363780006
    NEWMOND MANAGEMENT SERVICES LIMITED
    Pentagon House
    Sir Frank Whittle Road
    DE21 4XA Derby
    Derbyshire
    Administrateur
    Pentagon House
    Sir Frank Whittle Road
    DE21 4XA Derby
    Derbyshire
    57363780002
    WESTMINSTER SECURITIES LIMITED
    Pentagon House
    Sir Frank Whittle Road
    DE21 4XA Derby
    Administrateur
    Pentagon House
    Sir Frank Whittle Road
    DE21 4XA Derby
    33480800001
    WILLIAMS MANAGEMENT SERVICES LIMITED
    Pentagon House
    Sir Frank Whittle Road
    DE21 4XA Derby
    Derbyshire
    Administrateur
    Pentagon House
    Sir Frank Whittle Road
    DE21 4XA Derby
    Derbyshire
    6125640001

    NEWMOND (NUMBER 6) LIMITED a-t-elle des charges ?

    Charges
    ClassificationDatesStatutDétails
    Guarantee and debenture made between the company and the royal bank of scotland PLC as agent and trustee for the secured parties (as defined) pursuant to the intercreditor agreement (as defined)
    Créé le 22 nov. 2000
    Livré le 08 déc. 2000
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    The actual contingent present and/or future obligations and liabilities of the company to any of the secured parties under or pursuant to all or any of the secured documents (as defined) including the guarantee and debenture
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personnes ayant droit
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transactions
    • 08 déc. 2000Enregistrement d'une charge (395)
    • 25 mars 2004Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Accession agreement relating to a debenture dated 4/12/96
    Créé le 31 déc. 1996
    Livré le 09 janv. 1997
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from each obligor (as defined) to the finance parties or any of them under each or any of the finance documents (as defined)
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Morgan Grenfell & Co. Limited,as Agent for the Chargors
    Transactions
    • 09 janv. 1997Enregistrement d'une charge (395)
    • 06 déc. 2000Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)

    Source de données

    • Companies House du Royaume-Uni
      Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers.
    • Licence: CC0