ESTATES & GENERAL DEVELOPMENTS LIMITED

ESTATES & GENERAL DEVELOPMENTS LIMITED

  • Vue d'ensemble
  • Résumé
  • Objet social
  • Adresse
  • Dénominations sociales précédentes
  • Comptes
  • Dépôts
  • Dirigeants
  • Charges
  • Insolvabilité
  • Source de données
  • Vue d'ensemble

    Nom de la sociétéESTATES & GENERAL DEVELOPMENTS LIMITED
    Statut de la sociétéDissoute
    Forme juridiqueSociété à responsabilité limitée
    Numéro de société 00712831
    JuridictionAngleterre/Pays de Galles
    Date de création
    Date de cessation d'activité

    Résumé

    A des PSCs super sécurisésNon
    A des chargesOui
    A un historique d'insolvabilitéOui
    Le siège social est contestéNon

    Quel est l'objet de ESTATES & GENERAL DEVELOPMENTS LIMITED ?

    • (7011) /
    • (7415) /

    Où se situe ESTATES & GENERAL DEVELOPMENTS LIMITED ?

    Adresse du siège social
    c/o BEGBIES TRAYNOR (CENTRAL) LLP
    31st Floor 40 Bank Street
    E14 5NR London
    Adresse du siège social non livrableNon

    Quels étaient les noms précédents de ESTATES & GENERAL DEVELOPMENTS LIMITED ?

    Dénominations sociales précédentes
    Nom de la sociétéDeJusqu'au
    E & G ESTATES LIMITED22 janv. 199022 janv. 1990
    ESTATES AND GENERAL DEVELOPMENTS LIMITED31 déc. 197831 déc. 1978
    S.E.E.DEVELOPMENTS(BEDFORD)LIMITED12 janv. 196212 janv. 1962

    Quels sont les derniers comptes de ESTATES & GENERAL DEVELOPMENTS LIMITED ?

    Derniers comptes
    Derniers comptes arrêtés au31 mars 2009

    Quels sont les derniers dépôts pour ESTATES & GENERAL DEVELOPMENTS LIMITED ?

    Dépôts
    DateDescriptionDocumentType

    Gazette finale dissoute à la suite d'une liquidation

    1 pagesGAZ2

    Retour de la réunion finale dans une liquidation volontaire des créanciers

    20 pagesLIQ14

    Résumé des recettes et paiements du récepteur jusqu'au 10 mars 2018

    2 pages3.6

    Déclaration des reçus et paiements des liquidateurs jusqu'à 20 janv. 2018

    22 pagesLIQ03

    Résumé des recettes et paiements du récepteur jusqu'au 10 sept. 2017

    2 pages3.6

    Cessation de la nomination de F & C Reit (Corporate Services) Limited en tant que secrétaire le 08 août 2017

    2 pagesTM02

    Résumé des recettes et paiements du récepteur jusqu'au 10 mars 2017

    2 pages3.6

    Déclaration des reçus et paiements des liquidateurs jusqu'à 20 janv. 2017

    19 pages4.68

    Résumé des recettes et paiements du récepteur jusqu'au 10 sept. 2016

    1 pages3.6

    Cessation de la nomination de Christopher George White en tant que directeur le 11 avr. 2016

    2 pagesTM01

    Résumé des recettes et paiements du récepteur jusqu'au 10 mars 2016

    2 pages3.6

    Déclaration des reçus et paiements des liquidateurs jusqu'à 20 janv. 2016

    19 pages4.68

    Résumé des recettes et paiements du récepteur jusqu'au 10 sept. 2015

    2 pages3.6

    Résumé des recettes et paiements du récepteur jusqu'au 10 mars 2015

    2 pages3.6

    Déclaration des reçus et paiements des liquidateurs jusqu'à 20 janv. 2015

    18 pages4.68

    Résumé des recettes et paiements du récepteur jusqu'au 10 sept. 2014

    3 pages3.6

    Changement d'adresse du siège social de C/O Begbies Traynor 32 Cornhill London EC3V 3BT England à C/O Begbies Traynor (Central) Llp 31St Floor 40 Bank Street London E14 5NR le 26 sept. 2014

    2 pagesAD01

    Nomination d'un administrateur judiciaire ou d'un gérant

    4 pagesRM01

    Avis de cessation d'activité en tant qu'administrateur judiciaire ou gérant

    4 pagesRM02

    Résumé des recettes et paiements du récepteur jusqu'au 10 mars 2014

    2 pages3.6

    Déclaration des reçus et paiements des liquidateurs jusqu'à 20 janv. 2014

    18 pages4.68

    Résumé des recettes et paiements du récepteur jusqu'au 10 mars 2013

    3 pages3.6

    Déclaration des reçus et paiements des liquidateurs jusqu'à 20 janv. 2013

    19 pages4.68

    Résumé des recettes et paiements du récepteur jusqu'au 10 sept. 2012

    3 pages3.6

    Résumé des recettes et paiements du récepteur jusqu'au 10 mars 2012

    3 pages3.6

    Qui sont les dirigeants de ESTATES & GENERAL DEVELOPMENTS LIMITED ?

    Dirigeants
    NomNommé leDate de démissionRôleAdresseIdentification de la sociétéPays de résidenceNationalitéDate de naissanceProfessionNuméro
    BENADY, Maurice Moses
    57/63 Line Wall Road
    Gibraltar
    Administrateur
    57/63 Line Wall Road
    Gibraltar
    GibraltarBritish69435160001
    TRAFALGAR OFFICERS LIMITED
    5 Wigmore Street
    W1U 1PB London
    3rd Floor
    Administrateur
    5 Wigmore Street
    W1U 1PB London
    3rd Floor
    Type d'identificationEEE
    Numéro d'enregistrement6745658
    135316290001
    HOLLAND, Philip John
    9 Royle Close
    Chalfont St. Peter
    SL9 0BA Buckinghamshire
    Secrétaire
    9 Royle Close
    Chalfont St. Peter
    SL9 0BA Buckinghamshire
    British74688330002
    ROBERTS, Geoffrey Michael
    Brenchley 8 Hamilton Road
    DA15 7HB Sidcup
    Kent
    Secrétaire
    Brenchley 8 Hamilton Road
    DA15 7HB Sidcup
    Kent
    British29217560001
    WHITE, Christine
    31 Denmark Street
    WD17 4YA Watford
    Hertfordshire
    Secrétaire
    31 Denmark Street
    WD17 4YA Watford
    Hertfordshire
    British74900200002
    F&C REIT (CORPORATE SERVICES) LIMITED
    5 Wigmore Street
    W1U 1PB London
    Secrétaire
    5 Wigmore Street
    W1U 1PB London
    Type d'identificationEEE
    Numéro d'enregistrement3143222
    79571870006
    BLOOMFIELD, David William
    Hillcroft
    The Drive Harefield Place
    UB10 8AQ Ickenham
    Middlesex
    Administrateur
    Hillcroft
    The Drive Harefield Place
    UB10 8AQ Ickenham
    Middlesex
    British7927670001
    CLEGG, Barry Stuart
    The Gate House
    18a Ducks Hill Road
    HA6 2NR Northwood
    Middlesex
    Administrateur
    The Gate House
    18a Ducks Hill Road
    HA6 2NR Northwood
    Middlesex
    United KingdomBritish11296610002
    CULL, David Geoffrey Maurice
    8 Centennial Court
    High Street
    WD3 1AW Rickmansworth
    Hertfordshire
    Administrateur
    8 Centennial Court
    High Street
    WD3 1AW Rickmansworth
    Hertfordshire
    British84076630001
    DOSSETT, Roger John
    Charlecote
    Harewood Road
    HP8 4UA Chalfont St Giles
    Buckinghamshire
    Administrateur
    Charlecote
    Harewood Road
    HP8 4UA Chalfont St Giles
    Buckinghamshire
    EnglandBritish116927100001
    HOLLAND, Philip John
    61 Badgers Gate
    LU6 2BF Dunstable
    Bedfordshire
    Administrateur
    61 Badgers Gate
    LU6 2BF Dunstable
    Bedfordshire
    EnglandBritish163838050001
    MALONE, Kenneth Daniel
    One Tree Cottage 18 Woodside Avenue
    HP9 1JJ Beaconsfield
    Buckinghamshire
    Administrateur
    One Tree Cottage 18 Woodside Avenue
    HP9 1JJ Beaconsfield
    Buckinghamshire
    British60687110001
    TAYLOR, Robert Patrick
    Lanreath Ditton Hill
    KT6 5EH Surbiton
    Surrey
    Administrateur
    Lanreath Ditton Hill
    KT6 5EH Surbiton
    Surrey
    EnglandBritish7862560003
    WHITE, Christopher George
    Line Wall Road
    Gibraltar
    57/63
    Gibraltar
    Administrateur
    Line Wall Road
    Gibraltar
    57/63
    Gibraltar
    GibraltarBritish80132540006
    REIT(CORPORATE DIRECTORS) LIMITED
    5 Wigmore Street
    W1U 1PB London
    Administrateur
    5 Wigmore Street
    W1U 1PB London
    74030120002

    ESTATES & GENERAL DEVELOPMENTS LIMITED a-t-elle des charges ?

    Charges
    ClassificationDatesStatutDétails
    Tenth supplemental trust deed
    Créé le 12 mai 2006
    Livré le 15 mai 2006
    En cours
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    Certain houses and shops bearing the numbers 17 and a half, 19 and 21 ''beresford street'' in the parish of st helier vingtaine de haut de la ville in the island of jersey by way of floating charge its undertaking and all its property and assets present and future wheresoever including any uncalled capital. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Capita Irg Trustees Limited
    Transactions
    • 15 mai 2006Enregistrement d'une charge (395)
    • 215 mars 2011Nomination d'un administrateur ou d'un gestionnaire (LQ01)
    • 210 juin 2014Avis de cessation d'exercer en tant qu'administrateur ou gestionnaire (RM02)
    • 210 juin 2014Nomination d'un administrateur ou d'un gestionnaire (RM01)
      • Numéro de dossier 2
    Debenture
    Créé le 15 sept. 2004
    Livré le 29 sept. 2004
    En cours
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the chargor to any finance party on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    By way of fixed charge the real property other than the real property listed in part ii of schedule 2 of the debenture; all plant and machinery etc. and all related property rights; all debts; all of its securities and intellectual property rights; all goodwill and uncalled capital; and the insurance policies and the insurance proceeds. By way of assignment the insurance policies and the insurance proceeds; all rental income; any guarantee of rental income contained in or relating to any lease document; any hedging arrangements; each managing agent agreement; and each building contract and all related property rights. By way of first floating charge (I) the whole of its assets present and future and (ii) the whole of its assets situated in scotland.. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Hypo Real Estate Bank International (The "Security Trustee")
    Transactions
    • 29 sept. 2004Enregistrement d'une charge (395)
    Supplemental debenture
    Créé le 24 août 1998
    Livré le 25 août 1998
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee as security trustee for the secured parties (as defined in the composite guarantee and mortgage debenture), the payment and discharge of which are the subject of covenants, undertakings, guarnatees, and agreements contained in the composite guarantee and mortgage debenture and the supplemental debenture
    Brèves mentions
    F/H hayle business park and land adjoining marsh lane hayle cornwall t/n-CL65486 and all property k/a bluebell estate acklam middlesborough cleveland being all that f/h land being 5 to 15A medina gardens 2 to 10A romanby gardens and 13 to 11A lowlane acklam t/n-CE70014 (see form 395 for full details of property charged).. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • National Westminster Bank PLC
    Transactions
    • 25 août 1998Enregistrement d'une charge (395)
    • 23 oct. 2003Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Legal charge
    Créé le 12 août 1992
    Livré le 24 août 1992
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from estates & general PLC and/or the company to the governor and company of the bank of scotland on any account whatsoever
    Brèves mentions
    F/H property k/a or being 1-12A hillel walk,7-21 otterburn gardens and other properties (see form 395 for full details).
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transactions
    • 24 août 1992Enregistrement d'une charge (395)
    • 10 mai 2004Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Legal charge
    Créé le 12 août 1992
    Livré le 17 août 1992
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company and by estates & general PLC to the governor and company of the bank of scotland
    Brèves mentions
    The f/h property k/a plots 87-94 (inclusive) 100 102 104 and 110-113 (inclusive) the croft water lane cornwall.
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transactions
    • 17 août 1992Enregistrement d'une charge (395)
    • 10 mai 2004Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Legal charge
    Créé le 12 août 1992
    Livré le 17 août 1992
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company and estates & general PLC to the chargee
    Brèves mentions
    The property k/a hayle industrial park and hayle retail park marsh lane hayle cornwall other than plots 3 9 15 and 16 hayle industrial park and an area of 7. 92 square metres.
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transactions
    • 17 août 1992Enregistrement d'une charge (395)
    • 10 mai 2004Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Guarantee and debenture
    Créé le 04 août 1992
    Livré le 19 août 1992
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to national westminster bank PLC as "security trustee" for itself and the secured parties (all as defined therein) and to the secured parties (all as defined therein)
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personnes ayant droit
    • National Westminster Bank PLC
    Transactions
    • 19 août 1992Enregistrement d'une charge (395)
    • 27 mars 2001Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Equitable mortgage
    Créé le 29 janv. 1992
    Livré le 04 févr. 1992
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from estates & general PLC to the chargee on anyaccount whatsoever
    Brèves mentions
    Freehold property at marsh lane,hayle,cornwall and k/a hayle ind' park & retail park see doc M284C for details.
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transactions
    • 04 févr. 1992Enregistrement d'une charge (395)
    • 10 mai 2004Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Equitable mortgage
    Créé le 29 janv. 1992
    Livré le 04 févr. 1992
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from estates & general PLC to the chargee on anyaccount whatsoever
    Brèves mentions
    F/H property k/a 1-12A hillel walk,7-21 otterburn gdns',and 2-30A samaria gdns',acklam,middlesborough.t/n CE70053 5-15A medina gdns',2-10A romanby gdns' & 3-11 low lane,acklam,middlesborough.t/n CR70014.
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transactions
    • 04 févr. 1992Enregistrement d'une charge (395)
    • 10 mai 2004Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Equitable mortgage
    Créé le 29 janv. 1992
    Livré le 04 févr. 1992
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from estates & general PLC to the chargee on anyaccount whatsoever
    Brèves mentions
    F/H land k/a plots 87-94,100,102,104,and 110-113 the croft,water lane,hayle,cornwall.
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transactions
    • 04 févr. 1992Enregistrement d'une charge (395)
    • 16 juil. 1998Déclaration que tout ou partie de la propriété d'une charge flottante a été libérée (403b)
    • 10 mai 2004Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Legal mortgage
    Créé le 24 déc. 1991
    Livré le 31 déc. 1991
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    F/H property k/a 53-56 bartholomew street, land at 1 st. Nicholas street and st. Michaels road, newbury, berkshire title nos. BK260821 and BK280608.
    Personnes ayant droit
    • Lloyds Bank PLC
    Transactions
    • 31 déc. 1991Enregistrement d'une charge (395)
    • 16 juil. 1998Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Legal mortgage
    Créé le 18 mars 1991
    Livré le 22 mars 1991
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All moneys due or to become due from estates & general PLC to the chargee on any account whatsoever.
    Brèves mentions
    16,18 and 20 bridge street, leatherhead and land adjoining 20 bridge street leatherhead and/or the proceeds of sale thereof t/n sy 336363, sy 485260, sy 357147 and sy 446734. floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Personnes ayant droit
    • National Westminster Bank PLC
    Transactions
    • 22 mars 1991Enregistrement d'une charge
    • 10 mai 2004Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Letter confirming deposit of deeds by way of equitable charge
    Créé le 26 juil. 1990
    Livré le 13 août 1990
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from estates and general PLC to the chargee
    Brèves mentions
    Prestwood house high wycombe.
    Personnes ayant droit
    • Midland Bank PLC
    Transactions
    • 13 août 1990Enregistrement d'une charge
    • 23 juin 1998Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Equitable charge
    Créé le 26 juil. 1988
    Livré le 27 juil. 1988
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from estates and general investments PLC to the chargee on any account whatsoever.
    Brèves mentions
    F/H property k/a ward house, corporation street and castle street, high wycombe.
    Personnes ayant droit
    • Midland Bank PLC
    Transactions
    • 27 juil. 1988Enregistrement d'une charge
    • 23 juin 1998Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Legal mortgage
    Créé le 22 janv. 1987
    Livré le 29 janv. 1987
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All moneys due or to become due from estates and general investments public limited company to the chargee on any account whatsoever.
    Brèves mentions
    F/H property k/a 54/56 high street alfreton derbyshire and the proceeds of sale thereof. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Personnes ayant droit
    • National Westminster Bank PLC
    Transactions
    • 29 janv. 1987Enregistrement d'une charge
    • 23 juin 1998Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Legal mortgage
    Créé le 10 nov. 1986
    Livré le 11 nov. 1983
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    F/H 14,20,22,24 & 26 south street, dorking in the district of mole valley, surrey title no sy 485678 and/or the proceeds of sale thereof. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Personnes ayant droit
    • National Westminster Bank PLC
    Transactions
    • 11 nov. 1983Enregistrement d'une charge
    • 23 juin 1998Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Mortgage
    Créé le 17 août 1984
    Livré le 31 août 1984
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    L/H property known as blocks a and b, second way avonmouth industrial estate, avonmouth title no av 90348 and av 90349 and the proceeds of sale thereof. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Personnes ayant droit
    • National Westminster Bank PLC
    Transactions
    • 31 août 1984Enregistrement d'une charge
    • 23 juin 1998Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Mortgage
    Créé le 17 août 1984
    Livré le 31 août 1984
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    F/H mccelland house, (formerly the power house) headstone lane, harrow. Title no ngl 248936 and/or the proceeds of sale thereof. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Personnes ayant droit
    • National Westminster Bank PLC
    Transactions
    • 31 août 1984Enregistrement d'une charge
    • 23 juin 1998Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Legal mortgage
    Créé le 13 juin 1983
    Livré le 28 juin 1983
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    F/H property k/a little horwood manor nr bletchley, bucks and/or the proceeds of sale thereof. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Personnes ayant droit
    • National Westminster Bank PLC
    Transactions
    • 28 juin 1983Enregistrement d'une charge
    Legal mortgage
    Créé le 27 mai 1983
    Livré le 06 juin 1983
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Second third, and fourth floors 18, 18A and 18B white lion street, norwich, norfolk.. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Personnes ayant droit
    • Allied Irish Investment Bank Limited
    Transactions
    • 06 juin 1983Enregistrement d'une charge
    • 23 juin 1998Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Legal mortgage
    Créé le 13 mai 1983
    Livré le 16 mai 1983
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Castle hotel, castle meadow, norwich, norfolk title no:- nk 42785. floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Personnes ayant droit
    • Allied Irish Investment Bank Limited
    Transactions
    • 16 mai 1983Enregistrement d'une charge
    • 23 juin 1998Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Legal charge
    Créé le 06 juil. 1981
    Livré le 28 mai 1982
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    F/H k/a brook way leatherhead surrey title nos sy 327047 and sy 357185.
    Personnes ayant droit
    • Lloyds Bank PLC
    Transactions
    • 28 mai 1982Enregistrement d'une charge
    • 23 juin 1998Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)

    ESTATES & GENERAL DEVELOPMENTS LIMITED a-t-elle des procédures d'insolvabilité ?

    Numéro de dossierDatesTypePraticiensAutre
    1
    DateType
    21 janv. 2011Commencement of winding up
    04 janv. 2019Dissolved on
    Creditors voluntary liquidation
    NomRôleAdresseNommé leCessé le
    Kirstie Jane Provan
    32 Cornhill
    EC3V 3BT London
    practitioner
    32 Cornhill
    EC3V 3BT London
    Mark Robert Fry
    Begbies Traynor Central Llp
    32 Cornhill
    EC3V 3BT London
    practitioner
    Begbies Traynor Central Llp
    32 Cornhill
    EC3V 3BT London
    2Receiver/Manager appointed
    NomRôleAdresseNommé leCessé le
    Nicholas Guy Edwards
    Deloitte Llp Po Box 810 66 Shoe Lane
    EC4A 3WA London
    receiver manager
    Deloitte Llp Po Box 810 66 Shoe Lane
    EC4A 3WA London
    Louise Mary Brittain
    Po Box 810 66 Shoe Lane
    EC4A 3WA London
    receiver manager
    Po Box 810 66 Shoe Lane
    EC4A 3WA London
    Lee Antony Manning
    Athene Place 66 Shoe Lane
    EC4A 3BQ London
    receiver manager
    Athene Place 66 Shoe Lane
    EC4A 3BQ London

    Source de données

    • Companies House du Royaume-Uni
      Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers.
    • Licence: CC0