GOWRINGS MOTOR HOLDINGS LIMITED

GOWRINGS MOTOR HOLDINGS LIMITED

  • Vue d'ensemble
  • Résumé
  • Objet social
  • Adresse
  • Dénominations sociales précédentes
  • Comptes
  • Dépôts
  • Dirigeants
  • Personnes ayant un contrôle significatif
  • Charges
  • Source de données
  • Vue d'ensemble

    Nom de la sociétéGOWRINGS MOTOR HOLDINGS LIMITED
    Statut de la sociétéDissoute
    Forme juridiqueSociété à responsabilité limitée
    Numéro de société 00716004
    JuridictionAngleterre/Pays de Galles
    Date de création
    Date de cessation d'activité

    Résumé

    A des PSCs super sécurisésNon
    A des chargesOui
    A un historique d'insolvabilitéNon
    Le siège social est contestéNon

    Quel est l'objet de GOWRINGS MOTOR HOLDINGS LIMITED ?

    • Société inactive (99999) / Activités des organisations et organismes extraterritoriaux

    Où se situe GOWRINGS MOTOR HOLDINGS LIMITED ?

    Adresse du siège social
    The Cedars
    2 High Street
    GU19 5AE Bagshot
    Surrey
    Adresse du siège social non livrableNon

    Quels étaient les noms précédents de GOWRINGS MOTOR HOLDINGS LIMITED ?

    Dénominations sociales précédentes
    Nom de la sociétéDeJusqu'au
    GOWRINGS OF WOKINGHAM LIMITED21 févr. 196221 févr. 1962

    Quels sont les derniers comptes de GOWRINGS MOTOR HOLDINGS LIMITED ?

    Derniers comptes
    Derniers comptes arrêtés au31 déc. 2017

    Quels sont les derniers dépôts pour GOWRINGS MOTOR HOLDINGS LIMITED ?

    Dépôts
    DateDescriptionDocumentType

    Bulletin officiel final dissous par radiation volontaire

    1 pagesGAZ2(A)

    Premier avis au Bulletin officiel pour la radiation volontaire

    1 pagesGAZ1(A)

    Demande de radiation de la société du registre du commerce

    3 pagesDS01
    A8EYPZHL

    legacy

    1 pagesSH20
    L8DGCR5F

    État du capital au 06 sept. 2019

    • Capital: GBP 2
    3 pagesSH19
    L8DGCR8J

    legacy

    1 pagesCAP-SS
    L8DGCR77

    Résolutions

    Resolutions
    2 pagesRESOLUTIONS
    Résolutions
    CatégorieDateDescriptionType
    capital

    Résolution de réduction du capital social émis

    RES06

    Cessation de la nomination de Michael James Gray en tant que secrétaire le 31 mai 2019

    1 pagesTM02
    X8AZB9MA

    Cessation de la nomination de Michael James Gray en tant que directeur le 31 mai 2019

    1 pagesTM01
    X8AZB9MY

    Comptes pour une société dormante établis au 31 déc. 2017

    5 pagesAA
    A7EF4BZM

    Déclaration de confirmation établie le 24 août 2018 sans mise à jour

    3 pagesCS01
    X7DQ3QGO

    Satisfaction de la charge 12 en totalité

    4 pagesMR04
    A6JXQCXC

    Comptes pour une société dormante établis au 31 déc. 2016

    5 pagesAA
    A6FD8XMA

    Déclaration de confirmation établie le 24 août 2017 avec mises à jour

    4 pagesCS01
    X6DUCNMX

    Comptes pour une société dormante établis au 31 déc. 2015

    5 pagesAA
    A5GH9KIR

    Déclaration de confirmation établie le 24 août 2016 avec mises à jour

    5 pagesCS01
    X5F2T32P

    Comptes pour une société dormante établis au 31 déc. 2014

    5 pagesAA
    A4GY6FPF

    Déclaration annuelle jusqu'au 24 août 2015 avec liste complète des actionnaires

    4 pagesAR01
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    capital18 sept. 2015

    État du capital au 18 sept. 2015

    • Capital: GBP 1,000,000
    SH01
    X4G8BI60

    Comptes pour une société dormante établis au 31 déc. 2013

    5 pagesAA
    A3H6D5UB

    Déclaration annuelle jusqu'au 24 août 2014 avec liste complète des actionnaires

    4 pagesAR01
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    capital19 sept. 2014

    État du capital au 19 sept. 2014

    • Capital: GBP 1,000,000
    SH01
    X3GPZVNT

    Modification des coordonnées du secrétaire Michael James Gray le 19 sept. 2014

    1 pagesCH03
    X3GPZVR5

    Modification des coordonnées de l'administrateur Michael James Gray le 19 sept. 2014

    2 pagesCH01
    X3GPZVRD

    Comptes pour une société dormante établis au 31 déc. 2012

    5 pagesAA
    A2HPODKW

    Déclaration annuelle jusqu'au 24 août 2013 avec liste complète des actionnaires

    6 pagesAR01
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    capital11 sept. 2013

    État du capital au 11 sept. 2013

    • Capital: GBP 1,000,000
    SH01
    X2GPV5A0

    Cessation de la nomination de Derek Coulson en tant que directeur

    1 pagesTM01
    X2GPV59S

    Qui sont les dirigeants de GOWRINGS MOTOR HOLDINGS LIMITED ?

    Dirigeants
    NomNommé leDate de démissionRôleAdresseIdentification de la sociétéPays de résidenceNationalitéDate de naissanceProfessionNuméro
    NADER-ZADEH, Taji
    The Cedars
    2 High Street
    GU19 5AE Bagshot
    Surrey
    Administrateur
    The Cedars
    2 High Street
    GU19 5AE Bagshot
    Surrey
    EnglandBritishDirector35056010004
    CHADWICK, Clive Frederick
    75 Gorselands
    Wash Common
    RG14 6PU Newbury
    Berkshire
    Secrétaire
    75 Gorselands
    Wash Common
    RG14 6PU Newbury
    Berkshire
    BritishChartered Accountant107091790001
    FOALE, Stephen John
    42 Holmbury Avenue
    RG45 6TQ Crowthorne
    Berkshire
    Secrétaire
    42 Holmbury Avenue
    RG45 6TQ Crowthorne
    Berkshire
    British37403500001
    GRAY, David Henry
    Whisper Wood House Whisper Wood
    Loudwater
    WD3 4JU Hertfordshire
    Secrétaire
    Whisper Wood House Whisper Wood
    Loudwater
    WD3 4JU Hertfordshire
    British6369250003
    GRAY, Michael James
    The Cedars
    2 High Street
    GU19 5AE Bagshot
    Surrey
    Secrétaire
    The Cedars
    2 High Street
    GU19 5AE Bagshot
    Surrey
    BritishFinance Director55978100001
    SMITH, Graham Charles
    Lawndale
    8 Hillfield Road
    SL9 0DX Chalfont St Peter
    Buckinghamshire
    Secrétaire
    Lawndale
    8 Hillfield Road
    SL9 0DX Chalfont St Peter
    Buckinghamshire
    BritishAccountant37978250001
    BARRANCE, Stephen Leonard
    Clarbert Cottage
    Water End
    HP14 3XQ Stokenchurch
    Buckinghamshire
    Administrateur
    Clarbert Cottage
    Water End
    HP14 3XQ Stokenchurch
    Buckinghamshire
    BritishCompany Director126821190001
    CHADWICK, Clive Frederick
    75 Gorselands
    Wash Common
    RG14 6PU Newbury
    Berkshire
    Administrateur
    75 Gorselands
    Wash Common
    RG14 6PU Newbury
    Berkshire
    BritishChartered Accountant107091790001
    COULSON, Derek William
    Fox Lea Hermitage Road
    Cold Ash
    RG18 9JH Newbury
    Berkshire
    Administrateur
    Fox Lea Hermitage Road
    Cold Ash
    RG18 9JH Newbury
    Berkshire
    EnglandBritishCompany Director30237250002
    FOWLES, John
    Burghclere Manor
    Old Burghclere
    RG20 9NS Newbury
    Berkshire
    Administrateur
    Burghclere Manor
    Old Burghclere
    RG20 9NS Newbury
    Berkshire
    BritishCompany Director12870040001
    GRAY, David Henry
    Whisper Wood House Whisper Wood
    Loudwater
    WD3 4JU Hertfordshire
    Administrateur
    Whisper Wood House Whisper Wood
    Loudwater
    WD3 4JU Hertfordshire
    BritishAccountant6369250003
    GRAY, Michael James
    The Cedars
    2 High Street
    GU19 5AE Bagshot
    Surrey
    Administrateur
    The Cedars
    2 High Street
    GU19 5AE Bagshot
    Surrey
    EnglandBritishFinance Director55978100001
    JACOBS, David
    Staddle Stones Copse Mead
    Woodley
    RG5 4RP Reading
    Berkshire
    Administrateur
    Staddle Stones Copse Mead
    Woodley
    RG5 4RP Reading
    Berkshire
    BritishCompany Director17211060001
    PRIOR, Malcolm David
    10 Irwin Road
    GU2 5PP Guildford
    Surrey
    Administrateur
    10 Irwin Road
    GU2 5PP Guildford
    Surrey
    BritishCompany Director30237260001

    Qui sont les personnes ayant un contrôle significatif sur GOWRINGS MOTOR HOLDINGS LIMITED ?

    Personnes ayant un contrôle significatif
    NomNotifié leAdresseCessé
    Caspian Uk Holdings Limited
    2 High Street
    GU19 5AE Bagshot
    The Cedars
    England
    06 avr. 2016
    2 High Street
    GU19 5AE Bagshot
    The Cedars
    England
    Non
    Forme juridiqueLimited Company
    Pays d'enregistrementEngland
    Autorité légaleCompanies Act 2006
    Lieu d'enregistrementEngland
    Numéro d'enregistrement00182180
    Nature du contrôle
    • La personne détient, directement ou indirectement, plus de 75 % des actions de la société.

    GOWRINGS MOTOR HOLDINGS LIMITED a-t-elle des charges ?

    Charges
    ClassificationDatesStatutDétails
    Debenture
    Créé le 24 mars 2005
    Livré le 30 mars 2005
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personnes ayant droit
    • National Westminster Bank PLC
    Transactions
    • 30 mars 2005Enregistrement d'une charge (395)
    • 25 nov. 2017Satisfaction d'une charge (MR04)
    Charge over bulk deposit & other receivables
    Créé le 07 mars 1994
    Livré le 09 mars 1994
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    All monies deposited from time to time by the company with ford credit europe PLC pursuant to the terms of a sale or return agreement dated 1 september 1992 and all other debts and claims falling due to the company by ford credit europe PLC under the dealer agreement or the sor.
    Personnes ayant droit
    • Ford Credit Europe PLC
    Transactions
    • 09 mars 1994Enregistrement d'une charge (395)
    • 28 mars 2001Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Debenture
    Créé le 23 févr. 1994
    Livré le 25 févr. 1994
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    All f/h & l/h property now or hereafter vested in the company; all stocks shares and other securities owned by the company; all book and other debts of the company; all the undertaking and other assets of the company (both present and future) including its goodwill and uncalled capital.
    Personnes ayant droit
    • Ford Credit Europe PLC
    Transactions
    • 25 févr. 1994Enregistrement d'une charge (395)
    • 06 avr. 2001Déclaration que tout ou partie de la propriété d'une charge flottante a été libérée (403b)
    • 21 mai 2004Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Charge on vehicle stocks
    Créé le 23 févr. 1994
    Livré le 25 févr. 1994
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    All new & used motor vehicles which are from time to time during the continuance of the said charge in the possession of the company or in respect of which the company is entitled to exercise its rights of possession, ownership or otherwise in whatsoever capacity. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Ford Credit Europe PLC
    Transactions
    • 25 févr. 1994Enregistrement d'une charge (395)
    • 21 mai 2004Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Fixed charge
    Créé le 13 juil. 1993
    Livré le 14 juil. 1993
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of an agreement of even date
    Brèves mentions
    The monies at the date hereof deposited with ford credit PLC pursuant to the terms of an agreement between the company and ford dated 1/9/92 together with any other monies which shall from time to time accrue. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • United Dominions Trust Limited
    Transactions
    • 14 juil. 1993Enregistrement d'une charge (395)
    • 28 mars 2001Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Debenture
    Créé le 24 avr. 1990
    Livré le 27 avr. 1990
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    See form 395 for full details.. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personnes ayant droit
    • United Dominions Trust Limited
    Transactions
    • 27 avr. 1990Enregistrement d'une charge
    • 28 mars 2001Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Legal charge
    Créé le 01 nov. 1983
    Livré le 02 nov. 1983
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Handpost corner garage, finchampstead rd., Wokingham, berkshire. Title no. BK62937.
    Personnes ayant droit
    • United Dominions & Trust Limited
    Transactions
    • 02 nov. 1983Enregistrement d'une charge
    • 28 mars 2001Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Mortgage
    Créé le 01 nov. 1983
    Livré le 02 nov. 1983
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee
    Brèves mentions
    All monies deposited with ford motor company limited pursuant to the terms of a sale or return agreement dated 10TH may 1982 together with any other monies due from ford motor company limited pursuant to the terms of the said agreement or any agreement replacing or amending the same.
    Personnes ayant droit
    • United Dominions & Trust Limited.
    Transactions
    • 02 nov. 1983Enregistrement d'une charge
    • 28 mars 2001Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Mortgage debenture
    Créé le 01 nov. 1983
    Livré le 02 nov. 1983
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee
    Brèves mentions
    All new and used motor vehicles, trailers & caravans owned by the company or in which the company has an interest and proceeds of sale deposits paid under consignments or other agreements to suppliess of new motor vehicles and trailers and caravans.
    Personnes ayant droit
    • United Dominions Trust Limited
    Transactions
    • 02 nov. 1983Enregistrement d'une charge
    • 20 déc. 1991Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Mortgage debenture
    Créé le 01 nov. 1983
    Livré le 02 nov. 1983
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee
    Brèves mentions
    All new and used motor vehicles, trailers & caravans owned by the company or in which the company has an interest and proceeds of sale, deposits paid under consignments or other agreements to suppliers of new motor vehicles and trailers and caravans.
    Personnes ayant droit
    • United Dominions Trust Limited
    Transactions
    • 02 nov. 1983Enregistrement d'une charge
    Legal charge
    Créé le 05 mars 1982
    Livré le 08 mars 1982
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    F/Hold land & buildings known as handpost corner garage, finchchampstead road, wokingham berks, title no:- bk 62937.
    Personnes ayant droit
    • Mercantile Credit Company Limited
    Transactions
    • 08 mars 1982Enregistrement d'une charge
    • 20 déc. 1991Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Legal charge
    Créé le 18 juil. 1980
    Livré le 25 juil. 1980
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    F/Hold handpost corner garage. Finchampstead road. Wokingham berkshire title no bk 62937.
    Personnes ayant droit
    • Barclays Bank PLC
    Transactions
    • 25 juil. 1980Enregistrement d'une charge

    Source de données

    • Companies House du Royaume-Uni
      Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers.
    • Licence: CC0