GOWRINGS MOTOR HOLDINGS LIMITED
Vue d'ensemble
Nom de la société | GOWRINGS MOTOR HOLDINGS LIMITED |
---|---|
Statut de la société | Dissoute |
Forme juridique | Société à responsabilité limitée |
Numéro de société | 00716004 |
Juridiction | Angleterre/Pays de Galles |
Date de création | |
Date de cessation d'activité |
Résumé
A des PSCs super sécurisés | Non |
---|---|
A des charges | Oui |
A un historique d'insolvabilité | Non |
Le siège social est contesté | Non |
Où se situe GOWRINGS MOTOR HOLDINGS LIMITED ?
Adresse du siège social | The Cedars 2 High Street GU19 5AE Bagshot Surrey |
---|---|
Adresse du siège social non livrable | Non |
Quels sont les derniers comptes de GOWRINGS MOTOR HOLDINGS LIMITED ?
Derniers comptes | |
---|---|
Derniers comptes arrêtés au | 31 déc. 2017 |
Quels sont les derniers dépôts pour GOWRINGS MOTOR HOLDINGS LIMITED ?
Date | Description | Document | Type | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bulletin officiel final dissous par radiation volontaire | 1 pages | GAZ2(A) | ||||||||||
Premier avis au Bulletin officiel pour la radiation volontaire | 1 pages | GAZ1(A) | ||||||||||
Demande de radiation de la société du registre du commerce | 3 pages | DS01 | ||||||||||
legacy | 1 pages | SH20 | ||||||||||
État du capital au 06 sept. 2019
| 3 pages | SH19 | ||||||||||
legacy | 1 pages | CAP-SS | ||||||||||
Résolutions Resolutions | 2 pages | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
Cessation de la nomination de Michael James Gray en tant que secrétaire le 31 mai 2019 | 1 pages | TM02 | ||||||||||
Cessation de la nomination de Michael James Gray en tant que directeur le 31 mai 2019 | 1 pages | TM01 | ||||||||||
Comptes pour une société dormante établis au 31 déc. 2017 | 5 pages | AA | ||||||||||
Déclaration de confirmation établie le 24 août 2018 sans mise à jour | 3 pages | CS01 | ||||||||||
Satisfaction de la charge 12 en totalité | 4 pages | MR04 | ||||||||||
Comptes pour une société dormante établis au 31 déc. 2016 | 5 pages | AA | ||||||||||
Déclaration de confirmation établie le 24 août 2017 avec mises à jour | 4 pages | CS01 | ||||||||||
Comptes pour une société dormante établis au 31 déc. 2015 | 5 pages | AA | ||||||||||
Déclaration de confirmation établie le 24 août 2016 avec mises à jour | 5 pages | CS01 | ||||||||||
Comptes pour une société dormante établis au 31 déc. 2014 | 5 pages | AA | ||||||||||
Déclaration annuelle jusqu'au 24 août 2015 avec liste complète des actionnaires | 4 pages | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Comptes pour une société dormante établis au 31 déc. 2013 | 5 pages | AA | ||||||||||
Déclaration annuelle jusqu'au 24 août 2014 avec liste complète des actionnaires | 4 pages | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Modification des coordonnées du secrétaire Michael James Gray le 19 sept. 2014 | 1 pages | CH03 | ||||||||||
Modification des coordonnées de l'administrateur Michael James Gray le 19 sept. 2014 | 2 pages | CH01 | ||||||||||
Comptes pour une société dormante établis au 31 déc. 2012 | 5 pages | AA | ||||||||||
Déclaration annuelle jusqu'au 24 août 2013 avec liste complète des actionnaires | 6 pages | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Cessation de la nomination de Derek Coulson en tant que directeur | 1 pages | TM01 | ||||||||||
Qui sont les dirigeants de GOWRINGS MOTOR HOLDINGS LIMITED ?
Nom | Nommé le | Date de démission | Rôle | Adresse | Identification de la société | Pays de résidence | Nationalité | Date de naissance | Profession | Numéro |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NADER-ZADEH, Taji | Administrateur | The Cedars 2 High Street GU19 5AE Bagshot Surrey | England | British | Director | 35056010004 | ||||
CHADWICK, Clive Frederick | Secrétaire | 75 Gorselands Wash Common RG14 6PU Newbury Berkshire | British | Chartered Accountant | 107091790001 | |||||
FOALE, Stephen John | Secrétaire | 42 Holmbury Avenue RG45 6TQ Crowthorne Berkshire | British | 37403500001 | ||||||
GRAY, David Henry | Secrétaire | Whisper Wood House Whisper Wood Loudwater WD3 4JU Hertfordshire | British | 6369250003 | ||||||
GRAY, Michael James | Secrétaire | The Cedars 2 High Street GU19 5AE Bagshot Surrey | British | Finance Director | 55978100001 | |||||
SMITH, Graham Charles | Secrétaire | Lawndale 8 Hillfield Road SL9 0DX Chalfont St Peter Buckinghamshire | British | Accountant | 37978250001 | |||||
BARRANCE, Stephen Leonard | Administrateur | Clarbert Cottage Water End HP14 3XQ Stokenchurch Buckinghamshire | British | Company Director | 126821190001 | |||||
CHADWICK, Clive Frederick | Administrateur | 75 Gorselands Wash Common RG14 6PU Newbury Berkshire | British | Chartered Accountant | 107091790001 | |||||
COULSON, Derek William | Administrateur | Fox Lea Hermitage Road Cold Ash RG18 9JH Newbury Berkshire | England | British | Company Director | 30237250002 | ||||
FOWLES, John | Administrateur | Burghclere Manor Old Burghclere RG20 9NS Newbury Berkshire | British | Company Director | 12870040001 | |||||
GRAY, David Henry | Administrateur | Whisper Wood House Whisper Wood Loudwater WD3 4JU Hertfordshire | British | Accountant | 6369250003 | |||||
GRAY, Michael James | Administrateur | The Cedars 2 High Street GU19 5AE Bagshot Surrey | England | British | Finance Director | 55978100001 | ||||
JACOBS, David | Administrateur | Staddle Stones Copse Mead Woodley RG5 4RP Reading Berkshire | British | Company Director | 17211060001 | |||||
PRIOR, Malcolm David | Administrateur | 10 Irwin Road GU2 5PP Guildford Surrey | British | Company Director | 30237260001 |
Qui sont les personnes ayant un contrôle significatif sur GOWRINGS MOTOR HOLDINGS LIMITED ?
Nom | Notifié le | Adresse | Cessé | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Caspian Uk Holdings Limited | 06 avr. 2016 | 2 High Street GU19 5AE Bagshot The Cedars England | Non | ||||||||||
| |||||||||||||
Nature du contrôle
|
GOWRINGS MOTOR HOLDINGS LIMITED a-t-elle des charges ?
Classification | Dates | Statut | Détails | |
---|---|---|---|---|
Debenture | Créé le 24 mars 2005 Livré le 30 mars 2005 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brèves mentions Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
Charge over bulk deposit & other receivables | Créé le 07 mars 1994 Livré le 09 mars 1994 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brèves mentions All monies deposited from time to time by the company with ford credit europe PLC pursuant to the terms of a sale or return agreement dated 1 september 1992 and all other debts and claims falling due to the company by ford credit europe PLC under the dealer agreement or the sor. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
Debenture | Créé le 23 févr. 1994 Livré le 25 févr. 1994 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brèves mentions All f/h & l/h property now or hereafter vested in the company; all stocks shares and other securities owned by the company; all book and other debts of the company; all the undertaking and other assets of the company (both present and future) including its goodwill and uncalled capital. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
Charge on vehicle stocks | Créé le 23 févr. 1994 Livré le 25 févr. 1994 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brèves mentions All new & used motor vehicles which are from time to time during the continuance of the said charge in the possession of the company or in respect of which the company is entitled to exercise its rights of possession, ownership or otherwise in whatsoever capacity. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
Fixed charge | Créé le 13 juil. 1993 Livré le 14 juil. 1993 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of an agreement of even date | |
Brèves mentions The monies at the date hereof deposited with ford credit PLC pursuant to the terms of an agreement between the company and ford dated 1/9/92 together with any other monies which shall from time to time accrue. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
Debenture | Créé le 24 avr. 1990 Livré le 27 avr. 1990 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brèves mentions See form 395 for full details.. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
Legal charge | Créé le 01 nov. 1983 Livré le 02 nov. 1983 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brèves mentions Handpost corner garage, finchampstead rd., Wokingham, berkshire. Title no. BK62937. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
Mortgage | Créé le 01 nov. 1983 Livré le 02 nov. 1983 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from the company to the chargee | |
Brèves mentions All monies deposited with ford motor company limited pursuant to the terms of a sale or return agreement dated 10TH may 1982 together with any other monies due from ford motor company limited pursuant to the terms of the said agreement or any agreement replacing or amending the same. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
Mortgage debenture | Créé le 01 nov. 1983 Livré le 02 nov. 1983 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from the company to the chargee | |
Brèves mentions All new and used motor vehicles, trailers & caravans owned by the company or in which the company has an interest and proceeds of sale deposits paid under consignments or other agreements to suppliess of new motor vehicles and trailers and caravans. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
Mortgage debenture | Créé le 01 nov. 1983 Livré le 02 nov. 1983 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from the company to the chargee | |
Brèves mentions All new and used motor vehicles, trailers & caravans owned by the company or in which the company has an interest and proceeds of sale, deposits paid under consignments or other agreements to suppliers of new motor vehicles and trailers and caravans. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
Legal charge | Créé le 05 mars 1982 Livré le 08 mars 1982 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brèves mentions F/Hold land & buildings known as handpost corner garage, finchchampstead road, wokingham berks, title no:- bk 62937. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
Legal charge | Créé le 18 juil. 1980 Livré le 25 juil. 1980 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brèves mentions F/Hold handpost corner garage. Finchampstead road. Wokingham berkshire title no bk 62937. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
|
Source de données
- Companies House du Royaume-Uni
Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers. - Licence: CC0