MOSBY INTERNATIONAL LIMITED

  • Vue d'ensemble
  • Résumé
  • Objet social
  • Adresse
  • Dénominations sociales précédentes
  • Comptes
  • Dépôts
  • Dirigeants
  • Personnes ayant un contrôle significatif
  • Charges
  • Source de données
  • Vue d'ensemble

    Nom de la sociétéMOSBY INTERNATIONAL LIMITED
    Statut de la sociétéDissoute
    Forme juridiqueSociété à responsabilité limitée
    Numéro de société 00723579
    JuridictionAngleterre/Pays de Galles
    Date de création
    Date de cessation d'activité

    Résumé

    A des PSCs super sécurisésNon
    A des chargesOui
    A un historique d'insolvabilitéNon
    Le siège social est contestéNon

    Quel est l'objet de MOSBY INTERNATIONAL LIMITED ?

    • Autres activités de soutien aux entreprises n.c.a. (82990) / Activités administratives et de soutien

    Où se situe MOSBY INTERNATIONAL LIMITED ?

    Adresse du siège social
    1-3 Strand
    London
    WC2N 5JR
    Adresse du siège social non livrableNon

    Quels étaient les noms précédents de MOSBY INTERNATIONAL LIMITED ?

    Dénominations sociales précédentes
    Nom de la sociétéDeJusqu'au
    TIMES MIRROR INTERNATIONAL PUBLISHERS LIMITED05 janv. 199405 janv. 1994
    MOSBY-YEAR BOOK EUROPE LIMITED16 mars 199216 mars 1992
    WOLFE PUBLISHING LIMITED09 mai 196209 mai 1962

    Quels sont les derniers comptes de MOSBY INTERNATIONAL LIMITED ?

    Derniers comptes
    Derniers comptes arrêtés au31 déc. 2017

    Quels sont les derniers dépôts pour MOSBY INTERNATIONAL LIMITED ?

    Dépôts
    DateDescriptionDocumentType

    Bulletin officiel final dissous par radiation volontaire

    1 pagesGAZ2(A)

    Cessation de la nomination de Alan William Mcculloch en tant que directeur le 30 août 2019

    1 pagesTM01

    Premier avis au Bulletin officiel pour la radiation volontaire

    1 pagesGAZ1(A)

    Demande de radiation de la société du registre du commerce

    3 pagesDS01

    Nomination de Mr Simon John Pereira en tant qu'administrateur le 01 août 2019

    2 pagesAP01

    Déclaration de confirmation établie le 14 juin 2019 avec mises à jour

    4 pagesCS01

    legacy

    1 pagesSH20

    État du capital au 21 nov. 2018

    • Capital: GBP 1
    3 pagesSH19

    legacy

    1 pagesCAP-SS

    Résolutions

    Resolutions
    2 pagesRESOLUTIONS
    Résolutions
    CatégorieDateDescriptionType
    capital

    Résolutions

    Reduction of share premium account 21/11/2018
    RES13
    capital

    Résolution de réduction du capital social émis

    RES06

    Déclaration de confirmation établie le 14 juin 2018 avec mises à jour

    4 pagesCS01

    Comptes annuels établis au 31 déc. 2017

    16 pagesAA

    Comptes annuels établis au 31 déc. 2016

    16 pagesAA

    Déclaration de confirmation établie le 14 juin 2017 avec mises à jour

    5 pagesCS01

    Cessation de la nomination de Re Directors (No 1) Limited en tant que directeur le 29 nov. 2016

    1 pagesTM01

    Cessation de la nomination de Re Directors No 2 Limited en tant que directeur le 29 nov. 2016

    1 pagesTM01

    Comptes annuels établis au 31 déc. 2015

    16 pagesAA

    Déclaration annuelle jusqu'au 14 juin 2016 avec liste complète des actionnaires

    6 pagesAR01
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    capital16 juin 2016

    État du capital au 16 juin 2016

    • Capital: GBP 13,050,000
    SH01

    Modification des coordonnées de l'administrateur Mr Alan William Mcculloch le 14 mars 2016

    2 pagesCH01

    Comptes annuels établis au 31 déc. 2014

    11 pagesAA

    Déclaration annuelle jusqu'au 28 juin 2015 avec liste complète des actionnaires

    6 pagesAR01
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    capital07 juil. 2015

    État du capital au 07 juil. 2015

    • Capital: GBP 13,050,000
    SH01

    Résolutions

    Resolutions
    RESOLUTIONS
    Résolutions
    CatégorieDateDescriptionType
    incorporation

    Résolution d'adoption des statuts

    RES01
    capital

    Résolution d'attribution de valeurs mobilières

    RES10
    capital

    Résolutions

    That the directors of the company be given powers pursuant to section 175 of the act 03/11/2014
    RES13

    Résolutions

    Resolutions
    RESOLUTIONS
    Résolutions
    CatégorieDateDescriptionType
    incorporation

    Résolution d'adoption des statuts

    RES01
    capital

    Résolution d'attribution de valeurs mobilières

    RES10
    capital

    Résolutions

    Section 175 03/11/2014
    RES13

    Comptes annuels établis au 31 déc. 2013

    10 pagesAA

    Déclaration annuelle jusqu'au 28 juin 2014 avec liste complète des actionnaires

    6 pagesAR01
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    capital11 juil. 2014

    État du capital au 11 juil. 2014

    • Capital: GBP 13,050,000
    SH01

    Qui sont les dirigeants de MOSBY INTERNATIONAL LIMITED ?

    Dirigeants
    NomNommé leDate de démissionRôleAdresseIdentification de la sociétéPays de résidenceNationalitéDate de naissanceProfessionNuméro
    RE SECRETARIES LIMITED
    1-3 Strand
    WC2N 5JR London
    Secrétaire
    1-3 Strand
    WC2N 5JR London
    Type d'identificationEEE
    Numéro d'enregistrement292732
    1327670012
    PEREIRA, Simon John
    Strand
    WC2N 5JR London
    1-3
    United Kingdom
    Administrateur
    Strand
    WC2N 5JR London
    1-3
    United Kingdom
    United KingdomBritishSolicitor261149560001
    UDOW, Henry Adam
    Strand
    WC2N 5JR London
    1-3
    United Kingdom
    Administrateur
    Strand
    WC2N 5JR London
    1-3
    United Kingdom
    United KingdomBritishChief Legal Officer125126820001
    BRUNGER, Harold George
    5 The Windings
    CR2 0HW Sanderstead
    Surrey
    Secrétaire
    5 The Windings
    CR2 0HW Sanderstead
    Surrey
    BritishAccountant158277610001
    HEILBRUNN, Peter Samuel
    6 Copperkins Grove
    HP6 5QD Amersham
    Buckinghamshire
    Secrétaire
    6 Copperkins Grove
    HP6 5QD Amersham
    Buckinghamshire
    British69196480001
    WARREN, Philip
    4 De Vere Close
    CM3 2LS Hatfield Peverel
    Essex
    Secrétaire
    4 De Vere Close
    CM3 2LS Hatfield Peverel
    Essex
    BritishFinance Director53134680002
    MAWLAW SECRETARIES LIMITED
    Black Friars Lane
    EC4V 6HD London
    20
    Secrétaire
    Black Friars Lane
    EC4V 6HD London
    20
    39182980001
    MITRE SECRETARIES LIMITED
    Mitre House
    160 Aldersgate Street
    EC1A 4DD London
    Secrétaire
    Mitre House
    160 Aldersgate Street
    EC1A 4DD London
    38565160001
    BLACK, Jonathan Piers
    37 Langdon Park Road
    N6 5PT London
    Administrateur
    37 Langdon Park Road
    N6 5PT London
    BritishFinance Director52219560001
    CAVE, Elizabeth Mary
    3 Albion Cottages
    Holmbury St.Mary
    RH5 6NH Dorking
    Surrey
    Administrateur
    3 Albion Cottages
    Holmbury St.Mary
    RH5 6NH Dorking
    Surrey
    BritishPm Director Publishing5707360002
    CLIFFORD, Patrick Antony
    780 Third Avenue
    New York
    New York 10017
    Usa
    Administrateur
    780 Third Avenue
    New York
    New York 10017
    Usa
    AmericanPublishing Executive33709850002
    COWDEN, Stephen John
    Strand
    WC2N 5JR London
    1-3
    United Kingdom
    Administrateur
    Strand
    WC2N 5JR London
    1-3
    United Kingdom
    BritishGeneral Counsel/Company Secretary510780002
    DIXON, Leslie
    Tonbridge Road
    Mereworth
    ME18 5JE Maidstone
    Belmont House
    Kent
    United Kingdom
    Administrateur
    Tonbridge Road
    Mereworth
    ME18 5JE Maidstone
    Belmont House
    Kent
    United Kingdom
    United KingdomBritishChartered Secretary830710002
    DOWNING, Kathryn M
    164 Roseville Road
    06880 Westport
    Ct
    Usa
    Administrateur
    164 Roseville Road
    06880 Westport
    Ct
    Usa
    AmericanChief Executive53134860001
    FOLEY, Fiona
    47 Linden Gardens
    Notting Hill Gate
    W2 4HQ London
    Administrateur
    47 Linden Gardens
    Notting Hill Gate
    W2 4HQ London
    BritishPublisher55471230001
    GIBSON, Christopher Alan
    5 Holly Park Road
    N11 3HA London
    Administrateur
    5 Holly Park Road
    N11 3HA London
    BritishCompany Director68203800001
    GREENWOOD, Geoffrey, Dr
    13 Whitchurch Close
    ME16 8UR Maidstone
    Kent
    Administrateur
    13 Whitchurch Close
    ME16 8UR Maidstone
    Kent
    BritishDirector85127650001
    HAILSTONE, Timothy Martin
    The White Cottage Ivy Bank
    Swannaton Road
    TQ6 9RL Dartmouth
    Devon
    Administrateur
    The White Cottage Ivy Bank
    Swannaton Road
    TQ6 9RL Dartmouth
    Devon
    United KingdomBritishBook Publisher62539790001
    HAILSTONE, Timothy Martin
    The White Cottage Ivy Bank
    Swannaton Road
    TQ6 9RL Dartmouth
    Devon
    Administrateur
    The White Cottage Ivy Bank
    Swannaton Road
    TQ6 9RL Dartmouth
    Devon
    United KingdomBritishBook Publisher62539790001
    HIRST, John
    Ling Point The Heath
    Cobbets Hill
    KT13 0UB Weybridge
    Surrey
    Administrateur
    Ling Point The Heath
    Cobbets Hill
    KT13 0UB Weybridge
    Surrey
    BritishPublishing36218630002
    HOENIGSBERG, Peter
    91 Tucker Farm Road
    North Andover
    Massachusetts
    01845
    Usa
    Administrateur
    91 Tucker Farm Road
    North Andover
    Massachusetts
    01845
    Usa
    Usa MassachusettsAmericanPublishing Executive64875500001
    HOLMAN, Derrick Stanley
    10 Eastmearn Road
    SE21 8HA London
    Administrateur
    10 Eastmearn Road
    SE21 8HA London
    EnglandBritishManaging Director99565490001
    HORNE, Simon Peter Barry
    28 Elmwood
    AL8 6LE Welwyn Garden City
    Hertfordshire
    Administrateur
    28 Elmwood
    AL8 6LE Welwyn Garden City
    Hertfordshire
    EnglandBritishChartered Accountant53516450002
    HOWE, Gavin Anthony
    The Boaters
    Park View Road, Woldingham
    CR3 7DN Caterham
    Surrey
    Administrateur
    The Boaters
    Park View Road, Woldingham
    CR3 7DN Caterham
    Surrey
    BritishCompany Director32964550003
    KNEZ, Brian Jon
    3 Tamarack Road
    Weston
    Massachusetts
    Usa 02193
    Administrateur
    3 Tamarack Road
    Weston
    Massachusetts
    Usa 02193
    AmericanExecutive60536830001
    LEVY, James Pierre
    65 Essex Road
    Chestnut Hill
    Massachusetts
    Ma 02467
    Usa
    Administrateur
    65 Essex Road
    Chestnut Hill
    Massachusetts
    Ma 02467
    Usa
    AmericanExecutive64875340001
    MACPHERSON, Colin Mackellar
    23 Belgrave Manor
    GU22 7TW Woking
    Surrey
    Administrateur
    23 Belgrave Manor
    GU22 7TW Woking
    Surrey
    BritishDirector16602780001
    MCCULLOCH, Alan William
    Strand
    WC2N 5JR London
    1-3
    United Kingdom
    Administrateur
    Strand
    WC2N 5JR London
    1-3
    United Kingdom
    United KingdomBritishChartered Secretary170986900001
    MOON, Anna Farley
    5 Five Mile Drive
    OX2 8HT Oxford
    Oxfordshire
    Administrateur
    5 Five Mile Drive
    OX2 8HT Oxford
    Oxfordshire
    United KingdomBritishPublishing57831040001
    REINES, Lewis
    1500 Locust Street
    Philadelphia Pennsylvania 19102
    FOREIGN Usa
    Administrateur
    1500 Locust Street
    Philadelphia Pennsylvania 19102
    FOREIGN Usa
    Us CitizenMedical Publisher34987970001
    SIDAYWAY, David Stephen
    12 Chauntry Road
    SL6 1TS Maidenhead
    Berkshire
    Administrateur
    12 Chauntry Road
    SL6 1TS Maidenhead
    Berkshire
    BritishM Director55100760001
    SMITH, Robert Alan
    35 Carisbrooke Road
    MA 02181 Wellesley
    Usa
    Administrateur
    35 Carisbrooke Road
    MA 02181 Wellesley
    Usa
    AmericanExecutive51764060001
    WEHNES, Jose Kelly
    Flat 4 35 Brompton Square
    SW3 2AE London
    Administrateur
    Flat 4 35 Brompton Square
    SW3 2AE London
    Us CitizenCompany Director68671390002
    WHITE, Nicholas Warren
    Zealys House
    St Marys Street
    SN15 3JW Chippenham
    Wiltshire
    Administrateur
    Zealys House
    St Marys Street
    SN15 3JW Chippenham
    Wiltshire
    BritishFinance & Operations Director46393840002
    RE DIRECTORS (NO 1) LIMITED
    1-3 Strand
    WC2N 5JR London
    Administrateur
    1-3 Strand
    WC2N 5JR London
    Type d'identificationEEE
    Numéro d'enregistrement292732
    48459750008

    Qui sont les personnes ayant un contrôle significatif sur MOSBY INTERNATIONAL LIMITED ?

    Personnes ayant un contrôle significatif
    NomNotifié leAdresseCessé
    Elsevier Inc.
    Park Avenue
    7th Floor
    NY 10169 New York
    230
    United States
    13 juin 2017
    Park Avenue
    7th Floor
    NY 10169 New York
    230
    United States
    Non
    Forme juridiqueCorporation
    Pays d'enregistrementDelaware
    Autorité légaleDelaware General Corporation Law
    Lieu d'enregistrementDelaware Division Of Corporations
    Numéro d'enregistrement13-1958712
    Nature du contrôle
    • La personne détient, directement ou indirectement, plus de 75 % des actions de la société.
    • La personne détient, directement ou indirectement, plus de 75 % des droits de vote dans la société.

    MOSBY INTERNATIONAL LIMITED a-t-elle des charges ?

    Charges
    ClassificationDatesStatutDétails
    Agreement
    Créé le 24 juil. 1987
    Livré le 27 juil. 1987
    En cours
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee pursuant to a sub-under lease dated 20/3/79
    Brèves mentions
    The sum of £30,000 (together with any reduction thereof or increase therein) held by the landlord on deposit in a separate designated account at the bank of scotland (or at such other bank as shall from time to time be the land lords clearing bank) becin a london clearing bank in the name of landlord and the tenant.
    Personnes ayant droit
    • W J Worth
    • K S Beecroft
    • M a B Jenks
    • P J Carpenter
    Transactions
    • 27 juil. 1987Enregistrement d'une charge
    Legal charge
    Créé le 23 sept. 1983
    Livré le 30 sept. 1983
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Freehold property k/a 3 and 5 conway street, london W1, and/or the proceeds of sale thereof. Title no: ngl 333745.
    Personnes ayant droit
    • Midland Bank PLC
    Transactions
    • 30 sept. 1983Enregistrement d'une charge
    Fixed and floating charge
    Créé le 26 sept. 1980
    Livré le 07 oct. 1980
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    First fixed charge on all book debts and other debts rols and from time to time due owing or incurred to the company. A floating charge over the undertaking and all property and assets present and future including bookdebts (excluding those mentioned above) uncalled capital. (See doc M37 for details).
    Personnes ayant droit
    • Midland Bank LTD
    Transactions
    • 07 oct. 1980Enregistrement d'une charge

    Source de données

    • Companies House du Royaume-Uni
      Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers.
    • Licence: CC0