WILLIAM WILSON (RUGBY) LIMITED

WILLIAM WILSON (RUGBY) LIMITED

  • Vue d'ensemble
  • Résumé
  • Objet social
  • Adresse
  • Dénominations sociales précédentes
  • Comptes
  • Dépôts
  • Dirigeants
  • Personnes ayant un contrôle significatif
  • Charges
  • Source de données
  • Vue d'ensemble

    Nom de la sociétéWILLIAM WILSON (RUGBY) LIMITED
    Statut de la sociétéDissoute
    Forme juridiqueSociété à responsabilité limitée
    Numéro de société 00726296
    JuridictionAngleterre/Pays de Galles
    Date de création
    Date de cessation d'activité

    Résumé

    A des PSCs super sécurisésNon
    A des chargesOui
    A un historique d'insolvabilitéNon
    Le siège social est contestéNon

    Quel est l'objet de WILLIAM WILSON (RUGBY) LIMITED ?

    • Société inactive (99999) / Activités des organisations et organismes extraterritoriaux

    Où se situe WILLIAM WILSON (RUGBY) LIMITED ?

    Adresse du siège social
    2 Kingmaker Court, Warwick Technology Park
    Gallows Hill
    CV34 6DY Warwick
    Warwickshire
    United Kingdom
    Adresse du siège social non livrableNon

    Quels étaient les noms précédents de WILLIAM WILSON (RUGBY) LIMITED ?

    Dénominations sociales précédentes
    Nom de la sociétéDeJusqu'au
    PROFESSIONAL DISTRIBUTION SERVICES (U.K.) LIMITED15 août 198615 août 1986
    ALFRED ALCOCK AND SON LIMITED05 juin 196205 juin 1962

    Quels sont les derniers comptes de WILLIAM WILSON (RUGBY) LIMITED ?

    Derniers comptes
    Derniers comptes arrêtés au31 juil. 2021

    Quels sont les derniers dépôts pour WILLIAM WILSON (RUGBY) LIMITED ?

    Dépôts
    DateDescriptionDocumentType

    Bulletin officiel final dissous par radiation volontaire

    1 pagesGAZ2(A)

    Premier avis au Bulletin officiel pour la radiation volontaire

    1 pagesGAZ1(A)

    Demande de radiation de la société du registre du commerce

    3 pagesDS01

    Modification des coordonnées de l'administrateur Wolseley Uk Directors Limited le 04 févr. 2022

    1 pagesCH02

    Déclaration de confirmation établie le 22 avr. 2022 sans mise à jour

    3 pagesCS01

    Comptes pour une société dormante établis au 31 juil. 2021

    5 pagesAA

    Déclaration de confirmation établie le 26 avr. 2021 sans mise à jour

    3 pagesCS01

    Nomination de Mr Simon Gray en tant qu'administrateur le 04 déc. 2020

    2 pagesAP01

    Cessation de la nomination de Andrew James Frederick Burton en tant que directeur le 04 déc. 2020

    1 pagesTM01

    Cessation de la nomination de Katherine Mary Mccormick en tant que secrétaire le 04 déc. 2020

    1 pagesTM02

    Nomination de Mr Nicky Paul Randle en tant que secrétaire le 04 déc. 2020

    2 pagesAP03

    Cessation de la nomination de Wolseley Directors Limited en tant que directeur le 04 déc. 2020

    1 pagesTM01

    Nomination de Wolseley Uk Directors Limited en tant qu'administrateur le 04 déc. 2020

    2 pagesAP02

    Changement d'adresse du siège social de 1020 Eskdale Road, Winnersh Triangle Wokingham Berkshire RG41 5TS United Kingdom à 2 Kingmaker Court, Warwick Technology Park Gallows Hill Warwick Warwickshire CV34 6DY le 04 déc. 2020

    1 pagesAD01

    Comptes pour une société dormante établis au 31 juil. 2020

    5 pagesAA

    Comptes pour une société dormante établis au 31 juil. 2019

    5 pagesAA

    Déclaration de confirmation établie le 20 mars 2020 sans mise à jour

    3 pagesCS01

    Déclaration de confirmation établie le 20 juin 2019 sans mise à jour

    3 pagesCS01

    Comptes pour une société dormante établis au 31 juil. 2018

    5 pagesAA

    Modification des détails de Sellers of Leeds Limited en tant que personne disposant d'un contrôle significatif le 03 déc. 2018

    2 pagesPSC05

    Déclaration de confirmation établie le 20 juin 2018 sans mise à jour

    3 pagesCS01

    Modification des coordonnées du secrétaire Katherine Mary Mccormick le 18 déc. 2017

    1 pagesCH03

    Changement d'adresse du siège social de Parkview 1220 Arlington Business Park Theale Reading RG7 4GA à 1020 Eskdale Road, Winnersh Triangle Wokingham Berkshire RG41 5TS le 20 déc. 2017

    1 pagesAD01

    Modification des coordonnées de l'administrateur Wolseley Directors Limited le 18 déc. 2017

    1 pagesCH02

    Comptes pour une société dormante établis au 31 juil. 2017

    5 pagesAA

    Qui sont les dirigeants de WILLIAM WILSON (RUGBY) LIMITED ?

    Dirigeants
    NomNommé leDate de démissionRôleAdresseIdentification de la sociétéPays de résidenceNationalitéDate de naissanceProfessionNuméro
    RANDLE, Nicky Paul
    Kingmaker Court, Warwick Technology Park
    Gallows Hill
    CV34 6DY Warwick
    2
    Warwickshire
    United Kingdom
    Secrétaire
    Kingmaker Court, Warwick Technology Park
    Gallows Hill
    CV34 6DY Warwick
    2
    Warwickshire
    United Kingdom
    277742880001
    GRAY, Simon
    Kingmaker Court, Warwick Technology Park
    Gallows Hill
    CV34 6DY Warwick
    2
    Warwickshire
    United Kingdom
    Administrateur
    Kingmaker Court, Warwick Technology Park
    Gallows Hill
    CV34 6DY Warwick
    2
    Warwickshire
    United Kingdom
    United KingdomBritish261668290001
    WOLSELEY DIRECTORS LIMITED
    Kingmaker Court, Warwick Technology Park
    Gallows Hill
    CV34 6DY Warwick
    2
    Warwickshire
    United Kingdom
    Administrateur
    Kingmaker Court, Warwick Technology Park
    Gallows Hill
    CV34 6DY Warwick
    2
    Warwickshire
    United Kingdom
    Type d'identificationSociété à responsabilité limitée du Royaume-Uni
    Numéro d'enregistrement09104902
    190186170013
    BROPHY, Tom
    Arlington Business Park
    Theale
    RG7 4GA Reading
    Parkview 1220
    Secrétaire
    Arlington Business Park
    Theale
    RG7 4GA Reading
    Parkview 1220
    162271760001
    DREW, Alison
    Elizabeth Close
    RG12 9SY Bracknell
    40
    Berkshire
    Secrétaire
    Elizabeth Close
    RG12 9SY Bracknell
    40
    Berkshire
    British129755940001
    MCCORMICK, Katherine Mary
    Kingmaker Court, Warwick Technology Park
    Gallows Hill
    CV34 6DY Warwick
    2
    Warwickshire
    United Kingdom
    Secrétaire
    Kingmaker Court, Warwick Technology Park
    Gallows Hill
    CV34 6DY Warwick
    2
    Warwickshire
    United Kingdom
    199908050001
    MIDDLEMISS, Graham
    Arlington Business Park
    Theale
    RG7 4GA Reading
    Parkview 1220
    United Kingdom
    Secrétaire
    Arlington Business Park
    Theale
    RG7 4GA Reading
    Parkview 1220
    United Kingdom
    174236340001
    MIDDLEMISS, Graham
    20 Spindle Lane
    Dickens Heath
    B90 1RP Solihull
    West Midlands
    Secrétaire
    20 Spindle Lane
    Dickens Heath
    B90 1RP Solihull
    West Midlands
    British100701940002
    NICOL, Grant Joss
    Amograil 14 Gurney Street
    AB3 2EB Stonehaven
    Kincardineshire
    Secrétaire
    Amograil 14 Gurney Street
    AB3 2EB Stonehaven
    Kincardineshire
    British66910001
    PALMER, Peter Edward
    Hill Top Farm
    Asenby
    YO7 3QN Thirsk
    North Yorkshire
    Secrétaire
    Hill Top Farm
    Asenby
    YO7 3QN Thirsk
    North Yorkshire
    British21105820001
    SKIDMORE, Robert William
    10 Bayview Road
    AB15 4EY Aberdeen
    Secrétaire
    10 Bayview Road
    AB15 4EY Aberdeen
    British40531180003
    BARDEN, Adrian
    Pearl House, 35 Pearce Avenue
    Lilliput
    BH14 8EG Poole
    Dorset
    Administrateur
    Pearl House, 35 Pearce Avenue
    Lilliput
    BH14 8EG Poole
    Dorset
    EnglandBritish66429950005
    BISSET, Robert Angus
    4 Gullymoss Gardens
    AB32 6NF Westhill
    Aberdeenshire
    Administrateur
    4 Gullymoss Gardens
    AB32 6NF Westhill
    Aberdeenshire
    British64973780001
    BISSET, Robert Angus
    4 Gullymoss Gardens
    AB32 6NF Westhill
    Aberdeenshire
    Administrateur
    4 Gullymoss Gardens
    AB32 6NF Westhill
    Aberdeenshire
    British64973780001
    BURTON, Andrew James Frederick
    Kingmaker Court, Warwick Technology Park
    Gallows Hill
    CV34 6DY Warwick
    2
    Warwickshire
    United Kingdom
    Administrateur
    Kingmaker Court, Warwick Technology Park
    Gallows Hill
    CV34 6DY Warwick
    2
    Warwickshire
    United Kingdom
    United KingdomBritish219597740001
    CHEADLE, William John
    Belmont Villa Holymoor Road
    Holymoorside
    S42 7DS Chesterfield
    Derbyshire
    Administrateur
    Belmont Villa Holymoor Road
    Holymoorside
    S42 7DS Chesterfield
    Derbyshire
    British21105830001
    CRAIG, Frederick John Robert
    Gateside
    KY14 7SX Cupar
    Freeland
    Fife
    United Kingdom
    Administrateur
    Gateside
    KY14 7SX Cupar
    Freeland
    Fife
    United Kingdom
    ScotlandBritish133316040001
    MCCLELLAND, John Graham
    18 Falconers Green
    Westbrook
    WA5 5XD Warrington
    Cheshire
    Administrateur
    18 Falconers Green
    Westbrook
    WA5 5XD Warrington
    Cheshire
    EnglandBritish28017330001
    NEVILLE, Matthew James
    9 The Brickall
    Long Marston
    CV37 8QL Stratford Upon Avon
    Warwickshire
    Administrateur
    9 The Brickall
    Long Marston
    CV37 8QL Stratford Upon Avon
    Warwickshire
    EnglandBritish85093360003
    NICOL, Grant Joss
    Amograil 14 Gurney Street
    AB3 2EB Stonehaven
    Kincardineshire
    Administrateur
    Amograil 14 Gurney Street
    AB3 2EB Stonehaven
    Kincardineshire
    British66910001
    PALMER, Peter Edward
    Hill Top Farm
    Asenby
    YO7 3QN Thirsk
    North Yorkshire
    Administrateur
    Hill Top Farm
    Asenby
    YO7 3QN Thirsk
    North Yorkshire
    EnglandBritish21105820001
    SKIDMORE, Robert William
    10 Bayview Road
    AB15 4EY Aberdeen
    Administrateur
    10 Bayview Road
    AB15 4EY Aberdeen
    ScotlandBritish40531180003
    SMITH, Robert Andrew Ross
    Arlington Business Park
    Theale
    RG7 4GA Reading
    Parkview 1220
    United Kingdom
    Administrateur
    Arlington Business Park
    Theale
    RG7 4GA Reading
    Parkview 1220
    United Kingdom
    United KingdomBritish150753930001
    TILLOTSON, Ian
    The Ashes
    16 Hughes Hill
    CV35 7AS Shrewley
    Warwickshire
    Administrateur
    The Ashes
    16 Hughes Hill
    CV35 7AS Shrewley
    Warwickshire
    United KingdomBritish109050510001
    WEBSTER, Stephen Paul
    Arlington Business Park
    Theale
    RG7 4GA Reading
    Parkview 1220
    Administrateur
    Arlington Business Park
    Theale
    RG7 4GA Reading
    Parkview 1220
    United KingdomBritish40201730005
    WOLSELEY DIRECTORS LIMITED
    Eskdale Road, Winnersh Triangle
    Wokingham
    RG41 5TS Berkshire
    1020
    United Kingdom
    Administrateur
    Eskdale Road, Winnersh Triangle
    Wokingham
    RG41 5TS Berkshire
    1020
    United Kingdom
    122185200001

    Qui sont les personnes ayant un contrôle significatif sur WILLIAM WILSON (RUGBY) LIMITED ?

    Personnes ayant un contrôle significatif
    NomNotifié leAdresseCessé
    Kingmaker Court, Warwick Technology Park
    Gallows Hill
    CV34 6DY Warwick
    2
    Warwickshire
    United Kingdom
    06 avr. 2016
    Kingmaker Court, Warwick Technology Park
    Gallows Hill
    CV34 6DY Warwick
    2
    Warwickshire
    United Kingdom
    Non
    Forme juridiqueLimited By Shares
    Pays d'enregistrementEngland And Wales
    Autorité légaleUnited Kingdom (England And Wales)
    Lieu d'enregistrementCompanies House
    Numéro d'enregistrement1032436
    Nature du contrôle
    • La personne détient, directement ou indirectement, plus de 75 % des actions de la société.
    • La personne détient, directement ou indirectement, plus de 75 % des droits de vote dans la société.
    • La personne détient, directement ou indirectement, le droit de nommer ou de révoquer une majorité des membres du conseil d'administration de la société.

    WILLIAM WILSON (RUGBY) LIMITED a-t-elle des charges ?

    Charges
    ClassificationDatesStatutDétails
    Debenture
    Créé le 01 mars 1988
    Livré le 17 mars 1988
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transactions
    • 17 mars 1988Enregistrement d'une charge
    • 08 nov. 2005Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Fixed and floating charge
    Créé le 21 mars 1986
    Livré le 04 avr. 1986
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Fixed & floating charge over undertaking and all property and assets present and future including book debts & uncalled capital.
    Personnes ayant droit
    • Clydesdale Bank Public Limited Company
    Transactions
    • 04 avr. 1986Enregistrement d'une charge
    Collateral debenture
    Créé le 19 mars 1986
    Livré le 02 avr. 1986
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from sellers of leeds limited to the chargee on any account whatsoever.
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personnes ayant droit
    • Investors in Industry
    Transactions
    • 02 avr. 1986Enregistrement d'une charge
    • 08 nov. 2005Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Charge
    Créé le 01 nov. 1983
    Livré le 07 nov. 1983
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    All book debts and other debts owing to the company.
    Personnes ayant droit
    • Midland Bank PLC
    Transactions
    • 07 nov. 1983Enregistrement d'une charge

    Source de données

    • Companies House du Royaume-Uni
      Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers.
    • Licence: CC0