CARILLION UTILITY SERVICES LIMITED
Vue d'ensemble
| Nom de la société | CARILLION UTILITY SERVICES LIMITED |
|---|---|
| Statut de la société | Liquidation |
| Forme juridique | Société à responsabilité limitée |
| Numéro de société | 00728599 |
| Juridiction | Angleterre/Pays de Galles |
| Date de création |
Résumé
| A des PSCs super sécurisés | Non |
|---|---|
| A des charges | Oui |
| A un historique d'insolvabilité | Oui |
| Le siège social est contesté | Non |
Où se situe CARILLION UTILITY SERVICES LIMITED ?
| Adresse du siège social | PWC 8th Floor Central Square 29 Wellington Street LS1 4DL Leeds West Yorkshire |
|---|---|
| Adresse du siège social non livrable | Non |
Quels sont les derniers comptes de CARILLION UTILITY SERVICES LIMITED ?
| En retard | Oui |
|---|---|
| Prochains comptes | |
| Fin de la prochaine période comptable le | 31 déc. 2017 |
| Date d'échéance des prochains comptes | 30 sept. 2018 |
| Derniers comptes | |
| Derniers comptes arrêtés au | 31 déc. 2016 |
Quel est le statut de la dernière déclaration de confirmation pour CARILLION UTILITY SERVICES LIMITED ?
| En retard | Oui |
|---|---|
| Dernière déclaration de confirmation établie jusqu'au | 17 mai 2018 |
| Date d'échéance de la prochaine déclaration de confirmation | 31 mai 2018 |
| Dernière déclaration de confirmation | |
| Prochaine déclaration de confirmation établie jusqu'au | 17 mai 2017 |
| En retard | Oui |
Quels sont les derniers dépôts pour CARILLION UTILITY SERVICES LIMITED ?
| Date | Description | Document | Type | |
|---|---|---|---|---|
Changement d'adresse du siège social de Crown House Birch Street Wolverhampton WV1 4JX United Kingdom à 8th Floor Central Square 29 Wellington Street Leeds West Yorkshire LS1 4DL le 22 juil. 2019 | 2 pages | AD01 | ||
Changement d'adresse du siège social de Carillion House 84 Salop Street Wolverhampton WV3 0SR à Crown House Birch Street Wolverhampton WV1 4JX le 01 oct. 2018 | 1 pages | AD01 | ||
Modification des détails de Carillion Utility Services Group Limited en tant que personne disposant d'un contrôle significatif le 01 oct. 2018 | 2 pages | PSC05 | ||
Cessation de la nomination de Richard Francis Tapp en tant que secrétaire le 25 juin 2018 | 1 pages | TM02 | ||
Cessation de la nomination de Lee James Mills en tant que directeur le 18 juin 2018 | 1 pages | TM01 | ||
Cessation de la nomination de Westley Maffei en tant que secrétaire le 04 juin 2018 | 1 pages | TM02 | ||
Cessation de la nomination de Daniel Easthope en tant que directeur le 30 mai 2018 | 1 pages | TM01 | ||
Ordonnance du tribunal pour liquider | 3 pages | COCOMP | ||
Cessation de la nomination de Richard John Howson en tant que directeur le 15 janv. 2018 | 1 pages | TM01 | ||
Nomination de Andrew Mark Davies en tant qu'administrateur le 14 déc. 2017 | 2 pages | AP01 | ||
Nomination de Daniel Easthope en tant qu'administrateur le 14 déc. 2017 | 2 pages | AP01 | ||
Comptes annuels établis au 31 déc. 2016 | 17 pages | AA | ||
Nomination de Mr Lee James Mills en tant qu'administrateur le 23 oct. 2017 | 2 pages | AP01 | ||
Cessation de la nomination de Nigel Paul Taylor en tant que directeur le 29 sept. 2017 | 1 pages | TM01 | ||
Cessation de la nomination de Zafar Iqbal Khan en tant que directeur le 11 sept. 2017 | 1 pages | TM01 | ||
Cessation de la nomination de Martin Peter Routledge en tant que directeur le 31 juil. 2017 | 1 pages | TM01 | ||
Nomination de Westley Maffei en tant que secrétaire le 01 juil. 2017 | 2 pages | AP03 | ||
Cessation de la nomination de Timothy Francis George en tant que secrétaire le 30 juin 2017 | 1 pages | TM02 | ||
Cessation de la nomination de Graham Michael Carr en tant que directeur le 30 juin 2017 | 1 pages | TM01 | ||
Déclaration de confirmation établie le 17 mai 2017 avec mises à jour | 5 pages | CS01 | ||
Modification des coordonnées de l'administrateur Mr Zafar Iqbal Khan le 01 janv. 2017 | 2 pages | CH01 | ||
Cessation de la nomination de Stephen William Hudson en tant que directeur le 17 avr. 2015 | 1 pages | TM01 | ||
Nomination de Zafar Iqbal Khan en tant qu'administrateur le 31 oct. 2016 | 2 pages | AP01 | ||
Cessation de la nomination de Richard John Adam en tant que directeur le 31 oct. 2016 | 1 pages | TM01 | ||
Comptes annuels établis au 31 déc. 2015 | 17 pages | AA | ||
Qui sont les dirigeants de CARILLION UTILITY SERVICES LIMITED ?
| Nom | Nommé le | Date de démission | Rôle | Adresse | Identification de la société | Pays de résidence | Nationalité | Date de naissance | Profession | Numéro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DAVIES, Andrew Mark | Administrateur | Broad Street S1 2BQ Sheffield The Square United Kingdom | United Kingdom | British | 186650110002 | |||||
| FORSTER, Garry James | Secrétaire | Pilgrim Cottage Path Hill RG8 7RE Goring Heath Oxfordshire | British | 38750850004 | ||||||
| GEORGE, Timothy Francis | Secrétaire | 84 Salop Street WV3 0SR Wolverhampton Carillion House United Kingdom | British | 24075160004 | ||||||
| HIGGINS, Caroline Patricia | Secrétaire | Flat 10 7 Aubert Park N5 1TL London | British | 88102970001 | ||||||
| KIRKIN, Richard William | Secrétaire | 2 Redwood Close Woolston WA1 4EH Warrington Cheshire | British | 1180700001 | ||||||
| LEE, Christopher Michael | Secrétaire | Mill Road CM4 9BH Stock 1 Essex | British | 133709330001 | ||||||
| MAFFEI, Westley | Secrétaire | 84 Salop Street WV3 0SR Wolverhampton Carillion House United Kingdom | 235183570001 | |||||||
| TAPP, Richard Francis | Secrétaire | 84 Salop Street WV3 0SR Wolverhampton Carillion House United Kingdom | British | 173852420001 | ||||||
| ADAM, Richard John | Administrateur | 84 Salop Street WV3 0SR Wolverhampton Carillion House United Kingdom | United Kingdom | British | 67133560004 | |||||
| ARMSTRONG, Neil Patrick | Administrateur | 4 Euxton Hall Gardens Euxton PR7 6PB Chorley Lancashire | Irish | 104897110001 | ||||||
| ATKINSON, Sarah Elizabeth | Administrateur | 13 Milverton Drive Bramhall SK7 1EY Stockport Cheshire | British | 53216670002 | ||||||
| BEIRNE, Michael | Administrateur | 52 Lock Road Broadheath WA14 4HD Altrincham Cheshire | British | 61171370001 | ||||||
| BROWN, Andrew Peter | Administrateur | Furness Lodge Furness Field Off Werneth Low Road Gee Cross SK14 3AJ Hyde Cheshire | British | 61171450002 | ||||||
| CAROLAN, Peter Vincent | Administrateur | 272 Leigh Road Worsley M28 1LF Manchester | Irish | 62299930001 | ||||||
| CARR, Graham Michael | Administrateur | 550 Mauldeth Road West Chorlton-Cum-Hardy M21 7AA Manchester Lowry House United Kingdom | England | British | 154698170001 | |||||
| COCKER, Neil David | Administrateur | 5 Rossett Close Kingsmead CW9 8WP Northwich Cheshire | England | British | 260158230001 | |||||
| COCLIFF, Stephen Jeffrey | Administrateur | Coton Grange Coton Hill SY1 2PD Shrewsbury | England | British | 125427070002 | |||||
| COMER, Patrick Gerald | Administrateur | 21 Buttermere Drive Hale Barns WA15 0ST Altrincham Cheshire | British | 1180680003 | ||||||
| CURLEY, Patrick Joseph | Administrateur | Danley House Alders Land Disley Cheshire | Irish | 1180690001 | ||||||
| EASTHOPE, Daniel James | Administrateur | 10-12 Russell Square Bloomsbury WC1B 5EH London Russell Square House United Kingdom | England | British | 239996840001 | |||||
| GARNER, Alan David | Administrateur | 21 Sandy Lane LU7 3BE Leighton Buzzard Bedfordshire | British | 76422880001 | ||||||
| GATES, Antony Richard | Administrateur | 34 St Stephens Avenue AL3 4AD St. Albans Hertfordshire | United Kingdom | British | 165339210001 | |||||
| GLOVER, Michael John | Administrateur | 88 Barkham Ride RG40 4ET Wokingham Berkshire | British | 50242550001 | ||||||
| GRICE, Ian Michael | Administrateur | Heronshaw Oldbury Lane TN15 9DE Ightham Kent | United Kingdom | British | 44883010002 | |||||
| HOLMES, David Mark | Administrateur | 57 Hatherop Road TW12 2RG Hampton Middlesex | United Kingdom | British | 115187480001 | |||||
| HOWSON, Richard John | Administrateur | 84 Salop Street WV3 0SR Wolverhampton Carillion House United Kingdom | England | British | 147650310001 | |||||
| HUDSON, Stephen William | Administrateur | 84 Salop Street WV3 0SR Wolverhampton Carillion House United Kingdom | United Kingdom | British | 78380050003 | |||||
| HUNT, Kenneth Edward | Administrateur | 2 Fern Cottages Post Office Lane Norley WA6 8JW Frodsham Cheshire | British | 1180660002 | ||||||
| JACKSON, Andrew Philip | Administrateur | 6 Sparvells Eversley RG27 0QG Hook Hampshire | England | British | 7921750002 | |||||
| JONES, Peter Rudulph | Administrateur | Birch Street WV1 4HY Wolverhampton 24 United Kingdom | England | Irish | 173952430001 | |||||
| KENNEDY, Patrick James | Administrateur | Mayo Brooks Drive Halebarns WA15 8TL Altrincham Cheshire | United Kingdom | British | 47720560001 | |||||
| KENYON, David | Administrateur | 42 The Warings Heskin PR7 5NZ Chorley Lancashire | British | 37060690001 | ||||||
| KHAN, Zafar Iqbal | Administrateur | 84 Salop Street WV3 0SR Wolverhampton Carillion House United Kingdom | England | British | 195408780001 | |||||
| KIRKIN, Richard William | Administrateur | 2 Redwood Close Woolston WA1 4EH Warrington Cheshire | England | British | 1180700001 | |||||
| LAVELLE, Dominic Joseph | Administrateur | 2 West Grove SE10 8QT London Flat 3 | United Kingdom | British | 137285750001 |
Qui sont les personnes ayant un contrôle significatif sur CARILLION UTILITY SERVICES LIMITED ?
| Nom | Notifié le | Adresse | Cessé | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carillion Utility Services Group Limited | 06 avr. 2016 | Birch Street WV1 4JX Wolverhampton Crown House United Kingdom | Non | ||||||||||
| |||||||||||||
Nature du contrôle
| |||||||||||||
CARILLION UTILITY SERVICES LIMITED a-t-elle des charges ?
| Classification | Dates | Statut | Détails | |
|---|---|---|---|---|
| Construction cost account charge | Créé le 26 août 2005 Livré le 03 sept. 2005 | En cours | Montant garanti All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Brèves mentions All of its right, title and interest in and to the charged assets. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
| Debenture | Créé le 13 août 1997 Livré le 16 août 1997 | Totalement satisfaite | Montant garanti All moneys, obligations and liabilities for the time being, owing or incurred by the obligors (as defined therein) to the chargee under or in connection with the finance documents (as defined therein) and/or on any other account whatsoever | |
Brèves mentions .. fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
| Cash collateral security | Créé le 13 août 1997 Livré le 15 août 1997 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brèves mentions Assigns the charged account being the acount of the company with the depository (being the royal bank of scotland international limited) which account is blocked or designated as charged to the bank and the deposit being all sums at the date of the cash collateral security or thereafter standing to the credit of the charged account together with all interest and other amounts accruing on such sums in (whatever currency)together with all the rights titles and benefits of the company whatsoever present and future therein. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
| Deed of charge | Créé le 27 oct. 1981 Livré le 29 oct. 1981 | Totalement satisfaite | Montant garanti UK 11,700 | |
Brèves mentions Equitable charge over motor vehicles registration nos bmw 528I bmw 728I nja 743W nrj 553W. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
| Deed | Créé le 31 juil. 1981 Livré le 18 août 1981 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from the company to the chargee suplemental to a debenture dated 1/2/72 | |
Brèves mentions First fixed charge on all book debts & other debts. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
CARILLION UTILITY SERVICES LIMITED a-t-elle des procédures d'insolvabilité ?
| Numéro de dossier | Dates | Type | Praticiens | Autre | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
| Compulsory liquidation |
|
Source de données
- Companies House du Royaume-Uni
Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers. - Licence: CC0