00735317 LIMITED

  • Vue d'ensemble
  • Résumé
  • Objet social
  • Adresse
  • Comptes
  • Déclaration de confirmation
  • Bilan annuel
  • Dépôts
  • Dirigeants
  • Charges
  • Insolvabilité
  • Source de données
  • Vue d'ensemble

    Nom de la société00735317 LIMITED
    Statut de la sociétéLiquidation
    Forme juridiqueSociété à responsabilité limitée
    Numéro de société 00735317
    JuridictionAngleterre/Pays de Galles
    Date de création
    Date de cessation d'activité

    Résumé

    A des PSCs super sécurisésNon
    A des chargesOui
    A un historique d'insolvabilitéOui
    Le siège social est contestéNon

    Quel est l'objet de 00735317 LIMITED ?

    • (4521) /

    Où se situe 00735317 LIMITED ?

    Adresse du siège social
    KPMG LLP
    15 Canada Square Canary Wharf
    E14 5GL London
    Adresse du siège social non livrableNon

    Quels sont les derniers comptes de 00735317 LIMITED ?

    En retardOui
    Prochains comptes
    Fin de la prochaine période comptable le30 juin 2010
    Date d'échéance des prochains comptes31 mars 2011
    Derniers comptes
    Derniers comptes arrêtés au31 déc. 2008

    Quel est le statut de la dernière déclaration de confirmation pour 00735317 LIMITED ?

    En retardOui
    Dernière déclaration de confirmation établie jusqu'au31 mai 2017
    Date d'échéance de la prochaine déclaration de confirmation14 juin 2017
    En retardOui

    Quel est le statut du dernier bilan annuel pour 00735317 LIMITED ?

    Bilan annuel
    Dernier bilan annuel
    En retardOui

    Quels sont les derniers dépôts pour 00735317 LIMITED ?

    Dépôts
    DateDescriptionDocumentType

    Restauration par ordonnance du tribunal - précédemment en liquidation volontaire de créanciers

    4 pagesREST-CVL

    Certificat de changement de nom

    Company name changed holloway white allom\certificate issued on 11/01/21
    pagesCERTNM

    Gazette finale dissoute à la suite d'une liquidation

    1 pagesGAZ2

    Retour de la réunion finale dans une liquidation volontaire des créanciers

    22 pagesLIQ14

    Déclaration des reçus et paiements des liquidateurs jusqu'à 28 févr. 2019

    22 pagesLIQ03

    Déclaration des reçus et paiements des liquidateurs jusqu'à 28 févr. 2018

    22 pagesLIQ03

    Déclaration des reçus et paiements des liquidateurs jusqu'à 28 févr. 2017

    19 pages4.68

    Dépôt d'insolvabilité

    INSOLVENCY:secretary of state's release of liquidator
    1 pagesLIQ MISC

    Démission d'un liquidateur

    1 pages4.33

    Ordonnance du tribunal d'insolvabilité

    Court order INSOLVENCY:order of court in respect of replacement liquidator
    6 pagesLIQ MISC OC

    Déclaration des reçus et paiements des liquidateurs jusqu'à 29 févr. 2016

    19 pages4.68

    Changement d'adresse du siège social de Komg Llp 15 Canada Square Canary Wharf London E14 5GL à 15 Canada Square Canary Wharf London E14 5GL le 17 juin 2015

    2 pagesAD01

    Changement d'adresse du siège social de C/O Kpmg Llp 8 Salisbury Square London EC4Y 8BB à Komg Llp 15 Canada Square Canary Wharf London E14 5GL le 22 mai 2015

    2 pagesAD01

    Déclaration des reçus et paiements des liquidateurs jusqu'à 28 févr. 2015

    17 pages4.68

    Déclaration des reçus et paiements des liquidateurs jusqu'à 28 févr. 2014

    18 pages4.68

    Nomination d'un liquidateur volontaire

    1 pages600

    Rapport d'avancement de l'administrateur jusqu'à 25 févr. 2013

    22 pages2.24B

    Avis de transition de l'administration à la liquidation volontaire des créanciers

    1 pages2.34B

    Avis de transition de l'administration à la liquidation volontaire des créanciers

    1 pages2.34B

    Avis de prolongation de la période de l'administration

    1 pages2.31B

    Rapport d'avancement de l'administrateur jusqu'à 04 avr. 2012

    21 pages2.24B

    Cessation de la nomination de Nigel Diver en tant que secrétaire

    1 pagesTM02

    Avis d'approbation réputée des propositions

    1 pagesF2.18

    Déclaration de la proposition de l'administrateur

    36 pages2.17B

    Déclaration des affaires avec le formulaire 2.14B

    15 pages2.16B

    Qui sont les dirigeants de 00735317 LIMITED ?

    Dirigeants
    NomNommé leDate de démissionRôleAdresseIdentification de la sociétéPays de résidenceNationalitéDate de naissanceProfessionNuméro
    COLE, Robert Terry
    Canada Square
    Canary Wharf
    E14 5GL London
    15
    Administrateur
    Canada Square
    Canary Wharf
    E14 5GL London
    15
    EnglandBritishCompany Director82282430001
    HAILEY, Mark Crompton
    Canada Square
    Canary Wharf
    E14 5GL London
    15
    Administrateur
    Canada Square
    Canary Wharf
    E14 5GL London
    15
    United KingdomBritishDirector121769160001
    KEATING, Stephen Charles
    Canada Square
    Canary Wharf
    E14 5GL London
    15
    Administrateur
    Canada Square
    Canary Wharf
    E14 5GL London
    15
    United KingdomBritishDirector152085790001
    OIRSCHOT, Richard Anthony
    Canada Square
    Canary Wharf
    E14 5GL London
    15
    Administrateur
    Canada Square
    Canary Wharf
    E14 5GL London
    15
    EnglandBritishDirector153410900001
    DIVER, Nigel James
    10 Holbrook Gardens
    WD25 8AB Aldenham
    Hertfordshire
    Secrétaire
    10 Holbrook Gardens
    WD25 8AB Aldenham
    Hertfordshire
    BritishFinance84312990002
    FEATHERSTONE, Derek William
    33 Somersham
    Bridlewood Panshanger
    AL7 2PZ Welwyn Garden City
    Hertfordshire
    Secrétaire
    33 Somersham
    Bridlewood Panshanger
    AL7 2PZ Welwyn Garden City
    Hertfordshire
    BritishCompany Secretary38485580001
    MILLER, Roger Keith
    Hatters Barn
    Stockwell Lane Little Meadle
    HP17 9UG Aylesbury
    Buckinghamshire
    Secrétaire
    Hatters Barn
    Stockwell Lane Little Meadle
    HP17 9UG Aylesbury
    Buckinghamshire
    British120645920001
    PRAIN, Ronald
    19 Cross Deep Gardens
    TW1 4QZ Twickenham
    Middlesex
    Secrétaire
    19 Cross Deep Gardens
    TW1 4QZ Twickenham
    Middlesex
    British2864720001
    SPRIGGS, Peter John
    59 Crofts Path
    HP3 8HE Hemel Hempstead
    Hertfordshire
    Secrétaire
    59 Crofts Path
    HP3 8HE Hemel Hempstead
    Hertfordshire
    British11339380001
    ARDERN, Derrick
    Twyvidales
    85 Eythrope Road
    HP17 8PH Stone Aylesbury
    Buckinghamshire
    Administrateur
    Twyvidales
    85 Eythrope Road
    HP17 8PH Stone Aylesbury
    Buckinghamshire
    United KingdomBritishChartered Surveyor44478670001
    BARNES, David Arthur Robert
    2 Victoria Road
    TW1 3HW Twickenham
    Middlesex
    Administrateur
    2 Victoria Road
    TW1 3HW Twickenham
    Middlesex
    EnglandBritishCompany Director28481590001
    BREED, Barry Tony
    Vesta Avenue
    AL1 2PF St. Albans
    26
    Hertfordshire
    United Kingdom
    Administrateur
    Vesta Avenue
    AL1 2PF St. Albans
    26
    Hertfordshire
    United Kingdom
    United KingdomBritishConstruction140305440002
    COLGATE, Benjamin John
    Giddygreen 34 Sandyhurst Lane
    TN25 4NS Ashford
    Kent
    Administrateur
    Giddygreen 34 Sandyhurst Lane
    TN25 4NS Ashford
    Kent
    United KingdomBritishMarketing116271550001
    COLLINS, Paul David
    21 Onslow Road
    KT3 4AR New Malden
    Surrey
    Administrateur
    21 Onslow Road
    KT3 4AR New Malden
    Surrey
    BritishCompany Director28481600003
    COWEN, Michael Richard
    27 Addison Way
    NW11 6AL London
    Administrateur
    27 Addison Way
    NW11 6AL London
    BritishCertified Accountant67834500002
    CROSSMAN, Brian Robert
    3 Badgers Walk
    Tewin
    AL6 0HP Welwyn
    Hertfordshire
    Administrateur
    3 Badgers Walk
    Tewin
    AL6 0HP Welwyn
    Hertfordshire
    United KingdomBritishCommercial84313470002
    DAVENPORT, Simon
    Fishpool Street
    AL3 4RX St Albans
    56
    Herts
    Administrateur
    Fishpool Street
    AL3 4RX St Albans
    56
    Herts
    BritishDirector129728380001
    DAVIES, John Leighton
    Ferncroft Mapledrakes Road
    GU6 7QW Ewhurst
    Surrey
    Administrateur
    Ferncroft Mapledrakes Road
    GU6 7QW Ewhurst
    Surrey
    BritishChief Estimator60507760001
    DEAN, John Michael
    Charlwood Cottage Guildford Road
    Normandy
    GU3 2AW Guildford
    Surrey
    Administrateur
    Charlwood Cottage Guildford Road
    Normandy
    GU3 2AW Guildford
    Surrey
    BritishChief Surveyor28481620001
    DIVER, Nigel James
    10 Holbrook Gardens
    WD25 8AB Aldenham
    Hertfordshire
    Administrateur
    10 Holbrook Gardens
    WD25 8AB Aldenham
    Hertfordshire
    EnglandBritishFinance84312990002
    DUNN, James Christopher
    54 Oxford Drive
    SE1 2FB London
    Administrateur
    54 Oxford Drive
    SE1 2FB London
    BritishConstruction28529460003
    EDNIE, Derek Angus
    3 Vicarage Lane
    Dunton Green
    TN13 2TP Sevenoaks
    Kent
    Administrateur
    3 Vicarage Lane
    Dunton Green
    TN13 2TP Sevenoaks
    Kent
    United KingdomBritishCompany Director46123240001
    ERRINGTON, Paul John
    1 Hazlemere Road
    Penn
    HP10 8AA High Wycombe
    Buckinghamshire
    Administrateur
    1 Hazlemere Road
    Penn
    HP10 8AA High Wycombe
    Buckinghamshire
    United KingdomBritishDirector28481630001
    EWER, Adrian James Henry
    Blagdens House Bumpstead Road
    Hempstead
    CB10 2PW Saffron Walden
    Essex
    Administrateur
    Blagdens House Bumpstead Road
    Hempstead
    CB10 2PW Saffron Walden
    Essex
    United KingdomBritishChartered Accountant33196010002
    GILES, Phillip Peter
    17 Fairford Avenue
    LU2 7ER Luton
    Bedfordshire
    Administrateur
    17 Fairford Avenue
    LU2 7ER Luton
    Bedfordshire
    BritishQuantity Surveyor41677700001
    HOCKLEY, John Edward
    The Cottage
    Main Street Akeley
    MK18 5HR Buckingham
    Bucks
    Administrateur
    The Cottage
    Main Street Akeley
    MK18 5HR Buckingham
    Bucks
    United KingdomBritishManaging Director30434730001
    JONES, Ian Benbow
    11 Woodbury Park Road
    Ealing
    W13 8DD London
    Administrateur
    11 Woodbury Park Road
    Ealing
    W13 8DD London
    United KingdomBritishConstruction108331280002
    MOORE, Steven John
    Heathmoor House
    47 Pinfold Pond
    Woburn
    Bedfordshire
    Administrateur
    Heathmoor House
    47 Pinfold Pond
    Woburn
    Bedfordshire
    BritishDirector10662610001
    PRAIN, Ronald
    19 Cross Deep Gardens
    TW1 4QZ Twickenham
    Middlesex
    Administrateur
    19 Cross Deep Gardens
    TW1 4QZ Twickenham
    Middlesex
    BritishAccountant2864720001
    RANKIN, David Douglas
    20 Marriotts Way
    Haddenham
    HP17 8BW Aylesbury
    Buckinghamshire
    Administrateur
    20 Marriotts Way
    Haddenham
    HP17 8BW Aylesbury
    Buckinghamshire
    BritishCompany Director43928310001
    RICHARDSON, Brian
    Hylle House
    Pound Hill
    MK17 9AS Great Brickhill
    Buckinghamshire
    Administrateur
    Hylle House
    Pound Hill
    MK17 9AS Great Brickhill
    Buckinghamshire
    EnglandBritishCompany Director109836750001
    SHEPHERD, Martyn Alan
    1 Carteret Close
    Willen
    MK15 9LD Milton Keynes
    Buckinghamshire
    Administrateur
    1 Carteret Close
    Willen
    MK15 9LD Milton Keynes
    Buckinghamshire
    BritishQuantity Surveyor106456400001
    SIZE, Darren Thomas
    Ainsdale Road
    W5 1JY London
    31
    Administrateur
    Ainsdale Road
    W5 1JY London
    31
    EnglandIrishDirector129728000001
    SPRIGGS, Peter John
    59 Crofts Path
    HP3 8HE Hemel Hempstead
    Hertfordshire
    Administrateur
    59 Crofts Path
    HP3 8HE Hemel Hempstead
    Hertfordshire
    BritishAccountant11339380001
    VARLEY, David Gordon
    The Paddock House West Common
    SL9 7QN Gerrards Cross
    Buckinghamshire
    Administrateur
    The Paddock House West Common
    SL9 7QN Gerrards Cross
    Buckinghamshire
    BritishDirector Of Companies28481640001

    00735317 LIMITED a-t-elle des charges ?

    Charges
    ClassificationDatesStatutDétails
    Composite guarantee and debenture
    Créé le 14 févr. 2011
    Livré le 17 févr. 2011
    En cours
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    L/H property comprising parts of the basement ground floor and first floor of 43 south audley street london and the basement showroom in adams mews westminster t/no LN14336; fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, uncalled capital, plant & machinery, equipment. See image for full details.
    Personnes ayant droit
    • Reward Capital Limited
    Transactions
    • 17 févr. 2011Enregistrement d'une charge (MG01)
    • 02 juin 2011Déclaration que tout ou partie de la propriété grevée a été libérée (MG04)
    Guarantee & debenture
    Créé le 08 janv. 2010
    Livré le 22 janv. 2010
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from hwa group limited to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    Personnes ayant droit
    • Matrix Private Equity Partners LLP as Security Trustee
    Transactions
    • 22 janv. 2010Enregistrement d'une charge (MG01)
    • 17 févr. 2011Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (MG02)
    Legal assignment of key man policies
    Créé le 28 août 2008
    Livré le 09 sept. 2008
    En cours
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    Rights title interest and benefit in and to the key man policies being; 70C19U56, st james's place UK PLC, philip haydn whitehead, £400,000, 71C06P23 st james's place UK PLC robert terry cole £1,000,000, 90070383, phoenix life limited, nigel driver, £234,312. see image for full details.
    Personnes ayant droit
    • Lloyds Tsb Bank PLC
    Transactions
    • 09 sept. 2008Enregistrement d'une charge (395)
    Deed of counter indemnity
    Créé le 05 avr. 2008
    Livré le 15 avr. 2008
    En cours
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    All property assets and undertaking including the l/h premises parts of the basement ground floor and first floor of 43 south audley street and the basement showroom in adams mews london t/no LN14336 see image for full details.
    Personnes ayant droit
    • Zurich Gsg Limited
    Transactions
    • 15 avr. 2008Enregistrement d'une charge (395)
    Debenture
    Créé le 05 avr. 2008
    Livré le 11 avr. 2008
    En cours
    Montant garanti
    All monies due or to become due from any obligor to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery.
    Personnes ayant droit
    • Lloyds Tsb Bank PLC
    Transactions
    • 11 avr. 2008Enregistrement d'une charge (395)
    • 02 juin 2011Déclaration que tout ou partie de la propriété grevée a été libérée (MG04)
    Legal charge
    Créé le 10 août 2005
    Livré le 24 août 2005
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    L/H land comprising parts of the basement ground floor and first floor of 43 south audley street and the basement showroom in adams mews westminster t/n LN14336 and all buildings plant and machinery all additions and improvements and all the estate or interest all monies from time to time payable under or pursuant to the insurances including without limitation the refund of any premiums and first floating charge all moveable machinery equipment and furniture on or at the property. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Zurich Gsg Limited
    Transactions
    • 24 août 2005Enregistrement d'une charge (395)
    • 17 févr. 2011Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (MG02)
    Mortgage deed
    Créé le 05 nov. 2002
    Livré le 19 nov. 2002
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    The l/h property k/a 43 south audley street grosvenor square london. Together with all buildings and fixtures (including trade fixtures) fixed plant and machinery by way of fixed charge all present and future book and other debts floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment by way of assignment the goodwill of the business (if any) the full benefit of all licences and all guarantees.
    Personnes ayant droit
    • Lloyds Tsb Bank PLC
    Transactions
    • 19 nov. 2002Enregistrement d'une charge (395)
    • 01 juin 2005Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Account management agreement
    Créé le 05 nov. 2002
    Livré le 19 nov. 2002
    En cours
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    All sums standing to the credit of the account and numbered 01118165.
    Personnes ayant droit
    • Lloyds Tsb Bank PLC
    Transactions
    • 19 nov. 2002Enregistrement d'une charge (395)
    Debenture deed
    Créé le 05 nov. 2002
    Livré le 19 nov. 2002
    En cours
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personnes ayant droit
    • Lloyds Tsb Bank PLC
    Transactions
    • 19 nov. 2002Enregistrement d'une charge (395)
    An omnibus letter of set off
    Créé le 05 nov. 2002
    Livré le 19 nov. 2002
    En cours
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company and/or hwa limited to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Any sum or sums standing to the credit of the account.
    Personnes ayant droit
    • Lloyds Tsb Bank PLC
    Transactions
    • 19 nov. 2002Enregistrement d'une charge (395)
    Mortgage of a life policy to secure own liabilities of a company
    Créé le 05 nov. 2002
    Livré le 19 nov. 2002
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Assigns all money including bonuses, the benefit of all options and rights under or in connection with the policy numbered 27C82G83 and in the name of robert cole. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Lloyds Tsb Bank PLC
    Transactions
    • 19 nov. 2002Enregistrement d'une charge (395)
    • 01 juin 2005Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Mortgage of a life policy to secure own liabilities of acompany
    Créé le 05 nov. 2002
    Livré le 19 nov. 2002
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Assigns all money including bonuses, the benefit of all options and rights under or in connection with the policy numbered F3347455 in the name of nigel james diver. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Lloyds Tsb Bank PLC
    Transactions
    • 19 nov. 2002Enregistrement d'une charge (395)
    • 01 juin 2005Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Mortgage of a life policy to secure own liabilities of a company
    Créé le 05 nov. 2002
    Livré le 19 nov. 2002
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Assigns all money including bonuses, the benefit of all options and rights under or in connection with the policy numbered F3347535 and in the name of brian robert crossman. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Lloyds Tsb Bank PLC
    Transactions
    • 19 nov. 2002Enregistrement d'une charge (395)
    • 01 juin 2005Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Mortgage of a life policy to secure own liabilities of a company
    Créé le 05 nov. 2002
    Livré le 19 nov. 2002
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Assigns all monies including bonuses, all option and rights under or in connection with the policy numbered 27C82E84 in the name of philip whitehead. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Lloyds Tsb Bank PLC
    Transactions
    • 19 nov. 2002Enregistrement d'une charge (395)
    • 01 juin 2005Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Guarantee and fixed and floating security document (the "security document")
    Créé le 22 oct. 2001
    Livré le 08 nov. 2001
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All moneys,debts and liabilities whatsoever due or to become due from the company to any beneficiary (as defined) under the guarantee and the group financing documents (as defined) and the security document
    Brèves mentions
    Including (I) millmarsh lane,enfield EN3 7AG; ngl 5924; (ii) sowton 30,sidmouth rd,exeter; dn 407452; (iii old railway works,newton rd,ashford (all freehold ) plus other properties listed; see form 395 for details. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personnes ayant droit
    • The Royal Bank of Scotland,as Security Trustee for the Beneficiaries
    Transactions
    • 08 nov. 2001Enregistrement d'une charge (395)
    • 06 nov. 2002Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)

    00735317 LIMITED a-t-elle des procédures d'insolvabilité ?

    Numéro de dossierDatesTypePraticiensAutre
    1
    DateType
    05 oct. 2011Administration started
    01 mars 2013Administration ended
    In administration
    NomRôleAdresseNommé leCessé le
    William James Wright
    One Snowhill Snow Hill Queensway
    B4 6GH Birmingham
    practitioner
    One Snowhill Snow Hill Queensway
    B4 6GH Birmingham
    Howard Smith
    Kpmg Llp
    1 The Embankment
    LS1 4DW Neville Street
    Leeds
    practitioner
    Kpmg Llp
    1 The Embankment
    LS1 4DW Neville Street
    Leeds
    Colin Michael Trevethyn Haig
    8 Salisbury Square
    EC4Y 8BB London
    practitioner
    8 Salisbury Square
    EC4Y 8BB London
    2
    DateType
    01 mars 2013Commencement of winding up
    11 oct. 2019Dissolved on
    Creditors voluntary liquidation
    NomRôleAdresseNommé leCessé le
    David John Standish
    8 Salisbury Square
    EC4Y 8BB London
    practitioner
    8 Salisbury Square
    EC4Y 8BB London
    Howard Smith
    8 Salisbury Square
    EC4Y 8BB London
    practitioner
    8 Salisbury Square
    EC4Y 8BB London
    Colin Michael Trevethyn Haig
    8 Salisbury Square
    EC4Y 8BB London
    practitioner
    8 Salisbury Square
    EC4Y 8BB London

    Source de données

    • Companies House du Royaume-Uni
      Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers.
    • Licence: CC0