MARSHALL RICHARDS BARCRO LIMITED

MARSHALL RICHARDS BARCRO LIMITED

  • Vue d'ensemble
  • Résumé
  • Objet social
  • Adresse
  • Dénominations sociales précédentes
  • Comptes
  • Bilan annuel
  • Dépôts
  • Dirigeants
  • Charges
  • Source de données
  • Vue d'ensemble

    Nom de la sociétéMARSHALL RICHARDS BARCRO LIMITED
    Statut de la sociétéDissoute
    Forme juridiqueSociété à responsabilité limitée
    Numéro de société 00741999
    JuridictionAngleterre/Pays de Galles
    Date de création
    Date de cessation d'activité

    Résumé

    A des PSCs super sécurisésNon
    A des chargesOui
    A un historique d'insolvabilitéNon
    Le siège social est contestéNon

    Quel est l'objet de MARSHALL RICHARDS BARCRO LIMITED ?

    • Société inactive (99999) / Activités des organisations et organismes extraterritoriaux

    Où se situe MARSHALL RICHARDS BARCRO LIMITED ?

    Adresse du siège social
    1 Henson Close
    South Church Enterprise Park
    DL14 6WA Bishop Auckland
    Durham
    Adresse du siège social non livrableNon

    Quels étaient les noms précédents de MARSHALL RICHARDS BARCRO LIMITED ?

    Dénominations sociales précédentes
    Nom de la sociétéDeJusqu'au
    BARCRO-OLYMPIC STRANDERS LIMITED26 nov. 196226 nov. 1962

    Quels sont les derniers comptes de MARSHALL RICHARDS BARCRO LIMITED ?

    Derniers comptes
    Derniers comptes arrêtés au30 sept. 2012

    Quel est le statut du dernier bilan annuel pour MARSHALL RICHARDS BARCRO LIMITED ?

    Bilan annuel
    Dernier bilan annuel

    Quels sont les derniers dépôts pour MARSHALL RICHARDS BARCRO LIMITED ?

    Dépôts
    DateDescriptionDocumentType

    Bulletin officiel final dissous par radiation d'office

    1 pagesGAZ2

    Premier avis au Bulletin officiel pour la radiation d'office

    1 pagesGAZ1

    Déclaration annuelle jusqu'au 31 janv. 2014 avec liste complète des actionnaires

    4 pagesAR01
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    capital03 févr. 2014

    État du capital au 03 févr. 2014

    • Capital: GBP 100
    SH01

    Cessation de la nomination de Paul Antony Storey en tant que directeur le 29 nov. 2013

    1 pagesTM01

    Nomination de Mr André Rahmen en tant qu'administrateur le 25 nov. 2013

    2 pagesAP01

    Nomination de Mr Stephen David Lidgate en tant qu'administrateur le 25 nov. 2013

    2 pagesAP01

    Comptes d'exonération totale pour petite entreprise établis au 30 sept. 2012

    3 pagesAA

    Déclaration annuelle jusqu'au 31 janv. 2013 avec liste complète des actionnaires

    3 pagesAR01

    Comptes d'exonération totale pour petite entreprise établis au 30 sept. 2011

    4 pagesAA

    Déclaration annuelle jusqu'au 31 janv. 2012 avec liste complète des actionnaires

    3 pagesAR01

    Comptes établis au 30 sept. 2010

    5 pagesAA

    Déclaration annuelle jusqu'au 31 janv. 2011 avec liste complète des actionnaires

    3 pagesAR01

    Comptes établis au 30 sept. 2009

    5 pagesAA

    Déclaration annuelle jusqu'au 31 janv. 2010 avec liste complète des actionnaires

    4 pagesAR01

    Modification des coordonnées de l'administrateur Paul Antony Storey le 15 oct. 2009

    2 pagesCH01

    Modification des coordonnées de l'administrateur Paul Antony Storey le 15 oct. 2009

    2 pagesCH01

    Comptes établis au 30 sept. 2008

    5 pagesAA

    legacy

    3 pages363a

    legacy

    1 pages288b

    Comptes établis au 30 sept. 2007

    5 pagesAA

    legacy

    6 pages363s

    legacy

    7 pages363s

    Comptes établis au 30 sept. 2006

    4 pagesAA

    legacy

    1 pages288b

    legacy

    7 pages363s

    Qui sont les dirigeants de MARSHALL RICHARDS BARCRO LIMITED ?

    Dirigeants
    NomNommé leDate de démissionRôleAdresseIdentification de la sociétéPays de résidenceNationalitéDate de naissanceProfessionNuméro
    LIDGATE, Stephen David
    Beresford Way
    S41 9FG Chesterfield
    The Bridge Business Centre
    Derbyshire
    England
    Administrateur
    Beresford Way
    S41 9FG Chesterfield
    The Bridge Business Centre
    Derbyshire
    England
    EnglandBritishCompany Director183151940001
    RAHMEN, André
    Beresford Way
    S41 9FG Chesterfield
    The Bridge Business Centre
    Derbyshire
    England
    Administrateur
    Beresford Way
    S41 9FG Chesterfield
    The Bridge Business Centre
    Derbyshire
    England
    GermanyGermanVice President Commercial183153740001
    NICKLIN, George
    25 Buttermere
    DL16 6UD Spennymoor
    County Durham
    Secrétaire
    25 Buttermere
    DL16 6UD Spennymoor
    County Durham
    British28873360001
    ROBSON, David
    2 Spire Hollin
    SR8 1DA Peterlee
    County Durham
    Secrétaire
    2 Spire Hollin
    SR8 1DA Peterlee
    County Durham
    British53835800001
    BREME, Harald
    Maarweg 16
    D-5100 Aachen
    Germany
    Administrateur
    Maarweg 16
    D-5100 Aachen
    Germany
    GermanDirector29332200002
    CAHILL, Terence
    5 Mallard Way
    CF36 3TS Porthcawl
    Mid-Glamorgan
    Administrateur
    5 Mallard Way
    CF36 3TS Porthcawl
    Mid-Glamorgan
    BritishTechnical Consultant28873380001
    CALDWELL, John Christopher
    282 Ecclesall Road South
    S11 9PS Sheffield
    South Yorkshire
    Administrateur
    282 Ecclesall Road South
    S11 9PS Sheffield
    South Yorkshire
    EnglandBritishDirector83552520001
    CHARLES, Nigel Alan
    1 Midfields
    School Aycliffe
    DL5 6QJ Newton Aycliffe
    County Durham
    Administrateur
    1 Midfields
    School Aycliffe
    DL5 6QJ Newton Aycliffe
    County Durham
    BritishDirector30529170001
    ERKES, Klaus Friedrich
    Auf Der Alm 10a
    Roetgen D-52159
    FOREIGN Germany
    Administrateur
    Auf Der Alm 10a
    Roetgen D-52159
    FOREIGN Germany
    GermanChairman60961460001
    GRAEFE, Joachim, Dr
    Sonnenhang 7b
    Schwerte
    D-58239
    Germany
    Administrateur
    Sonnenhang 7b
    Schwerte
    D-58239
    Germany
    GermanChairman105757030001
    NICKLIN, George
    25 Buttermere
    DL16 6UD Spennymoor
    County Durham
    Administrateur
    25 Buttermere
    DL16 6UD Spennymoor
    County Durham
    United KingdomBritishDirector28873360001
    PAMPLIN, John Warner, Dr
    Kirklees
    Hamsterley
    DL13 3PP Bishop Auckland
    County Durham
    Administrateur
    Kirklees
    Hamsterley
    DL13 3PP Bishop Auckland
    County Durham
    BritishDirector9292930001
    PARKES, John
    19 Wardles Lane
    Great Wyrley
    WS6 6DX Walsall
    West Midlands
    Administrateur
    19 Wardles Lane
    Great Wyrley
    WS6 6DX Walsall
    West Midlands
    BritishDirector55620660001
    PEIRSON, James Geoffrey
    17 Lindom Avenue
    DH3 3PP Chester Le Street
    County Durham
    Administrateur
    17 Lindom Avenue
    DH3 3PP Chester Le Street
    County Durham
    BritishDirector53835710001
    STOREY, Paul Antony
    1 Henson Close
    South Church Enterprise Park
    DL14 6WA Bishop Auckland
    Durham
    Administrateur
    1 Henson Close
    South Church Enterprise Park
    DL14 6WA Bishop Auckland
    Durham
    United KingdomBritishCompany Director53835780003
    TOMLINSON, Walter Murray
    Letterbox Farm
    Pratthall Calthorpe
    S42 7AZ Chesterfield
    Administrateur
    Letterbox Farm
    Pratthall Calthorpe
    S42 7AZ Chesterfield
    BritishDirector1961890001
    WETZELS, Walter
    Maarweg 12
    D-5100 Aachen
    Germany
    Administrateur
    Maarweg 12
    D-5100 Aachen
    Germany
    BelgianDirector31753130001

    MARSHALL RICHARDS BARCRO LIMITED a-t-elle des charges ?

    Charges
    ClassificationDatesStatutDétails
    Legal charge
    Créé le 08 janv. 1991
    Livré le 10 janv. 1991
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company and/or wmt holdings PLC to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Prospect house, fir tree crook county durham.
    Personnes ayant droit
    • Barclays Bank PLC
    Transactions
    • 10 janv. 1991Enregistrement d'une charge
    • 23 oct. 1993Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Letter of charge
    Créé le 14 juil. 1989
    Livré le 31 juil. 1989
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from morgan 85 LTD and/or rails 84 LTD and/or power and central systems LTD and/or wmt holdings LTD and/or lubewell LTD and/or limited and/or strategic maintenance services LTD and/or beals limited to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    All monies standing to the credit of any accounts of the company in the banks books.
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transactions
    • 31 juil. 1989Enregistrement d'une charge
    • 13 août 2004Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Letter of charge
    Créé le 22 sept. 1988
    Livré le 27 sept. 1988
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from wmt holdings limited and/or beaver 84 limited and/or rails 84 limited and/or murhan associates limited and/or morgan 85 limited and/or power & coutron systems limited and/or lubeswell limited on any account whatsoever to the chargee
    Brèves mentions
    All monies to the credit of any accounts of the company in the banks books.
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transactions
    • 27 sept. 1988Enregistrement d'une charge
    • 13 août 2004Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Letter of charge
    Créé le 05 mars 1988
    Livré le 23 mars 1988
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from wmt holdings LTD and/or beaver 84 LTD and/or rails 84 LTD and/or murhan associates LTD and/or morgan 85 LTD and/or power & control systems LTD. To the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    All monies due now or at any time herafter standing to the credit of any account or accounts of the company in the banks books.
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transactions
    • 23 mars 1988Enregistrement d'une charge
    • 13 août 2004Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Letter of charge
    Créé le 09 avr. 1987
    Livré le 15 avr. 1987
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from rails 84 limited and/or murhan associates limited and/or beaver 84 limited and/ or morgan 85 limited and/or wmt holdings limited to the governor and company of the bank of scotland on any account whatsoever
    Brèves mentions
    All monies now or at any time hereafter standing to the credit of any account or accounts of the company in the banks books.
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transactions
    • 15 avr. 1987Enregistrement d'une charge
    • 13 août 2004Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Debenture containing fixed and floating charges
    Créé le 09 avr. 1987
    Livré le 15 avr. 1987
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Undertaking and all property and assets of the company whatsoever and wheresoever present and future as specified in attached schedule which also contains covenants by and restrictions on the company which protect and further define the charges and must be read as one with the charges (please see doc).
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transactions
    • 15 avr. 1987Enregistrement d'une charge
    • 13 août 2004Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Mortgage debenture
    Créé le 08 mai 1985
    Livré le 14 mai 1985
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    A specific equitable charge over all f/h and l/h properties and/or the proceeds of sale thereof fixed & floating charges over undertaking and all property and assets present and future including goodwill book and other debts.
    Personnes ayant droit
    • National Westminster Bank PLC
    Transactions
    • 14 mai 1985Enregistrement d'une charge
    Debenture
    Créé le 12 juin 1984
    Livré le 20 juin 1984
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All moneys due or to become due from wmt holdings limited to the chargee on any account whatsoever pursuant to a loan agreement dated 12 june 1984
    Brèves mentions
    First legal mortgage the real property prospect house fir tree crook co durham first fixed charge (a) all real property (b) equipment fittings fixtures and furnishings (c) the goodwill and connections of the business (d) all book debts and other debts (e) plant and machinery now or from time to time owned by the company fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personnes ayant droit
    • United Kingdom Temperance and General Provident Institution
    Transactions
    • 20 juin 1984Enregistrement d'une charge
    • 13 août 2004Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)

    Source de données

    • Companies House du Royaume-Uni
      Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers.
    • Licence: CC0