SURRIDGE DAWSON LIMITED

  • Vue d'ensemble
  • Résumé
  • Objet social
  • Adresse
  • Comptes
  • Dépôts
  • Dirigeants
  • Charges
  • Insolvabilité
  • Source de données
  • Vue d'ensemble

    Nom de la sociétéSURRIDGE DAWSON LIMITED
    Statut de la sociétéDissoute
    Forme juridiqueSociété à responsabilité limitée
    Numéro de société 00744679
    JuridictionAngleterre/Pays de Galles
    Date de création
    Date de cessation d'activité

    Résumé

    A des PSCs super sécurisésNon
    A des chargesOui
    A un historique d'insolvabilitéOui
    Le siège social est contestéNon

    Quel est l'objet de SURRIDGE DAWSON LIMITED ?

    • (5156) /

    Où se situe SURRIDGE DAWSON LIMITED ?

    Adresse du siège social
    C/O ERNST & YOUNG LLP
    1 Bridgewater Place Water Lane
    LS11 5QR Leeds
    Adresse du siège social non livrableNon

    Quels sont les derniers comptes de SURRIDGE DAWSON LIMITED ?

    Derniers comptes
    Derniers comptes arrêtés au29 sept. 2007

    Quels sont les derniers dépôts pour SURRIDGE DAWSON LIMITED ?

    Dépôts
    DateDescriptionDocumentType

    Déclaration de biens vacants

    1 pagesBONA

    Gazette finale dissoute à la suite d'une liquidation

    1 pagesGAZ2

    Déclaration des reçus et paiements des liquidateurs jusqu'à 27 avr. 2017

    5 pages4.68

    Retour de la réunion finale dans une liquidation volontaire des créanciers

    3 pages4.72

    Déclaration des reçus et paiements des liquidateurs jusqu'à 05 févr. 2017

    6 pages4.68

    Déclaration des reçus et paiements des liquidateurs jusqu'à 05 août 2016

    17 pages4.68

    Déclaration des reçus et paiements des liquidateurs jusqu'à 05 août 2016

    5 pages4.68

    Déclaration des reçus et paiements des liquidateurs jusqu'à 05 févr. 2016

    5 pages4.68

    Déclaration des reçus et paiements des liquidateurs jusqu'à 05 août 2015

    15 pages4.68

    Déclaration des reçus et paiements des liquidateurs jusqu'à 05 août 2015

    5 pages4.68

    Déclaration des reçus et paiements des liquidateurs jusqu'à 05 févr. 2015

    5 pages4.68

    Déclaration des reçus et paiements des liquidateurs jusqu'à 05 août 2014

    15 pages4.68

    Déclaration des reçus et paiements des liquidateurs jusqu'à 05 août 2014

    5 pages4.68

    Déclaration des reçus et paiements des liquidateurs jusqu'à 05 févr. 2014

    5 pages4.68

    Déclaration des reçus et paiements des liquidateurs jusqu'à 05 août 2013

    5 pages4.68

    Déclaration des reçus et paiements des liquidateurs jusqu'à 05 févr. 2013

    5 pages4.68

    Déclaration des reçus et paiements des liquidateurs jusqu'à 05 août 2012

    5 pages4.68

    Déclaration des reçus et paiements des liquidateurs jusqu'à 05 févr. 2012

    6 pages4.68

    Déclaration des reçus et paiements des liquidateurs jusqu'à 05 août 2011

    10 pages4.68

    Cessation de la nomination de Nigel Freer en tant que directeur

    1 pagesTM01

    Cessation de la nomination de Adrian Wood en tant que directeur

    1 pagesTM01

    Cessation de la nomination de Hugh Cawley en tant que directeur

    1 pagesTM01

    Cessation de la nomination de Adrian Wood en tant que secrétaire

    1 pagesTM02

    Avis de constitution du Comité de liquidation

    2 pages4.48

    Nomination d'un liquidateur volontaire

    1 pages600

    Qui sont les dirigeants de SURRIDGE DAWSON LIMITED ?

    Dirigeants
    NomNommé leDate de démissionRôleAdresseIdentification de la sociétéPays de résidenceNationalitéDate de naissanceProfessionNuméro
    CLARK, William David
    5 Felbridge Avenue
    Pound Hill
    RH10 7BD Crawley
    West Sussex
    Secrétaire
    5 Felbridge Avenue
    Pound Hill
    RH10 7BD Crawley
    West Sussex
    British21438440001
    WOOD, Adrian Lewis
    15 Mill Place
    KT1 2RS Kingston Upon Thames
    Surrey
    Secrétaire
    15 Mill Place
    KT1 2RS Kingston Upon Thames
    Surrey
    British53930680002
    ARDEN, Philip John
    99 Hodford Road
    NW11 8EH London
    Administrateur
    99 Hodford Road
    NW11 8EH London
    EnglandUnited Kingdom72635300002
    BAKER, Dennis Henry
    3a Hillcrest Road
    Saltwood
    CT21 5EX Hythe
    Kent
    Administrateur
    3a Hillcrest Road
    Saltwood
    CT21 5EX Hythe
    Kent
    United KingdomBritish8558620001
    BLUNDELL, David
    38 Rue Des Armateurs
    17350 Port D'Envaux
    Charente Maritime
    France
    Administrateur
    38 Rue Des Armateurs
    17350 Port D'Envaux
    Charente Maritime
    France
    FranceBritish135612830001
    BROWN, Jeffrey Richard
    Greenway Cottage
    2 Parkland Close
    TN13 1SL Sevenoaks
    Kent
    Administrateur
    Greenway Cottage
    2 Parkland Close
    TN13 1SL Sevenoaks
    Kent
    British33494270001
    BROWN, Peter Michael
    12 Hyde Park Place
    W2 2LH London
    Administrateur
    12 Hyde Park Place
    W2 2LH London
    EnglandBritish1788540001
    BUTTERWORTH, Paul
    Slade Leas
    Middleton Cheney
    OX17 2NH Banbury
    10
    Oxon
    Administrateur
    Slade Leas
    Middleton Cheney
    OX17 2NH Banbury
    10
    Oxon
    United KingdomBritish133099190001
    CAWLEY, Hugh Charles Laurence
    Red Roke 137 Epsom Road
    Merrow
    GU1 2PP Guildford
    Surrey
    Administrateur
    Red Roke 137 Epsom Road
    Merrow
    GU1 2PP Guildford
    Surrey
    United KingdomBritish41820960003
    CONNOLLY, Gerard Vincent
    Ledbury House Manor Lane
    SL9 7NJ Gerrards Cross
    Buckinghamshire
    Administrateur
    Ledbury House Manor Lane
    SL9 7NJ Gerrards Cross
    Buckinghamshire
    Irish57063820001
    DURANCE, Peter George
    132 Woodland Way
    BR4 9LU West Wickham
    Kent
    Administrateur
    132 Woodland Way
    BR4 9LU West Wickham
    Kent
    British63568700001
    EVAN-COOK, Paul
    Borderigg Benhall Mill Road
    TN2 5JH Tunbridge Wells
    Kent
    Administrateur
    Borderigg Benhall Mill Road
    TN2 5JH Tunbridge Wells
    Kent
    British7658310001
    FREER, Nigel Rodney
    The Drey 12 Lakewood Road
    Chandlers Ford
    SO53 1ES Eastleigh
    Hampshire
    Administrateur
    The Drey 12 Lakewood Road
    Chandlers Ford
    SO53 1ES Eastleigh
    Hampshire
    United KingdomBritish59149820004
    HADDON, Laurence Lyndon
    Walnut Lea Beacon Hill
    Penn
    HP10 8NH High Wycombe
    Buckinghamshire
    Administrateur
    Walnut Lea Beacon Hill
    Penn
    HP10 8NH High Wycombe
    Buckinghamshire
    British7817410001
    HARRIS, Peter Robert
    Four Winds
    Fireball Hill
    SL5 9PJ Sunningdale
    Berkshire
    Administrateur
    Four Winds
    Fireball Hill
    SL5 9PJ Sunningdale
    Berkshire
    United KingdomBritish50619920001
    HAVELL, Roger Laurence
    1 Hatchlands
    Broad Street
    RH17 5LS Haywards Heath
    West Sussex
    Administrateur
    1 Hatchlands
    Broad Street
    RH17 5LS Haywards Heath
    West Sussex
    British73794670001
    HOWE, John
    10 Primrose Lane
    RG41 5UR Winnersh
    Berkshire
    Administrateur
    10 Primrose Lane
    RG41 5UR Winnersh
    Berkshire
    United KingdomBritish72001440001
    INGLEBY, Bryan Clifford
    Wentworth 355 London Road
    CT14 9PS Deal
    Kent
    Administrateur
    Wentworth 355 London Road
    CT14 9PS Deal
    Kent
    British7658300001
    KENNEDY, Alan Gilbert
    PO BOX 561 Pmb 6/805
    International Commercial Centre
    FOREIGN Main Street Gibraltar
    Administrateur
    PO BOX 561 Pmb 6/805
    International Commercial Centre
    FOREIGN Main Street Gibraltar
    British38254250001
    KERR, Diane Catherine
    The Cottage
    Back Lane
    NN14 4AX Little Addington
    Northamptonshire
    Administrateur
    The Cottage
    Back Lane
    NN14 4AX Little Addington
    Northamptonshire
    United KingdomBritish72001350001
    LOWTHER, David John
    12 Pensford Avenue
    Kew
    TW9 4HP Richmond
    Surrey
    Administrateur
    12 Pensford Avenue
    Kew
    TW9 4HP Richmond
    Surrey
    British43607630001
    MELODY, Roger James
    30 Highfield Road
    CR8 2JG Purley
    Surrey
    Administrateur
    30 Highfield Road
    CR8 2JG Purley
    Surrey
    British17422210001
    PERRY, Terence John
    4 Badgers Croft
    Leverstock Green
    HP2 4NE Hemel Hempstead
    Hertfordshire
    Administrateur
    4 Badgers Croft
    Leverstock Green
    HP2 4NE Hemel Hempstead
    Hertfordshire
    United KingdomBritish116319520001
    REDINGTON, John William
    19 Welcomes Road
    CR8 5HA Kenley
    Surrey
    Administrateur
    19 Welcomes Road
    CR8 5HA Kenley
    Surrey
    British65211420001
    SURRIDGE, Stephen Edward
    79 Rook Lane
    CR3 5BN Caterham
    Surrey
    Administrateur
    79 Rook Lane
    CR3 5BN Caterham
    Surrey
    British69814210001
    TOWNLEY, John Robert
    136 Coldershaw Road
    W13 9DT London
    Administrateur
    136 Coldershaw Road
    W13 9DT London
    British72000900002
    WOOD, Adrian Lewis
    15 Mill Place
    KT1 2RS Kingston Upon Thames
    Surrey
    Administrateur
    15 Mill Place
    KT1 2RS Kingston Upon Thames
    Surrey
    British53930680002
    WOOD, Adrian Lewis
    15 Mill Place
    KT1 2RS Kingston Upon Thames
    Surrey
    Administrateur
    15 Mill Place
    KT1 2RS Kingston Upon Thames
    Surrey
    British53930680002
    WOOD, Adrian Lewis
    7 Ullswater Crescent
    SW15 3RG London
    Administrateur
    7 Ullswater Crescent
    SW15 3RG London
    British53930680001

    SURRIDGE DAWSON LIMITED a-t-elle des charges ?

    Charges
    ClassificationDatesStatutDétails
    Debenture
    Créé le 25 juin 2009
    Livré le 08 juil. 2009
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    Personnes ayant droit
    • Frontline Limited
    Transactions
    • 08 juil. 2009Enregistrement d'une charge (395)
    • 04 mars 2010Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (MG02)
    Debenture
    Créé le 25 juin 2009
    Livré le 07 juil. 2009
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including book debts, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    Personnes ayant droit
    • Northern & Shell PLC
    Transactions
    • 07 juil. 2009Enregistrement d'une charge (395)
    • 04 mars 2010Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (MG02)
    Debenture
    Créé le 25 juin 2009
    Livré le 07 juil. 2009
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including book debts, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    Personnes ayant droit
    • Northern & Shell Distribution Limited
    Transactions
    • 07 juil. 2009Enregistrement d'une charge (395)
    • 04 mars 2010Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (MG02)
    Debenture
    Créé le 25 juin 2009
    Livré le 07 juil. 2009
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including book debts, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    Personnes ayant droit
    • Northern & Shell Magazines Limited
    Transactions
    • 07 juil. 2009Enregistrement d'une charge (395)
    • 04 mars 2010Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (MG02)
    Debenture
    Créé le 25 juin 2009
    Livré le 07 juil. 2009
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including book debts, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    Personnes ayant droit
    • Associated Newspapers Limited
    Transactions
    • 07 juil. 2009Enregistrement d'une charge (395)
    • 04 mars 2010Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (MG02)
    Debenture
    Créé le 25 juin 2009
    Livré le 07 juil. 2009
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including book debts, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    Personnes ayant droit
    • Guardian News & Media Limited
    Transactions
    • 07 juil. 2009Enregistrement d'une charge (395)
    • 09 mars 2010Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (MG02)
    Debenture
    Créé le 25 juin 2009
    Livré le 07 juil. 2009
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including book debts, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    Personnes ayant droit
    • Conde Nast & National Magazine Distributors Limited
    Transactions
    • 07 juil. 2009Enregistrement d'une charge (395)
    • 04 mars 2010Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (MG02)
    Debenture
    Créé le 25 juin 2009
    Livré le 07 juil. 2009
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including book debts, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    Personnes ayant droit
    • Marketforce (UK) Limited
    Transactions
    • 07 juil. 2009Enregistrement d'une charge (395)
    • 04 mars 2010Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (MG02)
    Debenture
    Créé le 25 juin 2009
    Livré le 07 juil. 2009
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including book debts, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    Personnes ayant droit
    • Mgn Limited
    Transactions
    • 07 juil. 2009Enregistrement d'une charge (395)
    • 04 mars 2010Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (MG02)
    Debenture
    Créé le 25 juin 2009
    Livré le 07 juil. 2009
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including book debts, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    Personnes ayant droit
    • Express Newspapers
    Transactions
    • 07 juil. 2009Enregistrement d'une charge (395)
    • 04 mars 2010Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (MG02)
    Debenture
    Créé le 25 juin 2009
    Livré le 07 juil. 2009
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including book debts, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    Personnes ayant droit
    • Seymour Distribution Limited
    Transactions
    • 07 juil. 2009Enregistrement d'une charge (395)
    • 04 mars 2010Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (MG02)
    Debenture
    Créé le 25 juin 2009
    Livré le 07 juil. 2009
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    Personnes ayant droit
    • Telegraph Media Group Limited
    Transactions
    • 07 juil. 2009Enregistrement d'une charge (395)
    • 04 mars 2010Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (MG02)
    Debenture
    Créé le 24 août 2007
    Livré le 01 sept. 2007
    En cours
    Montant garanti
    All monies due or to become due from any chargor to the finance parties under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Barclays Bank PLC
    Transactions
    • 01 sept. 2007Enregistrement d'une charge (395)
    • 07 déc. 2007Déclaration que tout ou partie de la propriété d'une charge flottante a été libérée (403b)
    Rent deposit deed
    Créé le 16 mai 2006
    Livré le 19 mai 2006
    En cours
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    The amount from time to time standing to the credit of a seperate designated interest earning account. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Harmsworth Pension Funds Trustees Limited
    Transactions
    • 19 mai 2006Enregistrement d'une charge (395)
    Guarantee and debenture
    Créé le 22 nov. 2001
    Livré le 05 déc. 2001
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies,obligations and liabilities due or to become due from the company (the "chargor") to any of the secured parties (as defined) under or pursuant to all or any of the financing documents (as defined) including the guarantee and debenture
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • National Westminster Bank PLC,as Agent and Trustee for the Secured Parties (As Defined)
    Transactions
    • 05 déc. 2001Enregistrement d'une charge (395)
    • 05 déc. 2007Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Guarantee and debenture
    Créé le 15 nov. 2000
    Livré le 23 nov. 2000
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies,obligations and liabilities due or to become due from the company (the "chargor") to any of the secured parties (as defined) on any account whatsoever and under this guarantee and debenture
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • National Westminster Bank PLC as Security Trustee
    Transactions
    • 23 nov. 2000Enregistrement d'une charge (395)
    • 15 déc. 2004Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Guarantee & debenture
    Créé le 19 janv. 1998
    Livré le 26 janv. 1998
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee under or pursuant to the financing documents (as therein defined)
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • National Westminster Bank PLC
    Transactions
    • 26 janv. 1998Enregistrement d'une charge (395)
    • 15 déc. 2004Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Legal charge
    Créé le 24 oct. 1991
    Livré le 23 oct. 1991
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    The performance of the company's obligations to the chargee under the terms of an agreement dated 24/10/91
    Brèves mentions
    F/H property off the south side of wainfleet road and to the east of robin hood rd, skegness lincolnshire.
    Personnes ayant droit
    • Wright (Properties) Limited
    Transactions
    • 23 oct. 1991Enregistrement d'une charge
    • 30 déc. 1997Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Series of debentures
    Créé le 17 févr. 1987
    Livré le 17 févr. 1987
    Totalement satisfaite
    Brèves mentions
    New windsor bridge road,bath.motts lane witham braintree.holmbush industrial estate, st.austell cornwall.
    Transactions
    • 17 févr. 1987Enregistrement d'une charge pour garantir une série de débentures (397)
    • 13 févr. 1992Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Series of debentures
    Créé le 17 févr. 1987
    Livré le 17 févr. 1987
    Totalement satisfaite
    Brèves mentions
    New windsor bridge road,bath.motts lane, witham braintree.holmbush industrial estate, st.austell cornwell.
    Transactions
    • 17 févr. 1987Enregistrement d'une charge pour garantir une série de débentures (397)
    • 13 févr. 1992Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)

    SURRIDGE DAWSON LIMITED a-t-elle des procédures d'insolvabilité ?

    Numéro de dossierDatesTypePraticiensAutre
    1
    DateType
    03 août 2009Administration started
    06 août 2010Administration ended
    In administration
    NomRôleAdresseNommé leCessé le
    Charles Graham John King
    Ernst & Young Llp
    1 Bridgewater Place
    LS11 5QR Water Lane
    Leeds
    practitioner
    Ernst & Young Llp
    1 Bridgewater Place
    LS11 5QR Water Lane
    Leeds
    Alan Robert Bloom
    Ernst & Young Llp
    1 More London Place
    SE1 2AF London
    practitioner
    Ernst & Young Llp
    1 More London Place
    SE1 2AF London
    Robert Hunter Kelly
    Ernst & Young Llp 1 Bridgewater Place Water Lane
    LS11 5QR Leeds
    West Yorkshire
    practitioner
    Ernst & Young Llp 1 Bridgewater Place Water Lane
    LS11 5QR Leeds
    West Yorkshire
    2
    DateType
    06 août 2010Commencement of winding up
    17 août 2017Dissolved on
    Creditors voluntary liquidation
    NomRôleAdresseNommé leCessé le
    Charles Graham John King
    Ernst & Young Llp
    1 Bridgewater Place
    LS11 5QR Water Lane
    Leeds
    practitioner
    Ernst & Young Llp
    1 Bridgewater Place
    LS11 5QR Water Lane
    Leeds
    Robert Hunter Kelly
    Ernst & Young Llp 1 Bridgewater Place Water Lane
    LS11 5QR Leeds
    West Yorkshire
    practitioner
    Ernst & Young Llp 1 Bridgewater Place Water Lane
    LS11 5QR Leeds
    West Yorkshire

    Source de données

    • Companies House du Royaume-Uni
      Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers.
    • Licence: CC0