G3 INVESTMENTS LIMITED

  • Vue d'ensemble
  • Résumé
  • Objet social
  • Adresse
  • Dénominations sociales précédentes
  • Comptes
  • Dépôts
  • Dirigeants
  • Personnes ayant un contrôle significatif
  • Charges
  • Insolvabilité
  • Source de données
  • Vue d'ensemble

    Nom de la sociétéG3 INVESTMENTS LIMITED
    Statut de la sociétéDissoute
    Forme juridiqueSociété à responsabilité limitée
    Numéro de société 00746257
    JuridictionAngleterre/Pays de Galles
    Date de création
    Date de cessation d'activité

    Résumé

    A des PSCs super sécurisésNon
    A des chargesOui
    A un historique d'insolvabilitéOui
    Le siège social est contestéNon

    Quel est l'objet de G3 INVESTMENTS LIMITED ?

    • Société non marchande non marchande (74990) / Activités spécialisées, scientifiques et techniques

    Où se situe G3 INVESTMENTS LIMITED ?

    Adresse du siège social
    Suite A 7th Floor City Gate East
    Tollhouse Hill
    NG1 5FS Nottingham
    Adresse du siège social non livrableNon

    Quels étaient les noms précédents de G3 INVESTMENTS LIMITED ?

    Dénominations sociales précédentes
    Nom de la sociétéDeJusqu'au
    WHITTLE INVESTMENT SERVICES LIMITED08 sept. 199508 sept. 1995
    G. & C. WHITTLE HOLDINGS LIMITED31 déc. 197731 déc. 1977
    MITRO ANODISING LIMITED08 janv. 196308 janv. 1963

    Quels sont les derniers comptes de G3 INVESTMENTS LIMITED ?

    Derniers comptes
    Derniers comptes arrêtés au31 mars 2016

    Quels sont les derniers dépôts pour G3 INVESTMENTS LIMITED ?

    Dépôts
    DateDescriptionDocumentType

    Gazette finale dissoute à la suite d'une liquidation

    1 pagesGAZ2

    Retour de la réunion finale dans une liquidation volontaire des membres

    15 pagesLIQ13

    Changement d'adresse du siège social de 81 Burton Road Derby Derbyshire DE1 1TJ à Suite a 7th Floor City Gate East Tollhouse Hill Nottingham NG1 5FS le 04 déc. 2017

    2 pagesAD01

    Nomination d'un liquidateur volontaire

    2 pages600

    Résolutions

    Resolutions
    2 pagesRESOLUTIONS
    Résolutions
    CatégorieDateDescriptionType
    liquidation

    Résolution spéciale pour la liquidation au 06 nov. 2017

    LRESSP

    Période comptable actuelle prolongée du 31 mars 2017 au 30 sept. 2017

    1 pagesAA01

    Comptes pour une société dormante établis au 31 mars 2016

    6 pagesAA

    Déclaration de confirmation établie le 21 oct. 2016 avec mises à jour

    5 pagesCS01

    Comptes pour une société dormante établis au 31 mars 2015

    6 pagesAA

    Déclaration annuelle jusqu'au 21 oct. 2015 avec liste complète des actionnaires

    6 pagesAR01
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    capital22 oct. 2015

    État du capital au 22 oct. 2015

    • Capital: GBP 878,003
    SH01

    Comptes pour une société dormante établis au 31 mars 2014

    6 pagesAA

    Déclaration annuelle jusqu'au 21 oct. 2014 avec liste complète des actionnaires

    6 pagesAR01
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    capital04 nov. 2014

    État du capital au 04 nov. 2014

    • Capital: GBP 878,003
    SH01

    Modification des coordonnées de l'administrateur Stephen Campbell Whittle le 16 sept. 2014

    2 pagesCH01

    Modification des coordonnées de l'administrateur Susan Massey Whittle le 16 sept. 2014

    2 pagesCH01

    Satisfaction de la charge 21 en totalité

    4 pagesMR04

    Satisfaction de la charge 12 en totalité

    4 pagesMR04

    Satisfaction de la charge 11 en totalité

    4 pagesMR04

    Satisfaction de la charge 14 en totalité

    4 pagesMR04

    Satisfaction de la charge 23 en totalité

    4 pagesMR04

    Satisfaction de la charge 25 en totalité

    4 pagesMR04

    Satisfaction de la charge 19 en totalité

    4 pagesMR04

    Satisfaction de la charge 17 en totalité

    4 pagesMR04

    Satisfaction de la charge 13 en totalité

    4 pagesMR04

    Satisfaction de la charge 16 en totalité

    4 pagesMR04

    Satisfaction de la charge 24 en totalité

    4 pagesMR04

    Qui sont les dirigeants de G3 INVESTMENTS LIMITED ?

    Dirigeants
    NomNommé leDate de démissionRôleAdresseIdentification de la sociétéPays de résidenceNationalitéDate de naissanceProfessionNuméro
    MINOGUE, Gillian Mary
    Mapperley Park
    NG3 5DT Nottingham
    6 Carisbrooke Avenue
    England
    Secrétaire
    Mapperley Park
    NG3 5DT Nottingham
    6 Carisbrooke Avenue
    England
    188447670001
    MINOGUE, Gillian Mary
    Carisbrooke Avenue
    Mapperley Park
    NG3 5DT Nottingham
    6
    United Kingdom
    Administrateur
    Carisbrooke Avenue
    Mapperley Park
    NG3 5DT Nottingham
    6
    United Kingdom
    BritishCompany Director44177270003
    WHITTLE, Stephen Campbell
    Oakhill House
    32 Park Terrace
    NG1 5DN Nottingham
    Flat 2
    England
    Administrateur
    Oakhill House
    32 Park Terrace
    NG1 5DN Nottingham
    Flat 2
    England
    United KingdomBritishDirector8325760005
    WHITTLE, Susan Massey
    Oakhill House
    32 Park Terrace
    NG1 5DN Nottingham
    Flat 2
    England
    Administrateur
    Oakhill House
    32 Park Terrace
    NG1 5DN Nottingham
    Flat 2
    England
    United KingdomBritishCompany Director8325770006
    HAMMOND, Christopher John
    17 Rock Hill Gardens
    NG18 2JP Mansfield
    Nottinghamshire
    Secrétaire
    17 Rock Hill Gardens
    NG18 2JP Mansfield
    Nottinghamshire
    British56802710001
    HUGHES, John Richard Hal
    Ivy Lodge
    2 Hallfields
    NG12 4AA Edwalton
    Nottinghamshire
    Secrétaire
    Ivy Lodge
    2 Hallfields
    NG12 4AA Edwalton
    Nottinghamshire
    British56860280001
    HAMMOND, Christopher John
    17 Rock Hill Gardens
    NG18 2JP Mansfield
    Nottinghamshire
    Administrateur
    17 Rock Hill Gardens
    NG18 2JP Mansfield
    Nottinghamshire
    BritishAccountant56802710001

    Qui sont les personnes ayant un contrôle significatif sur G3 INVESTMENTS LIMITED ?

    Personnes ayant un contrôle significatif
    NomNotifié leAdresseCessé
    DE1 1TJ Derby
    81 Burton Road
    Derbyshire
    England
    06 avr. 2016
    DE1 1TJ Derby
    81 Burton Road
    Derbyshire
    England
    Non
    Forme juridiqueLimited Company
    Pays d'enregistrementEngland And Wales
    Autorité légaleCompanies Act 1985
    Lieu d'enregistrementCompanies House
    Numéro d'enregistrement02469950
    Nature du contrôle
    • La personne détient, directement ou indirectement, plus de 75 % des actions de la société.

    G3 INVESTMENTS LIMITED a-t-elle des charges ?

    Charges
    ClassificationDatesStatutDétails
    Legal charge
    Créé le 23 sept. 2003
    Livré le 30 sept. 2003
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Apartment A24 on second floor of arundel house, 552 kings road, london SW10 to be known as blore house, coleridge gardens, kings road, london SW10 0RB,. By way of fixed charge the benefit of all covenants and rights concerning the property and plant machinery fixtures fittings furniture equipment implements and utensils the goodwill of any business carried on at the property and the proceeds of any insurance affecting the property or assets.
    Personnes ayant droit
    • National Westminster Bank PLC
    Transactions
    • 30 sept. 2003Enregistrement d'une charge (395)
    • 07 juin 2005Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Legal mortgage
    Créé le 31 mars 2000
    Livré le 12 avr. 2000
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Freehold property k/a 226 derby road nottingham t/n NT65710. And the proceeds of sale thereof floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment and an assignment of the goodwill and connection of any business together with the full benefit of all licences.
    Personnes ayant droit
    • National Westminster Bank PLC
    Transactions
    • 12 avr. 2000Enregistrement d'une charge (395)
    • 11 sept. 2014Satisfaction d'une charge (MR04)
    Legal mortgage
    Créé le 31 mars 2000
    Livré le 11 avr. 2000
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    F/Hold property known as 8 clumber crescent north the park nottingham; NT22698. And the proceeds of sale thereof floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment and an assignment of the goodwill and connection of any business together with the full benefit of all licences.
    Personnes ayant droit
    • National Westminster Bank PLC
    Transactions
    • 11 avr. 2000Enregistrement d'une charge (395)
    • 11 sept. 2014Satisfaction d'une charge (MR04)
    Legal mortgage
    Créé le 01 juil. 1997
    Livré le 15 juil. 1997
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    The freehold property known as land on the south side of little tennis street nottingham title number NT295793. And the proceeds of sale thereof floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment and an assignment of the goodwill and connection of any business together with the full benefit of all licences.
    Personnes ayant droit
    • National Westminster Bank PLC
    Transactions
    • 15 juil. 1997Enregistrement d'une charge (395)
    • 11 sept. 2014Satisfaction d'une charge (MR04)
    Legal mortgage
    Créé le 20 oct. 1995
    Livré le 25 oct. 1995
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Property k/a land and buildings on the south west side of high church street and A. floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment and an assignment of the goodwill and connection of any business together with the full benefit of all licences.
    Personnes ayant droit
    • National Westminster Bank PLC
    Transactions
    • 25 oct. 1995Enregistrement d'une charge (395)
    • 06 mai 1998Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Legal mortgage
    Créé le 20 oct. 1995
    Livré le 25 oct. 1995
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Property k/a land and buildings on the north side of kingsbury road erdington and A. floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment and an assignment of the goodwill and connection of any business together with the full benefit of all licences.
    Personnes ayant droit
    • National Westminster Bank PLC
    Transactions
    • 25 oct. 1995Enregistrement d'une charge (395)
    • 11 sept. 2014Satisfaction d'une charge (MR04)
    Legal mortgage
    Créé le 20 oct. 1995
    Livré le 25 oct. 1995
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Property k/a land and buildings on the east side of hucknall lane bulwell and A. floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment and an assignment of the goodwill and connection of any business together with the full benefit of all licences.
    Personnes ayant droit
    • National Westminster Bank PLC
    Transactions
    • 25 oct. 1995Enregistrement d'une charge (395)
    • 04 oct. 2002Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Legal mortgage
    Créé le 20 oct. 1995
    Livré le 25 oct. 1995
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Property k/a daybrook house monton road eccles manchester and A. floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment and an assignment of the goodwill and connection of any business together with the full benefit of all licences.
    Personnes ayant droit
    • National Westminster Bank PLC
    Transactions
    • 25 oct. 1995Enregistrement d'une charge (395)
    • 11 sept. 2014Satisfaction d'une charge (MR04)
    Legal mortgage
    Créé le 20 oct. 1995
    Livré le 25 oct. 1995
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Property k/a daybrook house hucknal lane bulwell and A. floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment and an assignment of the goodwill and connection of any business together with the full benefit of all licences.
    Personnes ayant droit
    • National Westminster Bank PLC
    Transactions
    • 25 oct. 1995Enregistrement d'une charge (395)
    • 04 oct. 2002Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Legal mortgage
    Créé le 14 juin 1995
    Livré le 26 juin 1995
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    L/H property k/a 72 maid marian way & newdigate house, castle gate, nottingham and the proceeds of sale thereof. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment and an assignment of the goodwill and connection of any business together with the full benefit of all licences.
    Personnes ayant droit
    • National Westminster Bank PLC
    Transactions
    • 26 juin 1995Enregistrement d'une charge (395)
    • 11 sept. 2014Satisfaction d'une charge (MR04)
    Mortgage debenture
    Créé le 17 juil. 1991
    Livré le 25 juil. 1991
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    A specific equitable charge over all freehold and leasehold properties and/or the proceeds of sale thereof fixed and floating charges over undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts and the benefits of any licences.
    Personnes ayant droit
    • National Westminster Bank PLC
    Transactions
    • 25 juil. 1991Enregistrement d'une charge
    • 15 avr. 1993Déclaration que tout ou partie de la propriété d'une charge flottante a été libérée (403b)
    • 12 sept. 1995Déclaration que tout ou partie de la propriété d'une charge flottante a été libérée (403b)
    • 06 mai 1998Déclaration que tout ou partie de la propriété d'une charge flottante a été libérée (403b)
    • 11 sept. 2014Satisfaction d'une charge (MR04)
    Legal mortgage
    Créé le 17 juil. 1991
    Livré le 25 juil. 1991
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Daybrook house, hucknall lane, bulwell, nottinghamshire t/no. NT212140 and proceeds of sale thereof. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Personnes ayant droit
    • National Westminster Bank PLC
    Transactions
    • 25 juil. 1991Enregistrement d'une charge
    • 15 avr. 1993Déclaration que tout ou partie de la propriété d'une charge flottante a été libérée (403b)
    • 04 oct. 2002Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Legal mortgage
    Créé le 17 juil. 1991
    Livré le 25 juil. 1991
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Daybrook house, monton road, eccles, manchester t/no. GM481630 and/or proceeds of sale. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Personnes ayant droit
    • National Westminster Bank PLC
    Transactions
    • 25 juil. 1991Enregistrement d'une charge
    • 15 avr. 1993Déclaration que tout ou partie de la propriété d'une charge flottante a été libérée (403b)
    • 11 sept. 2014Satisfaction d'une charge (MR04)
    Legal mortgage
    Créé le 17 juil. 1991
    Livré le 25 juil. 1991
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Land at ollerton road, arnold, nottinghamshire, t/no. NT159220 and/or proceeds of sale thereof. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Personnes ayant droit
    • National Westminster Bank PLC
    Transactions
    • 25 juil. 1991Enregistrement d'une charge
    • 15 avr. 1993Déclaration que tout ou partie de la propriété d'une charge flottante a été libérée (403b)
    • 11 sept. 2014Satisfaction d'une charge (MR04)
    Legal mortgage
    Créé le 17 juil. 1991
    Livré le 25 juil. 1991
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Land and buildings on west side of kingsbury road, eslington, W.midlands t/no. WM7473 and/or proceeds of sale. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Personnes ayant droit
    • National Westminster Bank PLC
    Transactions
    • 25 juil. 1991Enregistrement d'une charge
    • 15 avr. 1993Déclaration que tout ou partie de la propriété d'une charge flottante a été libérée (403b)
    • 11 sept. 2014Satisfaction d'une charge (MR04)
    Legal mortgage
    Créé le 17 juil. 1991
    Livré le 25 juil. 1991
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Land at cockcliffe farm, arnold, nottinghamshire t/no. NT261915 and/or proceeds of sale. Floating charge over all movable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Personnes ayant droit
    • National Westminster Bank PLC
    Transactions
    • 25 juil. 1991Enregistrement d'une charge
    • 15 avr. 1993Déclaration que tout ou partie de la propriété d'une charge flottante a été libérée (403b)
    • 11 sept. 2014Satisfaction d'une charge (MR04)
    Legal charge
    Créé le 03 oct. 1988
    Livré le 14 oct. 1988
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Land & buildings at 170A monton road monton eccles manchester.
    Personnes ayant droit
    • Midland Bank PLC
    Transactions
    • 14 oct. 1988Enregistrement d'une charge
    • 20 août 1991Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Legal charge
    Créé le 13 oct. 1987
    Livré le 14 oct. 1987
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Land lying to the west of hermitage lane mansfield nottinghamshire.
    Personnes ayant droit
    • Midland Bank PLC
    Transactions
    • 14 oct. 1987Enregistrement d'une charge
    • 20 août 1991Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Legal charge
    Créé le 13 oct. 1987
    Livré le 14 oct. 1987
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Premises in hucknall lane bulwell, nottingham.
    Personnes ayant droit
    • Midland Bank PLC
    Transactions
    • 14 oct. 1987Enregistrement d'une charge
    • 20 août 1991Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Legal charge
    Créé le 12 sept. 1983
    Livré le 26 sept. 1983
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    F/H land containing 18.63 acres. Comprising enclosure numbers 3385 and 3667 on the ordnance survey map at ollerton rd, arnold, nottingham.
    Personnes ayant droit
    • Midland Bank PLC
    Transactions
    • 26 sept. 1983Enregistrement d'une charge
    • 20 août 1991Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Charge
    Créé le 23 mai 1983
    Livré le 02 juin 1983
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    All book debts and other debts owing to the company.
    Personnes ayant droit
    • Midland Bank PLC
    Transactions
    • 02 juin 1983Enregistrement d'une charge
    • 20 août 1991Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Mortgage
    Créé le 04 juin 1981
    Livré le 22 juin 1981
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    F/H 14.5 acres approx land at cockliffe hill farm arnold nottingham.
    Personnes ayant droit
    • Midland Bank PLC
    Transactions
    • 22 juin 1981Enregistrement d'une charge
    • 20 août 1991Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Mortgage
    Créé le 04 juin 1981
    Livré le 22 juin 1981
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    F/H and premises 944/952 kingsbury road erdington birmingham title no. Wm 7473.
    Personnes ayant droit
    • Midland Bank PLC
    Transactions
    • 22 juin 1981Enregistrement d'une charge
    • 20 août 1991Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Mortgage
    Créé le 26 juin 1980
    Livré le 03 juil. 1980
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    L/H flat e top floor 15 cleveland square. London W.2. title no ln 69566 together with all fixtures.
    Personnes ayant droit
    • Midland Bank PLC
    Transactions
    • 03 juil. 1980Enregistrement d'une charge
    • 20 août 1991Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Mortgage
    Créé le 28 mars 1980
    Livré le 31 mars 1980
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    F/H lands & premises at nottingham road, daybrook, nottingham together with all fixtures.
    Personnes ayant droit
    • Midland Bank PLC
    Transactions
    • 31 mars 1980Enregistrement d'une charge
    • 20 août 1991Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)

    G3 INVESTMENTS LIMITED a-t-elle des procédures d'insolvabilité ?

    Numéro de dossierDatesTypePraticiensAutre
    1
    DateType
    18 avr. 2019Dissolved on
    06 nov. 2017Commencement of winding up
    Members voluntary liquidation
    NomRôleAdresseNommé leCessé le
    Patrick B Ellward
    Suite A 7th Floor City Gate East
    Tollhouse Hill
    NG1 5FS Nottingham
    Nottinghamshire
    practitioner
    Suite A 7th Floor City Gate East
    Tollhouse Hill
    NG1 5FS Nottingham
    Nottinghamshire
    Adrian David Allen
    Suite A, 7th Floor City Gate East Tollhouse Hill
    NG1 5FS Nottingham
    practitioner
    Suite A, 7th Floor City Gate East Tollhouse Hill
    NG1 5FS Nottingham

    Source de données

    • Companies House du Royaume-Uni
      Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers.
    • Licence: CC0