CHEMRING EUROPE LIMITED

  • Vue d'ensemble
  • Résumé
  • Objet social
  • Adresse
  • Dénominations sociales précédentes
  • Comptes
  • Dépôts
  • Dirigeants
  • Personnes ayant un contrôle significatif
  • Charges
  • Source de données
  • Vue d'ensemble

    Nom de la sociétéCHEMRING EUROPE LIMITED
    Statut de la sociétéDissoute
    Forme juridiqueSociété à responsabilité limitée
    Numéro de société 00746603
    JuridictionAngleterre/Pays de Galles
    Date de création
    Date de cessation d'activité

    Résumé

    A des PSCs super sécurisésNon
    A des chargesOui
    A un historique d'insolvabilitéNon
    Le siège social est contestéNon

    Quel est l'objet de CHEMRING EUROPE LIMITED ?

    • Activités des sièges sociaux (70100) / Activités spécialisées, scientifiques et techniques

    Où se situe CHEMRING EUROPE LIMITED ?

    Adresse du siège social
    Roke Manor
    Old Salisbury Lane
    SO51 0ZN Romsey
    Hampshire
    Adresse du siège social non livrableNon

    Quels étaient les noms précédents de CHEMRING EUROPE LIMITED ?

    Dénominations sociales précédentes
    Nom de la sociétéDeJusqu'au
    PARKWAY NO 4 LIMITED18 avr. 200718 avr. 2007
    MCMURDO LIMITED25 sept. 198925 sept. 1989
    MCMURDO INSTRUMENT COMPANY LIMITED(THE)11 janv. 196311 janv. 1963

    Quels sont les derniers comptes de CHEMRING EUROPE LIMITED ?

    Derniers comptes
    Derniers comptes arrêtés au31 oct. 2021

    Quels sont les derniers dépôts pour CHEMRING EUROPE LIMITED ?

    Dépôts
    DateDescriptionDocumentType

    Bulletin officiel final dissous par radiation volontaire

    1 pagesGAZ2(A)

    Premier avis au Bulletin officiel pour la radiation volontaire

    1 pagesGAZ1(A)

    Demande de radiation de la société du registre du commerce

    3 pagesDS01

    Déclaration de confirmation établie le 01 févr. 2023 avec mises à jour

    4 pagesCS01

    État du capital au 03 févr. 2023

    • Capital: GBP 1
    5 pagesSH19

    legacy

    1 pagesSH20

    legacy

    1 pagesCAP-SS

    Résolutions

    Resolutions
    1 pagesRESOLUTIONS
    Résolutions
    CatégorieDateDescriptionType
    capital

    Résolution de réduction du capital social émis

    RES06

    État du capital après une attribution d'actions au 14 nov. 2022

    • Capital: GBP 24,156,245
    3 pagesSH01

    Statuts

    6 pagesMA

    Résolutions

    Resolutions
    1 pagesRESOLUTIONS
    Résolutions
    CatégorieDateDescriptionType
    capital

    Résolution d'attribution de valeurs mobilières

    RES10
    incorporation

    Résolution d'adoption des statuts

    RES01

    Statuts

    11 pagesMA

    Comptes pour une société dormante établis au 31 oct. 2021

    3 pagesAA

    Déclaration de confirmation établie le 01 févr. 2022 sans mise à jour

    3 pagesCS01

    Comptes pour une société dormante établis au 31 oct. 2020

    7 pagesAA

    Déclaration de confirmation établie le 01 févr. 2021 sans mise à jour

    3 pagesCS01

    Comptes pour une société dormante établis au 31 oct. 2019

    7 pagesAA

    Déclaration de confirmation établie le 01 févr. 2020 sans mise à jour

    3 pagesCS01

    Comptes pour une société dormante établis au 31 oct. 2018

    7 pagesAA

    Déclaration de confirmation établie le 01 févr. 2019 avec mises à jour

    4 pagesCS01

    Comptes pour une société dormante établis au 31 oct. 2017

    7 pagesAA

    Cessation de la nomination de Michael James Flowers en tant que directeur le 30 juin 2018

    1 pagesTM01

    Déclaration de confirmation établie le 01 févr. 2018 avec mises à jour

    4 pagesCS01

    Satisfaction de la charge 7 en totalité

    1 pagesMR04

    Satisfaction de la charge 8 en totalité

    1 pagesMR04

    Qui sont les dirigeants de CHEMRING EUROPE LIMITED ?

    Dirigeants
    NomNommé leDate de démissionRôleAdresseIdentification de la sociétéPays de résidenceNationalitéDate de naissanceProfessionNuméro
    ELLARD, Sarah Louise
    Old Salisbury Lane
    SO51 0ZN Romsey
    Roke Manor
    Hampshire
    United Kingdom
    Secrétaire
    Old Salisbury Lane
    SO51 0ZN Romsey
    Roke Manor
    Hampshire
    United Kingdom
    BritishCompany Secretary43855640011
    ELLARD, Sarah Louise
    Old Salisbury Lane
    SO51 0ZN Romsey
    Roke Manor
    Hampshire
    United Kingdom
    Administrateur
    Old Salisbury Lane
    SO51 0ZN Romsey
    Roke Manor
    Hampshire
    United Kingdom
    EnglandBritishGroup Legal Director43855640013
    LEWIS, Andrew Gregory
    Old Salisbury Lane
    SO51 0ZN Romsey
    Roke Manor
    Hampshire
    Administrateur
    Old Salisbury Lane
    SO51 0ZN Romsey
    Roke Manor
    Hampshire
    United KingdomBritishCompany Director222848510001
    EDGE, Geoffrey
    Spindlewood
    Dog Kennel Hill Kiveton Park Station
    S26 6NG Sheffield
    South Yorkshire
    Secrétaire
    Spindlewood
    Dog Kennel Hill Kiveton Park Station
    S26 6NG Sheffield
    South Yorkshire
    British2055530001
    LEIGHTON, Iain Gordon Kerr
    71 Rectory Grove
    Clapham Common
    SW4 0DS London
    Secrétaire
    71 Rectory Grove
    Clapham Common
    SW4 0DS London
    British42841660001
    VINE, Sylvia Elizabeth Faith
    Struan 65 Bell Hill
    GU32 2EA Petersfield
    Hampshire
    Secrétaire
    Struan 65 Bell Hill
    GU32 2EA Petersfield
    Hampshire
    British3801050001
    ASHER, Kenneth Robert
    Chemring House 1500 Parkway
    Whiteley
    PO15 7AF Fareham
    Hampshire
    Administrateur
    Chemring House 1500 Parkway
    Whiteley
    PO15 7AF Fareham
    Hampshire
    United KingdomBritishFinance Director121877530001
    AVERY, John Leonard
    Chemring House 1500 Parkway
    Whiteley
    PO15 7AF Fareham
    Hampshire
    Administrateur
    Chemring House 1500 Parkway
    Whiteley
    PO15 7AF Fareham
    Hampshire
    United KingdomBritishCompany Director82512570001
    BILLINGTON, Philip Gordon
    25 Carbis Close
    Port Solent Cosham
    PO6 4TW Portsmouth
    Hampshire
    Administrateur
    25 Carbis Close
    Port Solent Cosham
    PO6 4TW Portsmouth
    Hampshire
    BritishChairman18247670001
    BOWERS, Steven John
    Old Salisbury Lane
    SO51 0ZN Romsey
    Roke Manor
    Hampshire
    United Kingdom
    Administrateur
    Old Salisbury Lane
    SO51 0ZN Romsey
    Roke Manor
    Hampshire
    United Kingdom
    United KingdomBritishGroup Finance Director176189250001
    CLEARY, Michael John
    22 Main Road
    Naphill
    HP14 4QB High Wycombe
    Buckinghamshire
    Administrateur
    22 Main Road
    Naphill
    HP14 4QB High Wycombe
    Buckinghamshire
    BritishDirector1525670001
    DERBYSHIRE, Peter Walter
    Red Post Farm
    Red Post Lane
    SP11 8DA Andover
    Hants
    Administrateur
    Red Post Farm
    Red Post Lane
    SP11 8DA Andover
    Hants
    BritishManager31574890001
    EVANS, David Roger
    Yoxhall Lodge
    10 Worsley Road
    PO5 3DY Southsea
    Hampshire
    Administrateur
    Yoxhall Lodge
    10 Worsley Road
    PO5 3DY Southsea
    Hampshire
    EnglandBritishChief Executive4471420003
    FLOWERS, Michael James
    Old Salisbury Lane
    SO51 0LZ Romsey
    Roke Manor
    Hampshire
    United Kingdom
    Administrateur
    Old Salisbury Lane
    SO51 0LZ Romsey
    Roke Manor
    Hampshire
    United Kingdom
    United KingdomAustralianCompany Director188873370002
    GIBBS, Raymond John
    Bridge House
    7 Uxbridge Close
    SO31 7LP Sarisbury Soton
    Hampshire
    Administrateur
    Bridge House
    7 Uxbridge Close
    SO31 7LP Sarisbury Soton
    Hampshire
    BritishFinance Director & Company Sec85421380001
    HAYTER, Timothy William
    7 Salters Acres
    Stockbridge Road
    SO22 5JW Winchester
    Administrateur
    7 Salters Acres
    Stockbridge Road
    SO22 5JW Winchester
    BritishChief Operating Officer78917440003
    HELLYAR, Stuart Thomas
    1500 Parkway
    Whiteley
    PO15 7AF Fareham
    Chemring House
    Hampshire
    United Kingdom
    Administrateur
    1500 Parkway
    Whiteley
    PO15 7AF Fareham
    Chemring House
    Hampshire
    United Kingdom
    United KingdomBritishFinancial Controller109868650001
    HELME, Michael John
    1500 Parkway
    Whiteley
    PO15 7AF Fareham
    Chemring House
    Hampshire
    United Kingdom
    Administrateur
    1500 Parkway
    Whiteley
    PO15 7AF Fareham
    Chemring House
    Hampshire
    United Kingdom
    EnglandBritishProfessional Engineer91910030002
    HILL, Robert Seamus
    Heathwood 6 Ranvilles Lane
    PO14 3DS Fareham
    Hampshire
    Administrateur
    Heathwood 6 Ranvilles Lane
    PO14 3DS Fareham
    Hampshire
    EnglandBritishManagin Director59194350001
    HOFFMAN, Christopher Paul
    20 Hispano Avenue
    Whiteley
    PO15 7DS Fareham
    Hampshire
    Administrateur
    20 Hispano Avenue
    Whiteley
    PO15 7DS Fareham
    Hampshire
    BritishTechnical Director67353960001
    JAMES, Ben Luke
    Chemring House 1500 Parkway
    Whiteley
    PO15 7AF Fareham
    Hampshire
    Administrateur
    Chemring House 1500 Parkway
    Whiteley
    PO15 7AF Fareham
    Hampshire
    United KingdomBritishAccountant136637830001
    LYNN, John James
    House On The Corner
    Cricklade Street, Poulton
    GL7 5HW Cirencester
    Gloucestershire
    Administrateur
    House On The Corner
    Cricklade Street, Poulton
    GL7 5HW Cirencester
    Gloucestershire
    BritishManaging Director69883500001
    MULLINS, Gary
    8c Langstone Avenue
    PO9 1RU Havants
    Hampshire
    Administrateur
    8c Langstone Avenue
    PO9 1RU Havants
    Hampshire
    EnglandBritishBusiness Director Marine Produ102753040001
    PAPWORTH, Mark Harry
    Old Salisbury Lane
    SO51 0ZN Romsey
    Roke Manor
    Hampshire
    United Kingdom
    Administrateur
    Old Salisbury Lane
    SO51 0ZN Romsey
    Roke Manor
    Hampshire
    United Kingdom
    EnglandBritishChief Executive103085690002
    PRICE, David John
    1500 Parkway
    Whiteley
    PO15 7AF Fareham
    Chemring House
    Hampshire
    United Kingdom
    Administrateur
    1500 Parkway
    Whiteley
    PO15 7AF Fareham
    Chemring House
    Hampshire
    United Kingdom
    United KingdomBritishChief Executive75259760004
    RAYNER, Paul Adrian
    1500 Parkway
    Whiteley
    PO15 7AF Fareham
    Chemring House
    Hampshire
    United Kingdom
    Administrateur
    1500 Parkway
    Whiteley
    PO15 7AF Fareham
    Chemring House
    Hampshire
    United Kingdom
    United KingdomBritishFinance Director45628680002
    SMITH, Brian John
    Haystacks 2 St Albans Close
    Bishopdown Farm
    SP1 3FN Salisbury
    Wiltshire
    Administrateur
    Haystacks 2 St Albans Close
    Bishopdown Farm
    SP1 3FN Salisbury
    Wiltshire
    BritishManager57938750001
    WHITEHORN, Justin Michael
    Lower Farm House
    Upper Milton Milton Under Wychwood
    OX7 6EX Chipping Norton
    Oxfordshire
    Administrateur
    Lower Farm House
    Upper Milton Milton Under Wychwood
    OX7 6EX Chipping Norton
    Oxfordshire
    EnglandBritishDirector42825970001
    WILLINGHAM, Geoffrey Charles
    64 New Forest Drive
    SO42 7QW Brockenhurst
    Hampshire
    Administrateur
    64 New Forest Drive
    SO42 7QW Brockenhurst
    Hampshire
    BritishManager31574880001

    Qui sont les personnes ayant un contrôle significatif sur CHEMRING EUROPE LIMITED ?

    Personnes ayant un contrôle significatif
    NomNotifié leAdresseCessé
    Old Salisbury Lane
    SO51 0ZN Romsey
    Roke Manor
    Hampshire
    United Kingdom
    30 juin 2016
    Old Salisbury Lane
    SO51 0ZN Romsey
    Roke Manor
    Hampshire
    United Kingdom
    Non
    Forme juridiquePublic Limited Company
    Pays d'enregistrementUnited Kingdom
    Autorité légaleUnited Kingdom
    Lieu d'enregistrementCompanies House
    Numéro d'enregistrement86662
    Nature du contrôle
    • La personne détient, directement ou indirectement, plus de 75 % des actions de la société.
    • La personne détient, directement ou indirectement, plus de 75 % des droits de vote dans la société.
    • La personne détient, directement ou indirectement, le droit de nommer ou de révoquer une majorité des membres du conseil d'administration de la société.

    CHEMRING EUROPE LIMITED a-t-elle des charges ?

    Charges
    ClassificationDatesStatutDétails
    Debenture
    Créé le 24 sept. 2010
    Livré le 13 oct. 2010
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the obligors to any secured party on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    Personnes ayant droit
    • Bank of Scotland PLC (The Security Agent)
    Transactions
    • 13 oct. 2010Enregistrement d'une charge (MG01)
    • 18 janv. 2011Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (MG02)
    Guarantee & debenture
    Créé le 19 nov. 2009
    Livré le 30 nov. 2009
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the chargors to any of the secured parties on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    Personnes ayant droit
    • Bank of Scotland PLC
    Transactions
    • 30 nov. 2009Enregistrement d'une charge (MG01)
    • 18 janv. 2011Déclaration que tout ou partie de la propriété grevée a été libérée (MG04)
    • 15 sept. 2017Satisfaction d'une charge (MR04)
    Guarantee & debenture
    Créé le 12 nov. 2007
    Livré le 20 nov. 2007
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the chargors to any of the secured parties on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Bank of Scotland PLC (As Security Trustee for the Noteholders and the Purchasers)
    Transactions
    • 20 nov. 2007Enregistrement d'une charge (395)
    • 18 janv. 2011Déclaration que tout ou partie de la propriété grevée a été libérée (MG04)
    • 15 sept. 2017Satisfaction d'une charge (MR04)
    Guarantee & debenture
    Créé le 05 févr. 2001
    Livré le 14 févr. 2001
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All obligations and liabilities due or to become due from the obligors to the chargee under or pursuant to the financing documents (all terms defined therein)
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personnes ayant droit
    • The Royal Bank of Scotland PLC as Agent and Trustee for the Secured Parties
    Transactions
    • 14 févr. 2001Enregistrement d'une charge (395)
    • 18 janv. 2011Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (MG02)
    Mortgage debenture
    Créé le 22 déc. 1997
    Livré le 02 janv. 1998
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    A specific equitable charge over all freehold and leasehold properties and/or the proceeds of sale thereof fixed and floating charges over undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts and the benefits of any licences.
    Personnes ayant droit
    • National Westminster Bank PLC
    Transactions
    • 02 janv. 1998Enregistrement d'une charge (395)
    • 09 févr. 2001Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Charge over book debts
    Créé le 06 déc. 1994
    Livré le 14 déc. 1994
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    A specific charge over the benefit of all book debts and other debts due or owing to the company but so that the company shall pay into the company's account with the bank all monies which it may receive in respect of such debts. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • National Westminster Bank PLC
    Transactions
    • 14 déc. 1994Enregistrement d'une charge (395)
    • 09 févr. 2001Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Charge
    Créé le 29 avr. 1993
    Livré le 06 mai 1993
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Fixed charge on all goodwill and uncalled capital for the time being of the company; and all patents patent applications inventions trade marks trade names etc.
    Personnes ayant droit
    • Midland Bank PLC
    Transactions
    • 06 mai 1993Enregistrement d'une charge (395)
    • 15 mars 1995Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Fixed and floating charge
    Créé le 19 oct. 1990
    Livré le 05 nov. 1990
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Fixed charge over all book debts & other debts owing to the company floating charge over the undertaking and all property and assets present and future including book debts (excluding uncalled capital those mentioned above).
    Personnes ayant droit
    • Midland Bank PLC
    Transactions
    • 05 nov. 1990Enregistrement d'une charge
    • 15 mars 1995Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Debenture
    Créé le 19 oct. 1990
    Livré le 05 nov. 1990
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personnes ayant droit
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transactions
    • 05 nov. 1990Enregistrement d'une charge
    • 15 mars 1995Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)

    Source de données

    • Companies House du Royaume-Uni
      Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers.
    • Licence: CC0