ANV SYNDICATE MANAGEMENT LIMITED
Vue d'ensemble
| Nom de la société | ANV SYNDICATE MANAGEMENT LIMITED |
|---|---|
| Statut de la société | Dissoute |
| Forme juridique | Société à responsabilité limitée |
| Numéro de société | 00747594 |
| Juridiction | Angleterre/Pays de Galles |
| Date de création | |
| Date de cessation d'activité |
Résumé
| A des PSCs super sécurisés | Non |
|---|---|
| A des charges | Oui |
| A un historique d'insolvabilité | Non |
| Le siège social est contesté | Non |
Où se situe ANV SYNDICATE MANAGEMENT LIMITED ?
| Adresse du siège social | Exchequer Court 33 St Mary Axe EC3A 8AA London England |
|---|---|
| Adresse du siège social non livrable | Non |
Quels sont les derniers comptes de ANV SYNDICATE MANAGEMENT LIMITED ?
| Derniers comptes | |
|---|---|
| Derniers comptes arrêtés au | 31 déc. 2018 |
Quels sont les derniers dépôts pour ANV SYNDICATE MANAGEMENT LIMITED ?
| Date | Description | Document | Type | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bulletin officiel final dissous par radiation volontaire | 1 pages | GAZ2(A) | ||||||||||
Premier avis au Bulletin officiel pour la radiation volontaire | 1 pages | GAZ1(A) | ||||||||||
Demande de radiation de la société du registre du commerce | 1 pages | DS01 | ||||||||||
Déclaration de confirmation établie le 04 avr. 2020 sans mise à jour | 3 pages | CS01 | ||||||||||
Nomination de Mr Peter Dewey en tant qu'administrateur le 31 déc. 2019 | 2 pages | AP01 | ||||||||||
Cessation de la nomination de Nicholas Charles Thoresby Pawson en tant que directeur le 31 déc. 2019 | 1 pages | TM01 | ||||||||||
Nomination de Mr Jeremy Edward Cadle en tant qu'administrateur le 31 déc. 2019 | 2 pages | AP01 | ||||||||||
Cessation de la nomination de James Alexander Haggerston Gadsden Cartwright en tant que directeur le 02 oct. 2019 | 1 pages | TM01 | ||||||||||
Comptes annuels établis au 31 déc. 2018 | 18 pages | AA | ||||||||||
Déclaration de confirmation établie le 04 avr. 2019 sans mise à jour | 3 pages | CS01 | ||||||||||
Changement d'adresse du siège social de 4th Floor 1 Minster Court Mincing Lane London EC3R 7AA à Exchequer Court 33 st Mary Axe London EC3A 8AA le 26 oct. 2018 | 1 pages | AD01 | ||||||||||
Comptes annuels établis au 31 déc. 2017 | 19 pages | AA | ||||||||||
Déclaration de confirmation établie le 04 avr. 2018 sans mise à jour | 3 pages | CS01 | ||||||||||
Nomination de James Alexander Haggerston Gadsden Cartwright en tant qu'administrateur le 04 avr. 2018 | 2 pages | AP01 | ||||||||||
Cessation de la nomination de Janice Marie Hamilton en tant que directeur le 28 mars 2018 | 1 pages | TM01 | ||||||||||
Comptes annuels établis au 31 déc. 2016 | 16 pages | AA | ||||||||||
Déclaration de confirmation établie le 04 avr. 2017 avec mises à jour | 7 pages | CS01 | ||||||||||
Cessation de la nomination de Lynsey Jane Cross en tant que directeur le 25 nov. 2016 | 1 pages | TM01 | ||||||||||
Cessation de la nomination de Andrew Simon Wilson Hall en tant que secrétaire le 25 nov. 2016 | 1 pages | TM02 | ||||||||||
Cessation de la nomination de John Maxell Percy Taylor en tant que directeur le 07 nov. 2016 | 1 pages | TM01 | ||||||||||
Cessation de la nomination de Geradus Maria Van Loon en tant que directeur le 07 nov. 2016 | 1 pages | TM01 | ||||||||||
Cessation de la nomination de Anthony Philip Hulse en tant que directeur le 07 nov. 2016 | 1 pages | TM01 | ||||||||||
Cessation de la nomination de Adam Campbell Barker en tant que directeur le 31 oct. 2016 | 1 pages | TM01 | ||||||||||
Comptes annuels établis au 31 déc. 2015 | 21 pages | AA | ||||||||||
Déclaration annuelle jusqu'au 25 avr. 2016 avec liste complète des actionnaires | 9 pages | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Qui sont les dirigeants de ANV SYNDICATE MANAGEMENT LIMITED ?
| Nom | Nommé le | Date de démission | Rôle | Adresse | Identification de la société | Pays de résidence | Nationalité | Date de naissance | Profession | Numéro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CADLE, Jeremy Edward | Administrateur | 33 St Mary Axe EC3A 8AA London Exchequer Court England | England | British | 121806600001 | |||||
| DEWEY, Peter | Administrateur | 33 St Mary Axe EC3A 8AA London Exchequer Court England | England | British | 190721330001 | |||||
| BARDER, Peter Donald | Secrétaire | 29 East Common AL3 7NG Redbourne Hertfordshire | British | 52783880001 | ||||||
| D'ARCY, Anthony Richard Hugh | Secrétaire | Bourne House 10 Sandrock Hill Road GU10 4NS Farnham Surrey | British | 60023430001 | ||||||
| EGGLESTON, Hugh Patrick | Secrétaire | 9 Cicada Road SW18 2NN London | British | 30892130002 | ||||||
| HALL, Andrew Simon Wilson | Secrétaire | 1 Minster Court Mincing Lane EC3R 7AA London 4th Floor England | 186606190001 | |||||||
| MACDOWALL, Iain Falconer | Secrétaire | 31 Liskeard Gardens Blackheath SE3 0PE London | British | 209471330001 | ||||||
| MCAULEY, David Charles | Secrétaire | 11 Brook Gardens KT2 7ET Kingston Upon Thames Surrey | British | 28731100001 | ||||||
| ALLEN, Leslie Francis | Administrateur | Birch House 35 Birch Lane CM4 9NA Stock Essex | England | British | 74796160001 | |||||
| ARMSTRONG, Philip Anthony Christopher | Administrateur | Prinkle Farm House Prinkle Lane Bodle Street Green BN27 4UD Hailsham East Sussex | England | British | 141228360001 | |||||
| BAK, Andrew Roman | Administrateur | 1 Minster Court Mincing Lane EC3R 7AA London 4th Floor England | England | British | 126790290001 | |||||
| BARDER, John Herbert | Administrateur | Corner Cottage Cedar Road GU22 0JJ Woking Surrey | British | 28045730001 | ||||||
| BARDER, Peter Donald | Administrateur | 29 East Common AL3 7NG Redbourne Hertfordshire | British | 52783880001 | ||||||
| BARDER, Samuel Hugh Leonard | Administrateur | St Johns House RG25 1NW Odiham Hampshire | British | 28045720001 | ||||||
| BARDER, Simon Hugh | Administrateur | Chesters The Street Eversley RG27 0PJ Basingstoke Hampshire | British | 28731110002 | ||||||
| BARKER, Adam Campbell | Administrateur | 1 Minster Court Mincing Lane EC3R 7AA London 4th Floor England | England | British | 62286820001 | |||||
| BARNES, Jonathan David Patrick | Administrateur | 7 Priory Walk SW10 9SP London | British | 65351030001 | ||||||
| BAUGH, Andrew Peter | Administrateur | 17 Blenheim Close CM21 0BE Sawbridgeworth Hertfordshire | England | British | 94103330001 | |||||
| BLOXHAM, William Edward | Administrateur | Wylam Dilly Gallowstree Common RG4 9BX Reading Berkshire | British | 65535180001 | ||||||
| BOLT, Thomas Allen | Administrateur | Flat 7 7 Egerton Place SW3 2EF London | England | American | 50947560004 | |||||
| BROWN, David Arthur | Administrateur | 15 Tuckers Town Road St. George's Waters Edge Hs 02 Bermuda | Bermuda | British | 129491310001 | |||||
| BYRNE, Mark James | Administrateur | 6 Long Lane HS02 Tuckers Town Roughill Bermuda | Bermuda | Irish | 136712110001 | |||||
| CACKETT, John Ronald | Administrateur | 15 South Road ME13 7LR Faversham Kent | British | 15346840001 | ||||||
| CARTWRIGHT, James Alexander Haggerston Gadsden | Administrateur | 33 St Mary Axe EC3A 8AA London Exchequer Court England | England | British | 245125430001 | |||||
| CHEETHAM, Howard James | Administrateur | Little Beeches Cobham Way, East Horsley KT24 5BH Leatherhead Surrey | England | British | 82408420001 | |||||
| CHUBB, Paul Alan | Administrateur | 58 Elmwood Drive KT17 2NN Ewell Surrey | England | British | 78587560001 | |||||
| COLEMAN, Barry | Administrateur | Batchelors Barns Green RH13 7QG Horsham West Sussex | British | 15199730001 | ||||||
| CROSS, Lynsey Jane | Administrateur | 1 Minster Court Mincing Lane EC3R 7AA London 4th Floor England | England | British | 168589940001 | |||||
| D'ARCY, Anthony Richard Hugh | Administrateur | Bourne House 10 Sandrock Hill Road GU10 4NS Farnham Surrey | United Kingdom | British | 60023430001 | |||||
| DZIADZIO, Richard Steven | Administrateur | 1 Minster Court Mincing Lane EC3R 7AA London 4th Floor England | Usa | American | 171618040001 | |||||
| EVANS, Philip George Holt | Administrateur | Marley Edge GU27 3PU Haselmere Surrey | British | 28731140001 | ||||||
| GRIEVES, Karl Geoffrey | Administrateur | 1 Minster Court Mincing Lane EC3R 7AA London 4th Floor England | United Kingdom | British | 114263470003 | |||||
| HALLMAN, Cynthia Louise | Administrateur | 1 Minster Court Mincing Lane EC3R 7AA London 4th Floor England | Canada | Canadian | 159156960001 | |||||
| HAMILTON, Janice Marie | Administrateur | 1 Minster Court Mincing Lane EC3R 7AA London 4th Floor England | England | American | 182129350001 | |||||
| HART, Trevor Frank | Administrateur | 10 Beech Avenue WD7 7DE Radlett Hertfordshire | British | 28731150001 |
Qui sont les personnes ayant un contrôle significatif sur ANV SYNDICATE MANAGEMENT LIMITED ?
| Nom | Notifié le | Adresse | Cessé | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anv Holdings (Uk) Limited | 06 avr. 2016 | Minster Court Mincing Lane, 4th Floor EC3R 7AA London 1 England | Non | ||||||||||
| |||||||||||||
Nature du contrôle
| |||||||||||||
ANV SYNDICATE MANAGEMENT LIMITED a-t-elle des charges ?
| Classification | Dates | Statut | Détails | |
|---|---|---|---|---|
| Rent deposit deed | Créé le 29 juil. 1997 Livré le 31 juil. 1997 | Totalement satisfaite | Montant garanti The performance of the company's obligations due to the chargee under the terms of an underlease dated 29TH july 1997 and/or this rent deposit deed | |
Brèves mentions The rent deposit being £89,397.00 and interest. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
| Deed relating to rent deposit | Créé le 22 juil. 1997 Livré le 07 août 1997 | En cours | Montant garanti The rent reserved by and all other monies due or to become due from the company to the chargee under the lease made 22ND july 1997 | |
Brèves mentions The deposit account in the sole name of the company at national westminster bank PLC holborn circus branch and the deposit sum being the sum of £26,500. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
Source de données
- Companies House du Royaume-Uni
Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers. - Licence: CC0