FAUN ZOELLER (UK) LIMITED

  • Vue d'ensemble
  • Résumé
  • Objet social
  • Adresse
  • Dénominations sociales précédentes
  • Comptes
  • Déclaration de confirmation
  • Dépôts
  • Dirigeants
  • Personnes ayant un contrôle significatif
  • Charges
  • Source de données
  • Vue d'ensemble

    Nom de la sociétéFAUN ZOELLER (UK) LIMITED
    Statut de la sociétéActive
    Forme juridiqueSociété à responsabilité limitée
    Numéro de société 00751804
    JuridictionAngleterre/Pays de Galles
    Date de création

    Résumé

    A des PSCs super sécurisésNon
    A des chargesOui
    A un historique d'insolvabilitéNon
    Le siège social est contestéNon

    Quel est l'objet de FAUN ZOELLER (UK) LIMITED ?

    • Vente d'autres véhicules automobiles (45190) / Commerce de gros et de détail ; réparation de véhicules automobiles et de motocycles
    • Entretien et réparation de véhicules automobiles (45200) / Commerce de gros et de détail ; réparation de véhicules automobiles et de motocycles
    • Activités de conseil en environnement (74901) / Activités spécialisées, scientifiques et techniques

    Où se situe FAUN ZOELLER (UK) LIMITED ?

    Adresse du siège social
    c/o COMPANY SECRETARY
    Units 4 & 5 Colemeadow Road
    Moons Moat North Industrial Estate
    B98 9PB Redditch
    Worcestershire
    Adresse du siège social non livrableNon

    Quels étaient les noms précédents de FAUN ZOELLER (UK) LIMITED ?

    Dénominations sociales précédentes
    Nom de la sociétéDeJusqu'au
    FAUN MUNICIPAL VEHICLES LIMITED01 févr. 199601 févr. 1996
    LAIRD (ANGLESEY) LIMITED28 févr. 196328 févr. 1963

    Quels sont les derniers comptes de FAUN ZOELLER (UK) LIMITED ?

    En retardNon
    Prochains comptes
    Fin de la prochaine période comptable le31 déc. 2024
    Date d'échéance des prochains comptes30 sept. 2025
    Derniers comptes
    Derniers comptes arrêtés au31 déc. 2023

    Quel est le statut de la dernière déclaration de confirmation pour FAUN ZOELLER (UK) LIMITED ?

    Dernière déclaration de confirmation établie jusqu'au28 juin 2025
    Date d'échéance de la prochaine déclaration de confirmation12 juil. 2025
    Dernière déclaration de confirmation
    Prochaine déclaration de confirmation établie jusqu'au28 juin 2024
    En retardNon

    Quels sont les derniers dépôts pour FAUN ZOELLER (UK) LIMITED ?

    Dépôts
    DateDescriptionDocumentType

    Cessation de la nomination de Stewart Ian Gregory en tant que directeur le 30 nov. 2024

    1 pagesTM01

    Comptes annuels établis au 31 déc. 2023

    25 pagesAA

    Déclaration de confirmation établie le 28 juin 2024 sans mise à jour

    3 pagesCS01

    Comptes annuels établis au 31 déc. 2022

    24 pagesAA

    Déclaration de confirmation établie le 28 juin 2023 sans mise à jour

    3 pagesCS01

    Déclaration de confirmation établie le 28 juin 2022 avec mises à jour

    3 pagesCS01

    Comptes annuels établis au 31 déc. 2021

    23 pagesAA

    Déclaration de confirmation établie le 28 juin 2021 sans mise à jour

    3 pagesCS01

    Comptes annuels établis au 31 déc. 2020

    25 pagesAA

    Comptes annuels établis au 31 déc. 2019

    25 pagesAA

    Déclaration de confirmation établie le 28 juin 2020 sans mise à jour

    3 pagesCS01

    Déclaration de confirmation établie le 28 juin 2019 sans mise à jour

    3 pagesCS01

    Comptes annuels établis au 31 déc. 2018

    23 pagesAA

    Satisfaction de la charge 12 en totalité

    1 pagesMR04

    Satisfaction de la charge 7 en totalité

    1 pagesMR04

    Satisfaction de la charge 1 en totalité

    1 pagesMR04

    Satisfaction de la charge 9 en totalité

    2 pagesMR04

    Comptes annuels établis au 31 déc. 2017

    25 pagesAA

    Déclaration de confirmation établie le 28 juin 2018 sans mise à jour

    3 pagesCS01

    Comptes annuels établis au 31 déc. 2016

    26 pagesAA

    Deuxième dépôt pour la notification de Arndt Gunter Kirchhoff en tant que personne disposant d'un contrôle significatif

    7 pagesRP04PSC01

    Déclaration de confirmation établie le 28 juin 2017 sans mise à jour

    3 pagesCS01

    Modification des détails de Johannes Friedrich Kirchoff en tant que personne disposant d'un contrôle significatif le 06 avr. 2016

    2 pagesPSC04

    Notification de Arndt Günter Kirchhoff en tant que personne disposant d'un contrôle significatif le 06 avr. 2016

    3 pagesPSC01
    Annotations
    DateAnnotation
    30 sept. 2017Clarification A SECOND FILED PSC01 WAS REGISTERED ON 30/09/2017

    Notification de Jürgen Wolfgang Kirchhoff en tant que personne disposant d'un contrôle significatif le 06 avr. 2016

    2 pagesPSC01

    Qui sont les dirigeants de FAUN ZOELLER (UK) LIMITED ?

    Dirigeants
    NomNommé leDate de démissionRôleAdresseIdentification de la sociétéPays de résidenceNationalitéDate de naissanceProfessionNuméro
    HORTON, Richard
    c/o Company Secretary
    Colemeadow Road
    Moons Moat North Industrial Estate
    B98 9PB Redditch
    Units 4 & 5
    Worcestershire
    England
    Secrétaire
    c/o Company Secretary
    Colemeadow Road
    Moons Moat North Industrial Estate
    B98 9PB Redditch
    Units 4 & 5
    Worcestershire
    England
    181210180001
    HORTON, Richard Ian
    c/o Company Secretary
    Colemeadow Road
    Moons Moat North Industrial Estate
    B98 9PB Redditch
    Units 4 & 5
    Worcestershire
    Administrateur
    c/o Company Secretary
    Colemeadow Road
    Moons Moat North Industrial Estate
    B98 9PB Redditch
    Units 4 & 5
    Worcestershire
    EnglandBritishFinance Director196340440001
    HYDE, Simon Gretton
    c/o Company Secretary
    Colemeadow Road
    Moons Moat North Industrial Estate
    B98 9PB Redditch
    Units 4 & 5
    Worcestershire
    Administrateur
    c/o Company Secretary
    Colemeadow Road
    Moons Moat North Industrial Estate
    B98 9PB Redditch
    Units 4 & 5
    Worcestershire
    EnglandBritishDirector98901520003
    BALL, Stephen David
    Llangefni
    Isle Of Anglessey
    LL77 7XA
    Secrétaire
    Llangefni
    Isle Of Anglessey
    LL77 7XA
    166252580001
    BROWNING, Roger
    Teilo
    12 Sylva Gardens North
    LL30 1BP Llandudno
    Gwynedd
    Secrétaire
    Teilo
    12 Sylva Gardens North
    LL30 1BP Llandudno
    Gwynedd
    British70339810001
    FARNELL, William
    53 Plas Tudno
    Penrhyn Bay
    LL30 3ER Llandudno
    Gwynedd
    Secrétaire
    53 Plas Tudno
    Penrhyn Bay
    LL30 3ER Llandudno
    Gwynedd
    BritishAccountant46208150002
    FIRTH, Kevin Paul
    20 Cil Y Graig
    LL61 5NZ Llanfairpwllgwyngyll
    Gwynedd
    Secrétaire
    20 Cil Y Graig
    LL61 5NZ Llanfairpwllgwyngyll
    Gwynedd
    British9379930001
    FIRTH, Kevin Paul
    20 Cil Y Graig
    LL61 5NZ Llanfairpwllgwyngyll
    Gwynedd
    Secrétaire
    20 Cil Y Graig
    LL61 5NZ Llanfairpwllgwyngyll
    Gwynedd
    British9379930001
    JONES, John Alun
    10 Bryn Aur
    Gorsedd
    CH8 8RA Holywell
    Flintshire
    Secrétaire
    10 Bryn Aur
    Gorsedd
    CH8 8RA Holywell
    Flintshire
    BritishAccountant31274130002
    PATON, Ian James
    36 Grosvenor Road
    LL19 7NP Prestatyn
    Denbighshire
    Secrétaire
    36 Grosvenor Road
    LL19 7NP Prestatyn
    Denbighshire
    British82539480001
    CORLESS, Andrew
    21 Asturian Gate
    Ribchester
    PR3 3QX Preston
    Lancashire
    Administrateur
    21 Asturian Gate
    Ribchester
    PR3 3QX Preston
    Lancashire
    EnglandBritishManaging Director167835180001
    COWLING, Jeffrey
    Scott Croft
    Grindleton
    BB7 4QR Clitheroe
    Lancashire
    Administrateur
    Scott Croft
    Grindleton
    BB7 4QR Clitheroe
    Lancashire
    BritishEngineer1732400001
    EVANS, Gwynedd Jones, Works Director
    Wynona Esplanade
    LL34 6LY Penmaenmawr
    Gwynedd
    Administrateur
    Wynona Esplanade
    LL34 6LY Penmaenmawr
    Gwynedd
    BritishManaging Director31427340001
    FIRTH, Kevin Paul
    20 Cil Y Graig
    LL61 5NZ Llanfairpwllgwyngyll
    Gwynedd
    Administrateur
    20 Cil Y Graig
    LL61 5NZ Llanfairpwllgwyngyll
    Gwynedd
    BritishCompany Director9379930001
    GARDINER, John Anthony
    125 Sydenham Hill
    SE26 6LW London
    Administrateur
    125 Sydenham Hill
    SE26 6LW London
    BritishCompany Director9380001
    GEORGE, Russell Martin
    35 Pothouse Lane
    Stocksbridge
    S36 1ES Sheffield
    Administrateur
    35 Pothouse Lane
    Stocksbridge
    S36 1ES Sheffield
    EnglandBritishManaging Director56936880001
    GREGORY, Stewart Ian
    c/o Company Secretary
    Colemeadow Road
    Moons Moat North Industrial Estate
    B98 9PB Redditch
    Units 4 & 5
    Worcestershire
    Administrateur
    c/o Company Secretary
    Colemeadow Road
    Moons Moat North Industrial Estate
    B98 9PB Redditch
    Units 4 & 5
    Worcestershire
    WalesBritishCommercial Director232609460001
    HENEY, Geoffrey Frederick
    The Old Yard
    Red Wharf Bay
    LL75 8PZ Pentraeth
    Gwynedd
    Administrateur
    The Old Yard
    Red Wharf Bay
    LL75 8PZ Pentraeth
    Gwynedd
    BritishSales Director68323690001
    JONES, John Alun
    10 Bryn Aur
    Gorsedd
    CH8 8RA Holywell
    Flintshire
    Administrateur
    10 Bryn Aur
    Gorsedd
    CH8 8RA Holywell
    Flintshire
    United KingdomBritishAccountant31274130002
    KIRCHHOFF, Johannes F
    Langerfeldser 55
    D-58638 Iserlohn
    FOREIGN Germany
    Administrateur
    Langerfeldser 55
    D-58638 Iserlohn
    FOREIGN Germany
    GermanEngineer46208230001
    NICOL, John Gair, Engineering Director
    2 Glynne Road
    LL57 1AH Bangor
    Gwynedd
    Administrateur
    2 Glynne Road
    LL57 1AH Bangor
    Gwynedd
    BritishEngineer31427350001
    O'CONNOR, Vincent
    Ysgubor Wen
    Llaniestyn
    LL58 8TN Beaumaris
    Anglesey Gwynedd
    Administrateur
    Ysgubor Wen
    Llaniestyn
    LL58 8TN Beaumaris
    Anglesey Gwynedd
    BritishCompany Director18574110001
    PHILLIMORE, Lyndon
    Bodrwyn
    Cerrigceinwen
    LL62 5DH Bodorgan
    Gwynedd
    Administrateur
    Bodrwyn
    Cerrigceinwen
    LL62 5DH Bodorgan
    Gwynedd
    BritishCompany Director48045930001
    SCHMITZ, Thomas
    c/o Company Secretary
    Colemeadow Road
    Moons Moat North Industrial Estate
    B98 9PB Redditch
    Units 4 & 5
    Worcestershire
    England
    Administrateur
    c/o Company Secretary
    Colemeadow Road
    Moons Moat North Industrial Estate
    B98 9PB Redditch
    Units 4 & 5
    Worcestershire
    England
    GermanyGermanChairman110178810001
    SCHNEIDER, Jochen
    Obere Breitackerstrabe 18
    79761 Waldshut-Tiengen
    Germany
    Administrateur
    Obere Breitackerstrabe 18
    79761 Waldshut-Tiengen
    Germany
    GermanyGermanCo Director125171490001
    STOTT, Alan
    24 Rhiw Road
    Colwyn Bay
    LL29 7TP Conway
    Administrateur
    24 Rhiw Road
    Colwyn Bay
    LL29 7TP Conway
    BritishOperation Director82539550001
    STOWELL, Charles George D'Eyncourt
    Orchard Mews New Street
    LL58 8EL Beaumaris
    Gwynedd
    Administrateur
    Orchard Mews New Street
    LL58 8EL Beaumaris
    Gwynedd
    BritishEngineering11356310001
    VOGEL, Armin, Dr
    Hasenhohl 5
    58640 Iselhorn
    Germany
    Administrateur
    Hasenhohl 5
    58640 Iselhorn
    Germany
    GermanyGermanChairman70339910002

    Qui sont les personnes ayant un contrôle significatif sur FAUN ZOELLER (UK) LIMITED ?

    Personnes ayant un contrôle significatif
    NomNotifié leAdresseCessé
    Jürgen Wolfgang Kirchhoff
    c/o COMPANY SECRETARY
    Colemeadow Road
    Moons Moat North Industrial Estate
    B98 9PB Redditch
    Units 4 & 5
    Worcestershire
    06 avr. 2016
    c/o COMPANY SECRETARY
    Colemeadow Road
    Moons Moat North Industrial Estate
    B98 9PB Redditch
    Units 4 & 5
    Worcestershire
    Non
    Nationalité: German
    Pays de résidence: Germany
    Nature du contrôle
    • La personne détient, directement ou indirectement, plus de 25 % mais pas plus de 50 % des actions de la société.
    Johannes Friedrich Kirchhoff
    c/o COMPANY SECRETARY
    Colemeadow Road
    Moons Moat North Industrial Estate
    B98 9PB Redditch
    Units 4 & 5
    Worcestershire
    06 avr. 2016
    c/o COMPANY SECRETARY
    Colemeadow Road
    Moons Moat North Industrial Estate
    B98 9PB Redditch
    Units 4 & 5
    Worcestershire
    Non
    Nationalité: German
    Pays de résidence: Germany
    Nature du contrôle
    • La personne détient, directement ou indirectement, plus de 25 % mais pas plus de 50 % des actions de la société.
    Arndt Günter Kirchhoff
    c/o COMPANY SECRETARY
    Colemeadow Road
    Moons Moat North Industrial Estate
    B98 9PB Redditch
    Units 4 & 5
    Worcestershire
    06 avr. 2016
    c/o COMPANY SECRETARY
    Colemeadow Road
    Moons Moat North Industrial Estate
    B98 9PB Redditch
    Units 4 & 5
    Worcestershire
    Non
    Nationalité: German
    Pays de résidence: Germany
    Nature du contrôle
    • La personne détient, directement ou indirectement, plus de 25 % mais pas plus de 50 % des actions de la société.

    FAUN ZOELLER (UK) LIMITED a-t-elle des charges ?

    Charges
    ClassificationDatesStatutDétails
    Certificate of assignment
    Créé le 30 juil. 2007
    Livré le 10 août 2007
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    Assigns all monies now or hereafter to become due under the sub-hire agreements,the benefit of all guarantees indemnities negotiable instruments and securities. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transactions
    • 10 août 2007Enregistrement d'une charge (395)
    • 25 juil. 2014Satisfaction d'une charge (MR04)
    Rent deposit deed
    Créé le 11 sept. 2003
    Livré le 24 sept. 2003
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    £22,000 due or to become due from the company to the chargee
    Brèves mentions
    The company's interest in the deposit account and all money from time to time withdrawn from it in accordance with the rent deposit deed.
    Personnes ayant droit
    • Wattlid Limited
    Transactions
    • 24 sept. 2003Enregistrement d'une charge (395)
    • 24 juin 2019Satisfaction d'une charge (MR04)
    Legal mortgage
    Créé le 30 août 2002
    Livré le 04 sept. 2002
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    The property known as unit 4, bryn cefni industrial estate, llangefni, anglesey by way of fixed equitable charge the goodwill of any business; floating charge all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment and other chattel assets.
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transactions
    • 04 sept. 2002Enregistrement d'une charge (395)
    • 29 août 2014Satisfaction d'une charge (MR04)
    Debenture
    Créé le 30 août 2002
    Livré le 04 sept. 2002
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transactions
    • 04 sept. 2002Enregistrement d'une charge (395)
    • 30 déc. 2014Satisfaction d'une charge (MR04)
    Rent deposit deed
    Créé le 11 juin 2002
    Livré le 14 juin 2002
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    The sum of £21,150.00 deposited with the chargee and all monies from time to time deducted therefrom in accordance with the deed together with any additional sum or sums required to be paid pursuant to the terms of the deed to ensure that the amount of £21,150.00 is held by the chargee at all times.
    Personnes ayant droit
    • Lionbrook Property Partnership Nominee No 1 Limited
    Transactions
    • 14 juin 2002Enregistrement d'une charge (395)
    • 24 juin 2019Satisfaction d'une charge (MR04)
    Assignment and charge of sub-leasing agreements
    Créé le 05 avr. 2001
    Livré le 25 avr. 2001
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee under any chattel mortgage
    Brèves mentions
    All rights title and interest of the company in sub leases made or to be made by the company in respect of goods comprised in hp leasing or hire agreements made or to be made between the chargee and the company. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Barclays Mercantile Business Finance Limited
    Transactions
    • 25 avr. 2001Enregistrement d'une charge (395)
    • 05 sept. 2014Satisfaction d'une charge (MR04)
    Security deposit agreement
    Créé le 05 mai 2000
    Livré le 10 mai 2000
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    The sum of £17,625.00 due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever pursuant to the terms of the lease of even date
    Brèves mentions
    Factory unit bt.500/23 Shaw lane industrial estate, doncaster, south yorkshire.
    Personnes ayant droit
    • Priority Sites Investments Limited
    Transactions
    • 10 mai 2000Enregistrement d'une charge (395)
    • 24 juin 2019Satisfaction d'une charge (MR04)
    Debenture
    Créé le 28 août 1998
    Livré le 04 sept. 1998
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personnes ayant droit
    • Barclays Bank PLC
    Transactions
    • 04 sept. 1998Enregistrement d'une charge (395)
    • 17 oct. 2002Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Legal charge
    Créé le 22 déc. 1997
    Livré le 29 déc. 1997
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee under or pursuant to a deed of covenant dated 22ND december 1997
    Brèves mentions
    F/H unit 4 bryn lefni industrial estate llangefni t/n-WA668992.
    Personnes ayant droit
    • The Welsh Development Agency
    Transactions
    • 29 déc. 1997Enregistrement d'une charge (395)
    • 17 oct. 2002Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Legal charge
    Créé le 05 déc. 1997
    Livré le 12 déc. 1997
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    £646,250 due or to become due from the company to the chargee
    Brèves mentions
    Land comprised in unit 4 bryn cefni industrial estate, llangefni, anglesey together with all buildings thereon and all additions thereto and all fixtures and fittings in or upon the property.
    Personnes ayant droit
    • Watkin Jones (Holdings) Limited
    Transactions
    • 12 déc. 1997Enregistrement d'une charge (395)
    • 22 juin 2006Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Legal mortgage
    Créé le 05 déc. 1997
    Livré le 12 déc. 1997
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Unit 4 bryn cefni ind est llangefni anglesay north wales (but excluding 4 x street overhead gantry cranes (6 tonnes each) and others as described), fixed equitable charge the goodwill of any business,. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Personnes ayant droit
    • Bank of Wales PLC
    Transactions
    • 12 déc. 1997Enregistrement d'une charge (395)
    • 11 mars 2004Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Debenture
    Créé le 05 déc. 1997
    Livré le 12 déc. 1997
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    .. fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Midland Bank PLC
    Transactions
    • 12 déc. 1997Enregistrement d'une charge (395)
    • 25 avr. 1998Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Rent deposit deed
    Créé le 19 août 1997
    Livré le 28 août 1997
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    £18,310 due or to become due from the company to the chargee
    Brèves mentions
    The interest of faun municipal vehicles limited in the deposit sum of £18,310.00.
    Personnes ayant droit
    • The London County Freehold and Leasehold Properties Limited
    Transactions
    • 28 août 1997Enregistrement d'une charge (395)
    • 24 juin 2019Satisfaction d'une charge (MR04)

    Source de données

    • Companies House du Royaume-Uni
      Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers.
    • Licence: CC0