BOWENS INTERNATIONAL LIMITED

BOWENS INTERNATIONAL LIMITED

  • Vue d'ensemble
  • Résumé
  • Objet social
  • Adresse
  • Dénominations sociales précédentes
  • Comptes
  • Dépôts
  • Dirigeants
  • Personnes ayant un contrôle significatif
  • Charges
  • Insolvabilité
  • Source de données
  • Vue d'ensemble

    Nom de la sociétéBOWENS INTERNATIONAL LIMITED
    Statut de la sociétéDissoute
    Forme juridiqueSociété à responsabilité limitée
    Numéro de société 00754171
    JuridictionAngleterre/Pays de Galles
    Date de création
    Date de cessation d'activité

    Résumé

    A des PSCs super sécurisésNon
    A des chargesOui
    A un historique d'insolvabilitéOui
    Le siège social est contestéNon

    Quel est l'objet de BOWENS INTERNATIONAL LIMITED ?

    • fabrication d'équipements d'éclairage électrique (27400) / Industries manufacturières

    Où se situe BOWENS INTERNATIONAL LIMITED ?

    Adresse du siège social
    25 Farringdon Street
    EC4A 4AB London
    Adresse du siège social non livrableNon

    Quels étaient les noms précédents de BOWENS INTERNATIONAL LIMITED ?

    Dénominations sociales précédentes
    Nom de la sociétéDeJusqu'au
    BOWEN'S SALES & SERVICE LIMITED 21 mars 196321 mars 1963

    Quels sont les derniers comptes de BOWENS INTERNATIONAL LIMITED ?

    Derniers comptes
    Derniers comptes arrêtés au31 déc. 2015

    Quels sont les derniers dépôts pour BOWENS INTERNATIONAL LIMITED ?

    Dépôts
    DateDescriptionDocumentType

    Gazette finale dissoute à la suite d'une liquidation

    1 pagesGAZ2

    Retour de la réunion finale dans une liquidation volontaire des créanciers

    17 pagesLIQ14

    Déclaration des reçus et paiements des liquidateurs jusqu'à 15 août 2019

    19 pagesLIQ03

    Résolutions

    Resolutions
    1 pagesRESOLUTIONS
    Résolutions
    CatégorieDateDescriptionType
    liquidation

    Résolution extraordinaire pour la liquidation au 16 août 2017

    LRESEX

    Déclaration des reçus et paiements des liquidateurs jusqu'à 15 août 2018

    21 pagesLIQ03

    Avis au Registre du commerce et des sociétés de l'avis de désistement

    5 pagesNDISC

    Avis au Registre du commerce et des sociétés de l'avis de désistement

    5 pagesNDISC

    Avis au Registre du commerce et des sociétés de l'avis de désistement

    5 pagesNDISC

    Avis au Registre du commerce et des sociétés de l'avis de désistement

    5 pagesNDISC

    Avis au Registre du commerce et des sociétés de l'avis de désistement

    5 pagesNDISC

    Avis au Registre du commerce et des sociétés de l'avis de désistement

    5 pagesNDISC

    Avis au Registre du commerce et des sociétés de l'avis de désistement

    4 pagesNDISC

    Avis au Registre du commerce et des sociétés de l'avis de désistement

    5 pagesNDISC

    Satisfaction de la charge 007541710010 en totalité

    1 pagesMR04

    Satisfaction de la charge 007541710009 en totalité

    1 pagesMR04

    Avis au Registre du commerce et des sociétés de l'avis de désistement

    4 pagesNDISC

    Constitution du comité des créanciers ou du comité de liquidation

    7 pagesCOM1

    Changement d'adresse du siège social de Unit 6 Gilberd Court Colchester Essex CO4 9WN à 25 Farringdon Street London EC4A 4AB le 11 sept. 2017

    2 pagesAD01

    Déclaration des affaires

    12 pagesLIQ02

    Nomination d'un liquidateur volontaire

    2 pages600

    Notification de Friedrich Trautwein en tant que personne disposant d'un contrôle significatif le 21 juin 2017

    2 pagesPSC01

    Cessation de Joerg Dockendorf en tant que personne disposant d'un contrôle significatif le 21 juin 2017

    1 pagesPSC07

    Cessation de la nomination de Joerg Dockendorf en tant que directeur le 21 juin 2017

    1 pagesTM01

    Nomination de Dr Friedrich Trautwein en tant qu'administrateur le 21 juin 2017

    2 pagesAP01

    Cessation de la nomination de Andreas Schaefer en tant que directeur le 31 mai 2017

    1 pagesTM01

    Qui sont les dirigeants de BOWENS INTERNATIONAL LIMITED ?

    Dirigeants
    NomNommé leDate de démissionRôleAdresseIdentification de la sociétéPays de résidenceNationalitéDate de naissanceProfessionNuméro
    CROSSMAN, Darren Paul
    Farringdon Street
    EC4A 4AB London
    25
    Secrétaire
    Farringdon Street
    EC4A 4AB London
    25
    232291280001
    TRAUTWEIN, Friedrich
    Farringdon Street
    EC4A 4AB London
    25
    Administrateur
    Farringdon Street
    EC4A 4AB London
    25
    GermanyGermanConsultant217953420001
    BALFOUR, Matthew Philip
    70 Reeds Way
    IP14 4BP Stowmarket
    Suffolk
    Secrétaire
    70 Reeds Way
    IP14 4BP Stowmarket
    Suffolk
    British111392770001
    CUNNINGHAM, Anthony Gerald
    Cleeve House
    Weathercock Lane
    MK17 8NP Woburn Sands
    Bedfordshire
    Secrétaire
    Cleeve House
    Weathercock Lane
    MK17 8NP Woburn Sands
    Bedfordshire
    British11015530001
    SMITH, Laura
    355 Old Road
    Clacton On Sea
    CO15 3RH Essex
    Secrétaire
    355 Old Road
    Clacton On Sea
    CO15 3RH Essex
    BritishAccountant106919760003
    SPENCER, Jane-Anne
    Gilberd Court
    CO4 9WN Colchester
    Unit 6
    Essex
    England
    Secrétaire
    Gilberd Court
    CO4 9WN Colchester
    Unit 6
    Essex
    England
    186389620001
    TAYLOR, Michael
    Chapel House
    Croquet Gardens, Wivenhoe
    CO7 9PQ Colchester
    Essex
    Secrétaire
    Chapel House
    Croquet Gardens, Wivenhoe
    CO7 9PQ Colchester
    Essex
    BritishDirector65518110001
    WYER, Christopher Mark
    Horseshoe Cottage Upper Street
    Layham
    IP7 5JZ Ipswich
    Suffolk
    Secrétaire
    Horseshoe Cottage Upper Street
    Layham
    IP7 5JZ Ipswich
    Suffolk
    BritishCompany Director / Fin Director22722950001
    AHERNE, Mark
    The Tudors
    The Street
    CO11 1PH Brantham
    Essex
    Administrateur
    The Tudors
    The Street
    CO11 1PH Brantham
    Essex
    United KingdomBritishTechnical Director168880580001
    ALLWRIGHT, John Arthur Reginald
    Jaggards
    Rectory Road
    CO16 9BN Weeley Heath
    Essex
    Administrateur
    Jaggards
    Rectory Road
    CO16 9BN Weeley Heath
    Essex
    BritishCompany Director124042040001
    BALDWIN, Clifford
    32 Kings Road
    CO15 1BA Clacton On Sea
    Essex
    Administrateur
    32 Kings Road
    CO15 1BA Clacton On Sea
    Essex
    BritishProduction Director20200410001
    BROCK, Christiane
    Gilberd Court
    CO4 9WN Colchester
    Unit 6
    Essex
    Administrateur
    Gilberd Court
    CO4 9WN Colchester
    Unit 6
    Essex
    GermanyGermanCompany Director205247180001
    BUTTERY, Philip John
    108 Beach Road
    Sand Bay
    BS22 9UG Weston Super Mare
    Somerset
    Administrateur
    108 Beach Road
    Sand Bay
    BS22 9UG Weston Super Mare
    Somerset
    BritishCompany Director81865760001
    CLARK, Joe
    355 Old Road
    Clacton On Sea
    CO15 3RH Essex
    Administrateur
    355 Old Road
    Clacton On Sea
    CO15 3RH Essex
    EnglandScottishDirector148399370001
    CUNNINGHAM, Anthony Gerald
    Cleeve House
    Weathercock Lane
    MK17 8NP Woburn Sands
    Bedfordshire
    Administrateur
    Cleeve House
    Weathercock Lane
    MK17 8NP Woburn Sands
    Bedfordshire
    BritishCompany Director11015530001
    DOCKENDORF, Joerg, Dr
    Gilberd Court, Newcomen Way
    Severalls Industrial Park
    CO4 9WN Colchester
    Unit 6 Gilberd Court
    Essex
    England
    Administrateur
    Gilberd Court, Newcomen Way
    Severalls Industrial Park
    CO4 9WN Colchester
    Unit 6 Gilberd Court
    Essex
    England
    GermanyGermanCompany Director217356320001
    DREW, David Keith
    1037 North Elmwood Avenue
    Oak Park
    Illinois 60302
    Usa
    Administrateur
    1037 North Elmwood Avenue
    Oak Park
    Illinois 60302
    Usa
    UsaUsaDirector75587810001
    FISCHER, Andrew Olaf
    355 Old Road
    Clacton On Sea
    CO15 3RH Essex
    Administrateur
    355 Old Road
    Clacton On Sea
    CO15 3RH Essex
    United KingdomGermanCompany Director70312740036
    FISHER, Ian
    355 Old Road
    Clacton On Sea
    CO15 3RH Essex
    Administrateur
    355 Old Road
    Clacton On Sea
    CO15 3RH Essex
    United KingdomBritishCompany Director51776160030
    FLETCHER, Alan Thomas
    355 Old Road
    Clacton On Sea
    CO15 3RH Essex
    Administrateur
    355 Old Road
    Clacton On Sea
    CO15 3RH Essex
    United KingdomBritishCompany Director14669590002
    GOBBI, John Francis
    Gilberd Court
    CO4 9WN Colchester
    Unit 6
    Essex
    England
    Administrateur
    Gilberd Court
    CO4 9WN Colchester
    Unit 6
    Essex
    England
    EnglandEnglishManaging Director65362260005
    HALPERN, Colin
    Gilberd Court
    CO4 9WN Colchester
    Unit 6
    Essex
    England
    Administrateur
    Gilberd Court
    CO4 9WN Colchester
    Unit 6
    Essex
    England
    United StatesAmericanDirector112008300001
    HOUDE, Kathryn
    1453 South Shore Court
    60010 Barrington
    Illinois
    Us
    Administrateur
    1453 South Shore Court
    60010 Barrington
    Illinois
    Us
    UsaManager39410150001
    HUMPHRIES, Ian Ellis
    149 Wendover Road
    HP21 9NL Aylesbury
    Buckinghamshire
    Administrateur
    149 Wendover Road
    HP21 9NL Aylesbury
    Buckinghamshire
    EnglandBritishDirector109002350001
    LOUDEN, Peter Anthony
    Old Timbers Harwich Road
    Beaumont-Cum-Moze
    Essex
    Administrateur
    Old Timbers Harwich Road
    Beaumont-Cum-Moze
    Essex
    BritishTechnical Director6474240001
    RICHARDSON, Jonathan Charles
    355 Old Road
    Clacton On Sea
    CO15 3RH Essex
    Administrateur
    355 Old Road
    Clacton On Sea
    CO15 3RH Essex
    EnglandBritishDirector118293300001
    ROBERTS, Emerson
    Gilberd Court
    CO4 9WN Colchester
    Unit 6
    Essex
    England
    Administrateur
    Gilberd Court
    CO4 9WN Colchester
    Unit 6
    Essex
    England
    EnglandBritishManaging Director180431490001
    SCHAEFER, Andreas
    Gilberd Court, Newcomen Way
    Severalls Industrial Park
    CO4 9WN Colchester
    Unit 6 Gilberd Court
    England
    Administrateur
    Gilberd Court, Newcomen Way
    Severalls Industrial Park
    CO4 9WN Colchester
    Unit 6 Gilberd Court
    England
    GermanyGermanCompany Director208882220001
    SMITH, Stephen Anthony
    The Tudor House
    Week St Mary
    EX22 6UL Holsworthy
    Administrateur
    The Tudor House
    Week St Mary
    EX22 6UL Holsworthy
    United KingdomBritishDirector6780200002
    TAYLOR, Michael
    Old Road
    CO15 3RH Clacton On Sea
    355
    Essex
    Administrateur
    Old Road
    CO15 3RH Clacton On Sea
    355
    Essex
    EnglandBritishDirector65518110001
    URGO, Christopher John
    355 Old Road
    Clacton On Sea
    CO15 3RH Essex
    Administrateur
    355 Old Road
    Clacton On Sea
    CO15 3RH Essex
    UsaAmericanCfo159423310001
    VELEMA, Albert
    Prinses Beatrixlaan 1
    8051 Pg Hattem
    Netherlands
    Administrateur
    Prinses Beatrixlaan 1
    8051 Pg Hattem
    Netherlands
    DutchDirector49107800001
    WADE, Robert Ian
    68 Eldred Drive
    Great Cornard
    CO10 0YZ Sudbury
    Suffolk
    Administrateur
    68 Eldred Drive
    Great Cornard
    CO10 0YZ Sudbury
    Suffolk
    BritishDirector52630500001
    WHITING, Jon Alfred
    6 Shardeloes
    HP7 0RL Amersham
    Buckinghamshire
    Administrateur
    6 Shardeloes
    HP7 0RL Amersham
    Buckinghamshire
    BritishCompany Director25447590001
    WYER, Christopher Mark
    Horseshoe Cottage Upper Street
    Layham
    IP7 5JZ Ipswich
    Suffolk
    Administrateur
    Horseshoe Cottage Upper Street
    Layham
    IP7 5JZ Ipswich
    Suffolk
    BritishFinancial Director22722950001

    Qui sont les personnes ayant un contrôle significatif sur BOWENS INTERNATIONAL LIMITED ?

    Personnes ayant un contrôle significatif
    NomNotifié leAdresseCessé
    Mr Friedrich Trautwein
    Farringdon Street
    EC4A 4AB London
    25
    21 juin 2017
    Farringdon Street
    EC4A 4AB London
    25
    Non
    Nationalité: German
    Pays de résidence: Germany
    Nature du contrôle
    • La personne a le droit d'exercer, ou exerce effectivement, une influence ou un contrôle significatif sur la société.
    Dr Joerg Dockendorf
    Gilberd Court
    CO4 9WN Colchester
    Unit 6
    Essex
    18 oct. 2016
    Gilberd Court
    CO4 9WN Colchester
    Unit 6
    Essex
    Oui
    Nationalité: German
    Pays de résidence: Germany
    Nature du contrôle
    • La personne a le droit d'exercer, ou exerce effectivement, une influence ou un contrôle significatif sur la société.

    BOWENS INTERNATIONAL LIMITED a-t-elle des charges ?

    Charges
    ClassificationDatesStatutDétails
    A registered charge
    Créé le 17 juin 2016
    Livré le 29 juin 2016
    En cours
    Contient une promesse négative: Oui
    Contient une charge fixe: Oui
    Personnes ayant droit
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transactions
    • 29 juin 2016Enregistrement d'une charge (MR01)
    A registered charge
    Créé le 06 juin 2016
    Livré le 06 juin 2016
    Totalement satisfaite
    Brève description
    Each security obligor charges and agrees to charge all of its present and future right, title and interest in and to the following assets which are at any time owned by it, or in which it from time to time has an interest:. (A) by way of first legal mortgage the specified real property;. (B) by way of first fixed charge:. (I) all real property and all interests in real property not charged by clause 5.1(a);. (Ii) all licences to enter upon or us land and the benefit of all other agreements relating to land; and. (Iii) the proceeds of sale of all real property other than specified real property;. (C) by way of first fixed charge the intellectual property (if any) specified in part 4 of schedule 3 (details of security assets);. (D) by way of first fixed charge all intellectual property (if any) not charged by clause 5.1(q).. "Specified real property" means the estates and interests in freehold, leasehold and other immovable property (if any) specified in part 1 of schedule 3 (details of security assets), together with:. (A) all buildings and fixtures (including trade fixtures) and fixed p&m at any time thereon;. (B) all easements, rights and agreements in respect thereof;. (C) the benefit of all covenants given in respect thereof; and. (D) any other real property which shawbrook may designate as "specified real property".. All defined terms are as defined in the composite guarantee and debenture.
    La charge flottante couvre tout: Oui
    Contient une promesse négative: Oui
    Contient une charge flottante: Oui
    Contient une charge fixe: Oui
    Personnes ayant droit
    • Shawbrook Bank Limited T/a Shawbrook Business Credit
    Transactions
    • 06 juin 2016Enregistrement d'une charge (MR01)
    • 11 déc. 2017Satisfaction d'une charge (MR04)
    A registered charge
    Créé le 07 nov. 2013
    Livré le 19 nov. 2013
    Totalement satisfaite
    Brève description
    Trade marks: UK00002590774. UK00002494987. UK00002372224. UK00003012916. Notification of addition to or amendment of charge.
    La charge flottante couvre tout: Oui
    Contient une charge flottante: Oui
    Contient une charge fixe: Oui
    Personnes ayant droit
    • Robus German Credit Special Situations Master Fund, L.P.
    Transactions
    • 19 nov. 2013Enregistrement d'une charge (MR01)
    • 29 nov. 2017Satisfaction d'une charge (MR04)
    A registered charge
    Créé le 10 juin 2013
    Livré le 17 juin 2013
    Totalement satisfaite
    Brève description
    Notification of addition to or amendment of charge.
    La charge flottante couvre tout: Oui
    Contient une charge flottante: Oui
    Contient une charge fixe: Oui
    Personnes ayant droit
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transactions
    • 17 juin 2013Enregistrement d'une charge (MR01)
    • 07 juin 2016Satisfaction d'une charge (MR04)
    Debenture
    Créé le 03 août 2012
    Livré le 09 août 2012
    En cours
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    Personnes ayant droit
    • Rbs Invoice Finance Limited
    Transactions
    • 09 août 2012Enregistrement d'une charge (MG01)
    Charge over deposit account
    Créé le 21 mars 2011
    Livré le 26 mars 2011
    En cours
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    The company as a continuing security for the payment on demand of the company's obligations and with full title guarantee charges all rights to the deposit to the bank see image for full details.
    Personnes ayant droit
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transactions
    • 26 mars 2011Enregistrement d'une charge (MG01)
    Supplemental debenture to the debenture and
    Créé le 01 févr. 2011
    Livré le 11 févr. 2011
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from each loan party to the secured parties (or any of them) on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    The supplemental specified equipment, being: 1 canon eos 1DMKIV serial no 931001099, canon eos 7D, serial no 1580815795, 1 canon eos 7D, serial no 1580816048, and all spare parts and replacements for and all modificiations and additions to the supplemental specified equipment, see image for full details.
    Personnes ayant droit
    • Burdale Capital Finance, Inc. (As Administrative Agent and Trustee for the Secured Parties, the Agent)
    Transactions
    • 11 févr. 2011Enregistrement d'une charge (MG01)
    • 24 avr. 2012Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (MG02)
    Loan and security agreement
    Créé le 30 juin 2009
    Livré le 14 juil. 2009
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    Assigned pledged and granted all of its collateral see image for full details.
    Personnes ayant droit
    • Burdale Capital Finance Inc. as Administrative Agent and Trustee for the Secured Parties
    Transactions
    • 14 juil. 2009Enregistrement d'une charge (395)
    • 24 avr. 2012Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (MG02)
    Debenture
    Créé le 30 juin 2009
    Livré le 10 juil. 2009
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from each loan party to the secured parties (or any of them) on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    Fixed and floating charge over all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, fixtures, fixed plant & machinery (for details of properties charged please refer to the form 395). see image for full details.
    Personnes ayant droit
    • Burdale Capital Finance, Inc., as Administrative Agent and Trustee for the Secured Parties
    Transactions
    • 10 juil. 2009Enregistrement d'une charge (395)
    • 24 avr. 2012Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (MG02)
    Composite guarantee and debenture
    Créé le 13 mars 2006
    Livré le 21 mars 2006
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from each obligor to the chargee and the secured parties and to any of them on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transactions
    • 21 mars 2006Enregistrement d'une charge (395)
    • 14 juil. 2009Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Guarantee & debenture
    Créé le 21 avr. 2000
    Livré le 02 mai 2000
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All present and future obligations and liabilities of each obligor (as defined) to the security trustee and the secured beneficiaries (as defined) and to any of them under the financing documents (as defined)
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personnes ayant droit
    • Royal Bank of Scotland PLC (As Agent and Trustee)
    Transactions
    • 02 mai 2000Enregistrement d'une charge (395)
    • 23 mars 2006Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)

    BOWENS INTERNATIONAL LIMITED a-t-elle des procédures d'insolvabilité ?

    Numéro de dossierDatesTypePraticiensAutre
    1
    DateType
    16 août 2017Commencement of winding up
    03 nov. 2020Dissolved on
    Creditors voluntary liquidation
    NomRôleAdresseNommé leCessé le
    Steven M Law
    Suite A, 7th Floor City Gate East
    Tollhouse Hill
    NG1 5FS Nottingham
    practitioner
    Suite A, 7th Floor City Gate East
    Tollhouse Hill
    NG1 5FS Nottingham
    Matthew Robert Haw
    25 Farringdon Street
    EC4A 4AB London
    practitioner
    25 Farringdon Street
    EC4A 4AB London

    Source de données

    • Companies House du Royaume-Uni
      Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers.
    • Licence: CC0