CONFAB LIMITED
Vue d'ensemble
| Nom de la société | CONFAB LIMITED |
|---|---|
| Statut de la société | Dissoute |
| Forme juridique | Société à responsabilité limitée |
| Numéro de société | 00755561 |
| Juridiction | Angleterre/Pays de Galles |
| Date de création | |
| Date de cessation d'activité |
Résumé
| A des PSCs super sécurisés | Non |
|---|---|
| A des charges | Oui |
| A un historique d'insolvabilité | Non |
| Le siège social est contesté | Non |
Où se situe CONFAB LIMITED ?
| Adresse du siège social | Woodcote Grove Ashley Road KT18 5BW Epsom Surrey |
|---|---|
| Adresse du siège social non livrable | Non |
Quels sont les derniers comptes de CONFAB LIMITED ?
| Derniers comptes | |
|---|---|
| Derniers comptes arrêtés au | 31 déc. 2021 |
Quels sont les derniers dépôts pour CONFAB LIMITED ?
| Date | Description | Document | Type | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bulletin officiel final dissous par radiation volontaire | 1 pages | GAZ2(A) | ||||||||||
Premier avis au Bulletin officiel pour la radiation volontaire | 1 pages | GAZ1(A) | ||||||||||
Demande de radiation de la société du registre du commerce | 1 pages | DS01 | ||||||||||
État du capital au 21 déc. 2022
| 3 pages | SH19 | ||||||||||
legacy | 14 pages | SH20 | ||||||||||
legacy | 14 pages | CAP-SS | ||||||||||
Résolutions Resolutions | 14 pages | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
Déclaration de confirmation établie le 20 sept. 2022 sans mise à jour | 3 pages | CS01 | ||||||||||
Comptes pour une société dormante établis au 31 déc. 2021 | 6 pages | AA | ||||||||||
Cessation de la nomination de Alan James Cullens en tant que directeur le 07 avr. 2022 | 1 pages | TM01 | ||||||||||
Déclaration de confirmation établie le 20 sept. 2021 sans mise à jour | 3 pages | CS01 | ||||||||||
Comptes pour une société dormante établis au 31 déc. 2020 | 6 pages | AA | ||||||||||
Nomination de Joanne Jarman en tant qu'administrateur le 17 mai 2021 | 2 pages | AP01 | ||||||||||
Cessation de la nomination de Mark Stephen Anderson en tant que directeur le 17 mai 2021 | 1 pages | TM01 | ||||||||||
Les registres ont été transférés à l'adresse du siège social enregistré Woodcote Grove Ashley Road Epsom Surrey KT18 5BW | 1 pages | AD04 | ||||||||||
Comptes pour une société dormante établis au 31 déc. 2019 | 6 pages | AA | ||||||||||
Déclaration de confirmation établie le 20 sept. 2020 avec mises à jour | 4 pages | CS01 | ||||||||||
Déclaration de confirmation établie le 20 sept. 2019 sans mise à jour | 3 pages | CS01 | ||||||||||
Comptes pour une société dormante établis au 31 déc. 2018 | 6 pages | AA | ||||||||||
L'adresse d'inspection du registre a été modifiée de Euston Tower 286 Euston Raod London NW1 3AT United Kingdom à Epsom Gateway 2 Ashley Avenue Epsom Surrey KT18 5AL | 1 pages | AD02 | ||||||||||
Déclaration de confirmation établie le 20 sept. 2018 sans mise à jour | 3 pages | CS01 | ||||||||||
Comptes pour une société dormante établis au 31 déc. 2017 | 6 pages | AA | ||||||||||
Cessation de la nomination de Heath Stewart Drewett en tant que directeur le 15 déc. 2017 | 1 pages | TM01 | ||||||||||
Période comptable actuelle raccourcie du 31 mars 2018 au 31 déc. 2017 | 1 pages | AA01 | ||||||||||
Comptes pour une société dormante établis au 31 mars 2017 | 6 pages | AA | ||||||||||
Qui sont les dirigeants de CONFAB LIMITED ?
| Nom | Nommé le | Date de démission | Rôle | Adresse | Identification de la société | Pays de résidence | Nationalité | Date de naissance | Profession | Numéro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MCALLISTER, Louise Mary | Secrétaire | Ashley Road KT18 5BW Epsom Woodcote Grove Surrey United Kingdom | 238795770001 | |||||||
| NOBELEN, Elliot Michael | Secrétaire | Ashley Road KT18 5BW Epsom Woodcote Grove Surrey United Kingdom | 238796250001 | |||||||
| COLE, Simon Glenister | Administrateur | Woodcote Grove Ashley Road KT18 5BW Epsom Surrey | England | British | 146000480001 | |||||
| JARMAN, Joanne | Administrateur | Woodcote Grove Ashley Road KT18 5BW Epsom Surrey | United Kingdom | British | 283434280001 | |||||
| BAKER, Helen Alice | Secrétaire | Woodcote Grove Ashley Road KT18 5BW Epsom Surrey | British | 108742050002 | ||||||
| DAVID, Katie Charmian | Secrétaire | 31 Sandy Lane TN13 3TP Sevenoaks Kent | British | 73696680003 | ||||||
| DAVIS, Philip Stephen James | Secrétaire | Hartland Woodside Drive RG18 9QD Hermitage Berkshire | British | 71932630003 | ||||||
| GERRARD, Ashley Louise | Secrétaire | Ashley Road KT18 5BW Epsom Woodcote Grove Surrey United Kingdom | 218094720001 | |||||||
| HAMES, Victoria Elizabeth | Secrétaire | Flat 5 70 Elmbourne Road SW17 8JJ London | British | 102613150001 | ||||||
| LINDSAY, Catherine Elizabeth | Secrétaire | Ashley Road KT18 5BW Epsom Woodcote Grove Surrey United Kingdom | 218252840001 | |||||||
| MASSIE, Amanda Jane Emilia | Secrétaire | Bradlow Sandy Lane GU3 1HF Guildford Surrey | British | 36957420004 | ||||||
| TOMALIN, Richard Howarth | Secrétaire | 22 Fort Road GU1 3TE Guildford Surrey | British | 13199870002 | ||||||
| WEBSTER, Richard | Secrétaire | Woodcote Grove Ashley Road KT18 5BW Epsom Surrey | British | 85595860003 | ||||||
| ANDERSON, Mark Stephen | Administrateur | Woodcote Grove Ashley Road KT18 5BW Epsom Surrey | England | British | 122463830003 | |||||
| BILLINGHAM, Stephen Robert, Doctor | Administrateur | Gso Business Park G74 5PG East Kilbride British Energy | British | 983300008 | ||||||
| BROWN, Peter Allan | Administrateur | Warren Road GU1 2HG Guildford 48 Surrey | British | 30520670001 | ||||||
| CULLENS, Alan James | Administrateur | Woodcote Grove Ashley Road KT18 5BW Epsom Surrey | United Kingdom | British | 189297280001 | |||||
| DREWETT, Heath Stewart | Administrateur | Woodcote Grove Ashley Road KT18 5BW Epsom Surrey | United Kingdom | British | 167727030003 | |||||
| GILL, Timothy Stuart | Administrateur | 9 Vicarage Gardens GU26 6NH Grayshott Surrey | United Kingdom | British | 81465320001 | |||||
| GRIFFITHS, Alun Hughes | Administrateur | Woodcote Grove Ashley Road KT18 5BW Epsom Surrey | England | British | 47764900002 | |||||
| HAYLOCK, Colin Peter | Administrateur | Downside The Drive Belmont SM2 7DP Sutton Surrey | England | British | 47687610001 | |||||
| JOHNSON, Steven | Administrateur | Woodcote Grove Ashley Road KT18 5BW Epsom Surrey | United Kingdom | British | 161365240001 | |||||
| LONG, Richard Charles | Administrateur | 15 Downs Road KT18 5JF Epsom Surrey | Uk | British | 30556100002 | |||||
| MACLEOD, Robert James | Administrateur | Guildford Road GU6 8LT Cranleigh Norther Farm Surrey | United Kingdom | British | 90186680002 | |||||
| MASSIE, Amanda Jane Emilia | Administrateur | 4 Arden Court 20 Avenue Elmers KT6 4SE Surbiton Surrey | British | 36957420003 | ||||||
| MCCLEAN, James Constantine Stuart | Administrateur | Waterfield, Petworth Road Chiddingfold GU8 4UF Godalming Surrey | England | British | 121347960001 | |||||
| MULLER, Michael Hugh Sigvald | Administrateur | Windalls Slinfold RH13 7RP Horsham Sussex | British | 14179760001 | ||||||
| PALMER, Christopher Robin | Administrateur | 68 Glebe Gardens KT3 5RY New Malden Surrey | British | 13199890001 | ||||||
| PIPER, Richard John | Administrateur | Merryfield St Georges Road BR1 2LD Bickley Kent | England | British | 36504290001 | |||||
| PURSER, Ian Robert | Administrateur | Woodcote Grove Ashley Road KT18 5BW Epsom Surrey | United Kingdom | British | 61343830005 | |||||
| TOMALIN, Richard Howarth | Administrateur | 22 Fort Road GU1 3TE Guildford Surrey | British | 13199870002 | ||||||
| WEBSTER, Richard | Administrateur | Woodcote Grove Ashley Road KT18 5BW Epsom Surrey | United Kingdom | British | 265907550001 |
Qui sont les personnes ayant un contrôle significatif sur CONFAB LIMITED ?
| Nom | Notifié le | Adresse | Cessé | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ws Atkins Limited | 06 avr. 2016 | Ashley Road KT18 5BW Epsom Woodcote Grove Surrey United Kingdom | Non | ||||||||||
| |||||||||||||
Nature du contrôle
| |||||||||||||
CONFAB LIMITED a-t-elle des charges ?
| Classification | Dates | Statut | Détails | |
|---|---|---|---|---|
| Second fixed and floating debenture | Créé le 27 févr. 2003 Livré le 11 mars 2003 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from the company to any finance party on any account whatsoever | |
Brèves mentions The present real property, the future real property all other real property now belonging to it other than the excluded real property, book debts bank acounts investments with a floating charge over the. Undertaking and all property and assets. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
| Fixed and floating security document | Créé le 18 déc. 2002 Livré le 27 déc. 2002 | Totalement satisfaite | Montant garanti All moneys,indebtedness,debts and liabilities due or to become due from the company to any finance party on any account whatsoever | |
Brèves mentions Excluding (I) 650 aztec west business park,bristol; (ii) block b 4-6 wellbrook court CB3 ona,cambridge; (iii) 3RD floor longcross court 47 newport rd,CF24 oad,cardiff; see form 395 for details. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
Source de données
- Companies House du Royaume-Uni
Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers. - Licence: CC0