FURNIVAL ESTATES LIMITED

  • Vue d'ensemble
  • Résumé
  • Objet social
  • Adresse
  • Comptes
  • Bilan annuel
  • Dépôts
  • Dirigeants
  • Charges
  • Source de données
  • Vue d'ensemble

    Nom de la sociétéFURNIVAL ESTATES LIMITED
    Statut de la sociétéDissoute
    Forme juridiqueSociété à responsabilité limitée
    Numéro de société 00758082
    JuridictionAngleterre/Pays de Galles
    Date de création
    Date de cessation d'activité

    Résumé

    A des PSCs super sécurisésNon
    A des chargesOui
    A un historique d'insolvabilitéNon
    Le siège social est contestéNon

    Quel est l'objet de FURNIVAL ESTATES LIMITED ?

    • Développement de projets de construction (41100) / Construction
    • Achat et vente de biens immobiliers propres (68100) / Activités immobilières
    • Location et exploitation de biens immobiliers des sociétés de logement (68201) / Activités immobilières

    Où se situe FURNIVAL ESTATES LIMITED ?

    Adresse du siège social
    5 Wigmore Street
    London
    W1U 1PB
    Adresse du siège social non livrableNon

    Quels sont les derniers comptes de FURNIVAL ESTATES LIMITED ?

    Derniers comptes
    Derniers comptes arrêtés au31 mars 2012

    Quel est le statut du dernier bilan annuel pour FURNIVAL ESTATES LIMITED ?

    Bilan annuel
    Dernier bilan annuel

    Quels sont les derniers dépôts pour FURNIVAL ESTATES LIMITED ?

    Dépôts
    DateDescriptionDocumentType

    Bulletin officiel final dissous par radiation volontaire

    1 pagesGAZ2(A)

    Premier avis au Bulletin officiel pour la radiation volontaire

    1 pagesGAZ1(A)

    La procédure de radiation volontaire a été suspendue.

    1 pagesSOAS(A)

    Premier avis au Bulletin officiel pour la radiation volontaire

    1 pagesGAZ1(A)

    Demande de radiation de la société du registre du commerce

    2 pagesDS01

    Déclaration annuelle jusqu'au 24 août 2013 avec liste complète des actionnaires

    6 pagesAR01
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    capital02 sept. 2013

    État du capital au 02 sept. 2013

    • Capital: GBP 1,000,000
    SH01

    Comptes annuels établis au 31 mars 2012

    13 pagesAA

    Déclaration annuelle jusqu'au 24 août 2012 avec liste complète des actionnaires

    6 pagesAR01

    Comptes annuels établis au 31 mars 2011

    16 pagesAA

    La procédure de radiation d'office a été abandonnée

    1 pagesDISS40

    Déclaration annuelle jusqu'au 24 août 2011

    6 pagesAR01

    Comptes annuels établis au 31 mars 2010

    15 pagesAA

    Déclaration annuelle jusqu'au 24 août 2010

    6 pagesAR01

    Comptes annuels établis au 31 mars 2009

    14 pagesAA

    Premier avis au Bulletin officiel pour la radiation d'office

    1 pagesGAZ1

    Modification des coordonnées de l'administrateur Christopher George White le 01 mai 2010

    3 pagesCH01

    Modification des coordonnées de l'administrateur Mr Maurice Moses Benady le 01 mai 2010

    3 pagesCH01

    Comptes annuels établis au 31 mars 2008

    15 pagesAA

    legacy

    4 pages363a

    legacy

    1 pages288b

    legacy

    2 pages288a

    legacy

    4 pages288a

    legacy

    4 pages288a

    Résolutions

    Resolutions
    1 pagesRESOLUTIONS
    Résolutions
    CatégorieDateDescriptionType
    capital

    Résolutions

    Section 175 quoted 10/11/2008
    RES13

    Résolutions

    Resolutions
    1 pagesRESOLUTIONS
    Résolutions
    CatégorieDateDescriptionType
    capital

    Résolutions

    Section 175 quoted 10/11/2008
    RES13

    Qui sont les dirigeants de FURNIVAL ESTATES LIMITED ?

    Dirigeants
    NomNommé leDate de démissionRôleAdresseIdentification de la sociétéPays de résidenceNationalitéDate de naissanceProfessionNuméro
    REIT (CORPORATE SERVICES) LIMITED
    5 Wigmore Street
    W1U 1PB London
    Secrétaire
    5 Wigmore Street
    W1U 1PB London
    79571870001
    BENADY, Maurice Moses
    57/63 Line Wall Road
    Gibraltar
    Gibraltar
    Administrateur
    57/63 Line Wall Road
    Gibraltar
    Gibraltar
    GibraltarBritishSolicitor69435160001
    WHITE, Christopher George
    Line Wall Road
    Gibraltar
    57/63
    Gibraltar
    Administrateur
    Line Wall Road
    Gibraltar
    57/63
    Gibraltar
    GibraltarBritishBarrister-In-Law80132540006
    TRAFALGAR OFFICERS LIMITED
    5 Wigmore Street
    W1U 1PB London
    3rd Floor
    Administrateur
    5 Wigmore Street
    W1U 1PB London
    3rd Floor
    135316290001
    CURTIS, Ernest Leonard
    Cedar Lodge
    Greenfield Lane Hawksworth Guiseley
    LS20 8HF Leeds
    West Yorkshire
    Secrétaire
    Cedar Lodge
    Greenfield Lane Hawksworth Guiseley
    LS20 8HF Leeds
    West Yorkshire
    British19382660001
    GIBSON, William Mcaulay
    Ivy Bank
    1 Easby Drive
    LS29 9BE Ilkley
    West Yorkshire
    Secrétaire
    Ivy Bank
    1 Easby Drive
    LS29 9BE Ilkley
    West Yorkshire
    British5387660001
    GILBERT, Nicholas Jay
    Woodville
    14 Carlton Park Avenue
    WF8 3HQ Pontefract
    West Yorkshire
    Secrétaire
    Woodville
    14 Carlton Park Avenue
    WF8 3HQ Pontefract
    West Yorkshire
    British81344240001
    JOBBINS, Stuart
    16 Riverside Avenue
    LS21 2RT Otley
    West Yorkshire
    Secrétaire
    16 Riverside Avenue
    LS21 2RT Otley
    West Yorkshire
    British108146440001
    MILLINGTON, Paul Terence
    2a Gilleyfield Avenue
    Dore
    S17 3NS Sheffield
    Secrétaire
    2a Gilleyfield Avenue
    Dore
    S17 3NS Sheffield
    British58693930003
    BELL, John Drummond
    Gates Garth
    49 Rutland Drive
    HG1 2NX Harrogate
    North Yorkshire
    Administrateur
    Gates Garth
    49 Rutland Drive
    HG1 2NX Harrogate
    North Yorkshire
    United KingdomBritishCompany Director63940900001
    BELL, John Drummond
    Gates Garth
    49 Rutland Drive
    HG1 2NX Harrogate
    North Yorkshire
    Administrateur
    Gates Garth
    49 Rutland Drive
    HG1 2NX Harrogate
    North Yorkshire
    United KingdomBritishCompany Director63940900001
    BEST, George Laidler
    Kiddall Hall Farm
    York Road Barwick In Elmet
    LS14 3AE Leeds
    West Yorkshire
    Administrateur
    Kiddall Hall Farm
    York Road Barwick In Elmet
    LS14 3AE Leeds
    West Yorkshire
    BritishDirector2748600001
    CULL, David Geoffrey Maurice
    8 Centennial Court
    High Street
    WD3 1AW Rickmansworth
    Hertfordshire
    Administrateur
    8 Centennial Court
    High Street
    WD3 1AW Rickmansworth
    Hertfordshire
    BritishDirector84076630001
    CURTIS, Ernest Leonard
    Cedar Lodge
    Greenfield Lane Hawksworth Guiseley
    LS20 8HF Leeds
    West Yorkshire
    Administrateur
    Cedar Lodge
    Greenfield Lane Hawksworth Guiseley
    LS20 8HF Leeds
    West Yorkshire
    BritishDirector19382660001
    EVANS, Andreas Frederick
    Leathley Grange
    LS21 2LA Leathley
    North Yorkshire
    Administrateur
    Leathley Grange
    LS21 2LA Leathley
    North Yorkshire
    United KingdomBritishDirector9485290003
    EVANS, Dominic Redvers
    Pine Lodge
    9 Sandmoor Avenue
    LS17 7DW Leeds
    West Yorkshire
    Administrateur
    Pine Lodge
    9 Sandmoor Avenue
    LS17 7DW Leeds
    West Yorkshire
    BritishDirector7095590001
    EVANS, Frederick Redvers
    16 Sandmoor Drive
    LS17 7DG Leeds
    West Yorkshire
    Administrateur
    16 Sandmoor Drive
    LS17 7DG Leeds
    West Yorkshire
    BritishDirector4409160001
    EVANS, Roderick Michael
    Oakhill House
    Roundhay Park Lane
    LS17 8AR Leeds
    Administrateur
    Oakhill House
    Roundhay Park Lane
    LS17 8AR Leeds
    BritishDirector40175270002
    GIBSON, William Mcaulay
    Ivy Bank
    1 Easby Drive
    LS29 9BE Ilkley
    West Yorkshire
    Administrateur
    Ivy Bank
    1 Easby Drive
    LS29 9BE Ilkley
    West Yorkshire
    BritishDirector5387660001
    HELLIWELL, David Alistair
    8 Farndale Close
    Spofforth Hill
    LS22 4XE Wetherby
    West Yorkshire
    Administrateur
    8 Farndale Close
    Spofforth Hill
    LS22 4XE Wetherby
    West Yorkshire
    EnglandBritishEstates Director15578740001
    HORSBROUGH, Pauline Elizabeth
    30 The Orchard
    Wrenthorpe
    WF2 0LL Wakefield
    West Yorkshire
    Administrateur
    30 The Orchard
    Wrenthorpe
    WF2 0LL Wakefield
    West Yorkshire
    United KingdomBritishDirector4961270001
    MCKENDRICK, Charles
    St Anns Main Street
    LS22 5EB Kirk Deighton
    North Yorkshire
    Administrateur
    St Anns Main Street
    LS22 5EB Kirk Deighton
    North Yorkshire
    United KingdomBritishChartered Surveyor173983190001
    MILLINGTON, Paul Terence
    2a Gilleyfield Avenue
    Dore
    S17 3NS Sheffield
    Administrateur
    2a Gilleyfield Avenue
    Dore
    S17 3NS Sheffield
    United KingdomBritishAccountant58693930003
    TURNER, Philip Arthur
    Red Roofs 2 Mulberry Garth
    Thorp Arch
    LS23 7AF Wetherby
    West Yorkshire
    Administrateur
    Red Roofs 2 Mulberry Garth
    Thorp Arch
    LS23 7AF Wetherby
    West Yorkshire
    BritishDirector66424440001
    REIT(CORPORATE DIRECTORS) LIMITED
    5 Wigmore Street
    W1U 1PB London
    Administrateur
    5 Wigmore Street
    W1U 1PB London
    74030120002

    FURNIVAL ESTATES LIMITED a-t-elle des charges ?

    Charges
    ClassificationDatesStatutDétails
    Security agreement
    Créé le 19 sept. 2007
    Livré le 26 sept. 2007
    En cours
    Montant garanti
    All monies due or to become due from each obligor to any finance party on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Eurohypo Ag,London Branch
    Transactions
    • 26 sept. 2007Enregistrement d'une charge (395)
    Supplemental legal mortgage to composite guarantee and debenture dated 27 may 1999
    Créé le 28 janv. 2002
    Livré le 06 févr. 2002
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    The leasehold land known as land ajoining eyre street, furnival street, matilda way and matilda street, sheffield. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • National Westminster Bank PLC as Security Agent and Trustee for Itself and the Beneficiaries
    Transactions
    • 06 févr. 2002Enregistrement d'une charge (395)
    • 29 sept. 2007Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Deed of accession (supplemental to a composite guarantee and mortgage debenture dated 27 may 1999)
    Créé le 03 août 1999
    Livré le 16 août 1999
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies obligations and liabilities due owing or incurred by the obligors (as defined) or any of them to any of the beneficiaries (as defined) including all monies obligations and liabilities due owing or incurred by the obligors or any of them to any of the beneficiaries under or in connection with the finance documents (as defined) (or any of them) and/or on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • National Westminster Bank PLC
    Transactions
    • 16 août 1999Enregistrement d'une charge (395)
    • 29 sept. 2007Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Charge
    Créé le 23 déc. 1992
    Livré le 06 janv. 1993
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    £87,000,000 and all other monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the trust deed
    Brèves mentions
    Together with all buildings and erections and fixtures and fittings and fixed plant and machinery for the time being thereon (for full details of charge see form 395 and contd sheet).
    Personnes ayant droit
    • The Law Debenture Trust Corporation P.L.C.
    Transactions
    • 06 janv. 1993Enregistrement d'une charge (395)
    • 17 juil. 2007Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Second supplemental charge deed
    Créé le 04 déc. 1992
    Livré le 08 déc. 1992
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    £87,000,000 11% first mortgage debenture stock 2025 and all other monies from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee under the terms of the charge
    Brèves mentions
    Redvers house union street sheffield south yorkshire. Together with fixed and moveable plant machinery fixtures implements and utensils.
    Personnes ayant droit
    • The Law Debenture Trust Corporation PLC
    Transactions
    • 08 déc. 1992Enregistrement d'une charge (395)
    • 22 oct. 1996Déclaration que tout ou partie de la propriété d'une charge flottante a été libérée (403b)
    • 27 juil. 1999Déclaration que tout ou partie de la propriété d'une charge flottante a été libérée (403b)
    • 17 juil. 2007Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Legal mortgage
    Créé le 21 nov. 1990
    Livré le 29 nov. 1990
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from evans of leeds PLC to the chargee on any account whatsoever.
    Brèves mentions
    Redvers marse furnival street sheffield t/n: ywe 60547 and/or the proceeds of sale thereof.. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Personnes ayant droit
    • National Westminster Bank PLC
    Transactions
    • 29 nov. 1990Enregistrement d'une charge
    • 15 janv. 1993Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Further charge
    Créé le 19 sept. 1978
    Livré le 20 sept. 1978
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    £1,240,000 and all other monies due or to become due from evans of leeds limited to the chargee under the terms of a deed dated 17-6-61.
    Brèves mentions
    Land and buildings situate in sheffield being furnival house, furnival gate, as comprised in a lease dated 15-11-65.
    Personnes ayant droit
    • Eagle Star Insurance Company Limited
    Transactions
    • 20 sept. 1978Enregistrement d'une charge
    • 27 juil. 1999Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Legal mortgage
    Créé le 30 juin 1975
    Livré le 02 juil. 1975
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Redvers slouse, furnival street, sheffield. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Personnes ayant droit
    • Coventry Bank LTD
    Transactions
    • 02 juil. 1975Enregistrement d'une charge
    • 08 mai 1992Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Dep of title deed w/i
    Créé le 23 déc. 1971
    Livré le 28 déc. 1971
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    £650,000
    Brèves mentions
    Property at junction of union st and furnival gate, sheffield, known as redvers house.
    Personnes ayant droit
    • The Bank of Nova Scotia
    Transactions
    • 28 déc. 1971Enregistrement d'une charge
    • 08 mai 1992Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    A registered charge
    Créé le 17 juin 1971
    Livré le 28 juin 1971
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    £1,335,000 & all other monies due or to become due from evans of leeds LTD to the chargee any account whatsoever.
    Brèves mentions
    Furnival house, furnival gate, sheffield comprised in a lease dated 15/11/65.
    Personnes ayant droit
    • Eagle Star Insurance Company LTD
    Transactions
    • 28 juin 1971Enregistrement d'une charge
    • 27 juil. 1999Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Legal charge
    Créé le 04 déc. 1970
    Livré le 08 déc. 1970
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    For securing £800,000 due from lonsdale properties LTD to the chargers and for further securing £700,000 outstanding under 2 charges dated respectively 24/06/68 and 30/12/68 and due from the company millshaw property co. LTD and mulgate investments LTD to the chargee.
    Brèves mentions
    Land adjoining eyre st, furnival st, matilda way and matilda st, sheffield known as furnival house.
    Personnes ayant droit
    • Old Broad Street Securiting LTD
    Transactions
    • 08 déc. 1970Enregistrement d'une charge
    • 08 mai 1992Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Legal charge
    Créé le 30 déc. 1968
    Livré le 09 janv. 1969
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    For securing £427,000 & further securing £345,000 secured by a charge dated 24/06/68, all due from the company and the three other companies referred to therein
    Brèves mentions
    Land containing 891 square yards at the junction of furnival st & union lane in the city of sheffield.
    Personnes ayant droit
    • Old Broad Street Securities LTD.
    Transactions
    • 09 janv. 1969Enregistrement d'une charge
    • 08 mai 1992Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Legal charge
    Créé le 30 déc. 1968
    Livré le 09 janv. 1969
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    For securing £427,000 & furthe securing £345,000 secured by a charge dated 24/06/68. all due from the company and three other companies referred to therein.
    Brèves mentions
    Land adjoining eyre st, furnival st, matilda way, & matilda st, sheffield. 4833 square yards approx.
    Personnes ayant droit
    • Old Broad Street Securities LTD.
    Transactions
    • 09 janv. 1969Enregistrement d'une charge
    • 08 mai 1992Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Legal charge
    Créé le 24 juin 1968
    Livré le 28 juin 1968
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    Securing £345,000 and all other monies due or to become due from the co, to the chargee on any{ account whatsoever
    Brèves mentions
    Land adjoining eyre street,furnival street matilda way and matilda street sheffield together with the buildings erected thereon. (See doc 20).
    Personnes ayant droit
    • Old Broad Street Securities LTD.
    Transactions
    • 28 juin 1968Enregistrement d'une charge
    • 08 mai 1992Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)

    Source de données

    • Companies House du Royaume-Uni
      Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers.
    • Licence: CC0