CASANOVA CLUB LIMITED

  • Vue d'ensemble
  • Résumé
  • Objet social
  • Adresse
  • Dénominations sociales précédentes
  • Comptes
  • Dépôts
  • Dirigeants
  • Personnes ayant un contrôle significatif
  • Charges
  • Source de données
  • Vue d'ensemble

    Nom de la sociétéCASANOVA CLUB LIMITED
    Statut de la sociétéDissoute
    Forme juridiqueSociété à responsabilité limitée
    Numéro de société 00759903
    JuridictionAngleterre/Pays de Galles
    Date de création
    Date de cessation d'activité

    Résumé

    A des PSCs super sécurisésNon
    A des chargesOui
    A un historique d'insolvabilitéNon
    Le siège social est contestéNon

    Quel est l'objet de CASANOVA CLUB LIMITED ?

    • Société non marchande non marchande (74990) / Activités spécialisées, scientifiques et techniques

    Où se situe CASANOVA CLUB LIMITED ?

    Adresse du siège social
    55 Baker Street
    W1U 8EW London
    England
    Adresse du siège social non livrableNon

    Quels étaient les noms précédents de CASANOVA CLUB LIMITED ?

    Dénominations sociales précédentes
    Nom de la sociétéDeJusqu'au
    TOP OF THE WORLD LIMITED06 mai 196306 mai 1963

    Quels sont les derniers comptes de CASANOVA CLUB LIMITED ?

    Derniers comptes
    Derniers comptes arrêtés au31 déc. 2016

    Quels sont les derniers dépôts pour CASANOVA CLUB LIMITED ?

    Dépôts
    DateDescriptionDocumentType

    Bulletin officiel final dissous par radiation volontaire

    1 pagesGAZ2(A)

    Premier avis au Bulletin officiel pour la radiation volontaire

    1 pagesGAZ1(A)

    Demande de radiation de la société du registre du commerce

    3 pagesDS01

    legacy

    1 pagesSH20

    État du capital au 21 févr. 2018

    • Capital: GBP 1.00
    3 pagesSH19

    legacy

    1 pagesCAP-SS

    Résolutions

    Resolutions
    1 pagesRESOLUTIONS
    Résolutions
    CatégorieDateDescriptionType
    capital

    Résolution de réduction du capital social émis

    RES06

    Modification des détails de London Clubs Limited en tant que personne disposant d'un contrôle significatif le 01 févr. 2018

    2 pagesPSC05

    Déclaration de confirmation établie le 31 janv. 2018 sans mise à jour

    3 pagesCS01

    Modification des détails de London Clubs Limited en tant que personne disposant d'un contrôle significatif le 01 févr. 2018

    2 pagesPSC05

    Nomination de Mr Krishan Kaushal en tant que secrétaire le 01 nov. 2017

    2 pagesAP03

    Comptes pour une société dormante établis au 31 déc. 2016

    4 pagesAA

    Déclaration de confirmation établie le 31 janv. 2017 avec mises à jour

    5 pagesCS01

    Comptes pour une société dormante établis au 31 déc. 2015

    4 pagesAA

    Cessation de la nomination de Michael Daniel Cohen en tant que secrétaire le 04 avr. 2014

    1 pagesTM02

    Déclaration annuelle jusqu'au 31 janv. 2016 avec liste complète des actionnaires

    4 pagesAR01
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    capital01 févr. 2016

    État du capital au 01 févr. 2016

    • Capital: GBP 37,500
    SH01

    Cessation de la nomination de Gary William Loveman en tant que directeur le 01 juil. 2015

    1 pagesTM01

    Cessation de la nomination de Roy Alfred Charles Ramm en tant que directeur le 01 mai 2015

    1 pagesTM01

    Comptes pour une société dormante établis au 31 déc. 2014

    4 pagesAA

    Changement d'adresse du siège social de 10 Brick Street London W1J 7HQ à 55 Baker Street London W1U 8EW le 24 mars 2015

    1 pagesAD01

    Déclaration annuelle jusqu'au 31 janv. 2015 avec liste complète des actionnaires

    7 pagesAR01
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    capital03 févr. 2015

    État du capital au 03 févr. 2015

    • Capital: GBP 37,500
    SH01

    Modification des coordonnées de l'administrateur Alexis George Oswald le 29 déc. 2014

    2 pagesCH01

    Nomination de Alexis George Oswald en tant qu'administrateur le 27 oct. 2014

    2 pagesAP01

    Cessation de la nomination de Michael John Silberling en tant que directeur le 27 oct. 2014

    1 pagesTM01

    Comptes pour une société dormante établis au 31 déc. 2013

    4 pagesAA

    Qui sont les dirigeants de CASANOVA CLUB LIMITED ?

    Dirigeants
    NomNommé leDate de démissionRôleAdresseIdentification de la sociétéPays de résidenceNationalitéDate de naissanceProfessionNuméro
    KAUSHAL, Krishan
    Baker Street
    W1U 8EW London
    55
    England
    Secrétaire
    Baker Street
    W1U 8EW London
    55
    England
    240946710001
    OSWALD, Alexis George
    Baker Street
    W1U 8EW London
    55
    England
    Administrateur
    Baker Street
    W1U 8EW London
    55
    England
    United KingdomBritish192560850002
    ROTHWELL, Michael
    Vicentia Court Bridges Court Road
    SW11 3GY London
    Apartment 43,
    Administrateur
    Vicentia Court Bridges Court Road
    SW11 3GY London
    Apartment 43,
    United KingdomBritish116799060007
    COHEN, Michael Daniel
    10722 Gray Havens Court
    NV89135 Las Vegas
    Nevada 89135
    Usa
    Secrétaire
    10722 Gray Havens Court
    NV89135 Las Vegas
    Nevada 89135
    Usa
    American121989990001
    GORMAN, Jeremy Philip
    19 Connaught Square
    W2 2HJ London
    Secrétaire
    19 Connaught Square
    W2 2HJ London
    British3290440003
    PANNETT, George John Robert
    Maytime
    9 Woodlands Way
    KT21 1LH Ashtead
    Surrey
    Secrétaire
    Maytime
    9 Woodlands Way
    KT21 1LH Ashtead
    Surrey
    British1961250001
    TALBOT, Richard Ian
    Oakwood House Woodlands Court
    Filton Road Hambrook
    BS16 1QG Bristol
    Secrétaire
    Oakwood House Woodlands Court
    Filton Road Hambrook
    BS16 1QG Bristol
    British15269400002
    ATWOOD, Charles Lafayette
    One
    Hughes Centre Drive
    Las Vegas Nevada
    Nv89109
    Usa
    Administrateur
    One
    Hughes Centre Drive
    Las Vegas Nevada
    Nv89109
    Usa
    Us120659070001
    BRAHAM, Michael Derrick
    Mayfield Middle Way
    Kinston Gorse
    BN16 1RY East Preston
    West Sussex
    Administrateur
    Mayfield Middle Way
    Kinston Gorse
    BN16 1RY East Preston
    West Sussex
    British8456390001
    BRAWLEY, James
    3 Sydcote Rosendale Road
    West Dulwich
    SE21 8LH London
    Administrateur
    3 Sydcote Rosendale Road
    West Dulwich
    SE21 8LH London
    British33732450001
    BRUNS II, John Frederic
    9e Thorney Court Palace Gate
    W8 5NJ London
    Administrateur
    9e Thorney Court Palace Gate
    W8 5NJ London
    Usa124522430002
    FREED, Simon Raymond
    Rose Court Woodland Lane
    Chorleywood
    WD3 5LS Rickmansworth
    Hertfordshire
    Administrateur
    Rose Court Woodland Lane
    Chorleywood
    WD3 5LS Rickmansworth
    Hertfordshire
    British1961260001
    HARDY, George Barry Conyers
    6 The Bourne
    Townsend Lane
    AL5 2PW Harpenden
    Hertfordshire
    Administrateur
    6 The Bourne
    Townsend Lane
    AL5 2PW Harpenden
    Hertfordshire
    EnglandBritish38430002
    ISAACS, Philip Leonard
    16 Imperial Court
    NW8 7PT London
    Administrateur
    16 Imperial Court
    NW8 7PT London
    British12545650001
    KINGSLEY, Max Myer
    13 Hocroft Road
    NW2 2BP London
    Administrateur
    13 Hocroft Road
    NW2 2BP London
    British24036130002
    LOVEMAN, Gary William
    5 Sabrina Farm Road
    MA02482 Wellesley
    Ma 02482
    Us
    Administrateur
    5 Sabrina Farm Road
    MA02482 Wellesley
    Ma 02482
    Us
    UsaAmerican86449970002
    PANNETT, George John Robert
    Maytime
    9 Woodlands Way
    KT21 1LH Ashtead
    Surrey
    Administrateur
    Maytime
    9 Woodlands Way
    KT21 1LH Ashtead
    Surrey
    British1961250001
    RAMM, Roy Alfred Charles
    10 Brick Street
    W1J 7HQ London
    Administrateur
    10 Brick Street
    W1J 7HQ London
    United KingdomBritish112948830001
    SILBERLING, Michael John
    Portman Close
    W1H 6BR London
    19
    United Kingdom
    Administrateur
    Portman Close
    W1H 6BR London
    19
    United Kingdom
    United KingdomUsa130048270002
    TIMMINS, William
    Apartment 8
    2-4 Hyde Park Gate
    SW7 5EW London
    Administrateur
    Apartment 8
    2-4 Hyde Park Gate
    SW7 5EW London
    British64708660004
    DRIVEMADE LIMITED
    10 Brick Street
    W1Y 8HQ London
    Administrateur
    10 Brick Street
    W1Y 8HQ London
    30185160003

    Qui sont les personnes ayant un contrôle significatif sur CASANOVA CLUB LIMITED ?

    Personnes ayant un contrôle significatif
    NomNotifié leAdresseCessé
    Lci Plc
    Baker Street
    W1U 8EW London
    55
    United Kingdom
    06 avr. 2016
    Baker Street
    W1U 8EW London
    55
    United Kingdom
    Non
    Forme juridiquePrivate Company Limited By Shares
    Autorité légaleThe Companies Act Of 2006
    Nature du contrôle
    • La personne détient, directement ou indirectement, plus de 75 % des actions de la société.
    • La personne détient, directement ou indirectement, plus de 75 % des droits de vote dans la société.
    • La personne détient, directement ou indirectement, le droit de nommer ou de révoquer une majorité des membres du conseil d'administration de la société.

    CASANOVA CLUB LIMITED a-t-elle des charges ?

    Charges
    ClassificationDatesStatutDétails
    Mortgage debenture
    Créé le 06 juin 1994
    Livré le 17 juin 1994
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargees under the terms of the facilities agreement and overdraft letter both dated 24TH may 1994 and this charge
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • The Governor and the Company of the Bank of Scotlandas Agent and Trustee for the Beneficiaries (As Defined)
    Transactions
    • 17 juin 1994Enregistrement d'une charge (395)
    • 21 oct. 1997Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Mezzanine mortgage debenture
    Créé le 07 avr. 1993
    Livré le 24 avr. 1993
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All indebtedness monies obligations and liabilities now or hereafter due owing or incurred by the borrower (as defined) and each company (as defined) to the mezzanine lenders (as defined) under or in connection with clause 2 of the deed
    Brèves mentions
    See form 395 for full details. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personnes ayant droit
    • Standard Chartered Bankas Agent and Trustee for the Mezzanine Lenders
    Transactions
    • 24 avr. 1993Enregistrement d'une charge (395)
    • 11 nov. 1994Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Junior/senior mortgage debenture
    Créé le 07 avr. 1993
    Livré le 24 avr. 1993
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All indebtedness monies obligations and liabilities now or hereafter due owing or incurred by the borrower (as defined) and each company (as defined) to the banks under clause 2 of the deed
    Brèves mentions
    See form 395 for full details. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Scotlandas Agent and Trustee for the Banks
    Transactions
    • 24 avr. 1993Enregistrement d'une charge (395)
    • 11 nov. 1994Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Senior mortgage debenture
    Créé le 07 avr. 1993
    Livré le 24 avr. 1993
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All indebtedness,monies,obligations and liabilities now or hereafter due,owing or incurred by each borrower (as defined therein) and each company (as defined therein) to the beneficiaries (as defined therein) under or in connection with clause 2 of the senior mortgage debenture dated 7.4.93.
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personnes ayant droit
    • The Governor and the Company of the Bank of Scotlandas Agent and Trustee for Each of the Beneficiaries
    Transactions
    • 24 avr. 1993Enregistrement d'une charge (395)
    • 11 nov. 1994Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Lcm mortgage debenture
    Créé le 07 avr. 1993
    Livré le 07 avr. 1993
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    For securing all indebtedness monies obligations and liabilities now or hereafter due owing or incurred by each company (as defined therein) to the lender (as defined therein) under or in connection with clause 2 of the lcm mortgage debenture dated 7TH april 1993
    Brèves mentions
    See form 395 for full details. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personnes ayant droit
    • London Clubs Management Limited
    Transactions
    • 07 avr. 1993Enregistrement d'une charge (395)
    • 11 nov. 1994Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Guarantee and debenture
    Créé le 07 sept. 1992
    Livré le 15 sept. 1992
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from thecompany and/or all or any of the other companies named therein to the chargees under the terms of the charge
    Brèves mentions
    See form 395 ref M82. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personnes ayant droit
    • The Governor and the Company of the Bank of Scotlandas Agent and Trustee for the Overdraft Bank Andthe Overdraft Guarantors
    Transactions
    • 15 sept. 1992Enregistrement d'une charge (395)
    • 11 nov. 1994Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Supplemental senior guarantee and debenture
    Créé le 30 mars 1992
    Livré le 07 avr. 1992
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from thecompany and/or all or any of the other companies named therein to the chargees under the terms of the facilities agreement dated 5TH may 1989 (as amended)
    Brèves mentions
    See form 395 ref M175. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Scotlandas Agent and Trustee Thereunder and to the Banks and Overdraft Bank
    Transactions
    • 07 avr. 1992Enregistrement d'une charge (395)
    • 11 nov. 1994Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Trust deed & supplemental charge
    Créé le 18 août 1989
    Livré le 08 août 1989
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee under the terms of the charge.
    Brèves mentions
    (See form 395 ref M272 for full details).. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personnes ayant droit
    • The Governor & Company of the Bank of Scotland
    Transactions
    • 08 août 1989Enregistrement d'une charge
    • 11 nov. 1994Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Mezzarine guarantee & debenture
    Créé le 11 mai 1989
    Livré le 23 mai 1989
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personnes ayant droit
    • Standard Chartered Bank as Agent and Trustee for the Lenders
    Transactions
    • 23 mai 1989Enregistrement d'une charge
    • 11 nov. 1994Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Senior guarantee & debenture
    Créé le 11 mai 1989
    Livré le 23 mai 1989
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Scotlandas Agent and Trade for the Banks and the Overdraft Bank
    Transactions
    • 23 mai 1989Enregistrement d'une charge
    • 11 nov. 1994Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Junior senior guarantee & debenture
    Créé le 11 mai 1989
    Livré le 23 mai 1989
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Scotlandas Agent and Trustee for the Banks
    Transactions
    • 23 mai 1989Enregistrement d'une charge
    • 11 nov. 1994Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)

    Source de données

    • Companies House du Royaume-Uni
      Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers.
    • Licence: CC0