GREAT GARDENS OF ENGLAND INVESTMENTS LIMITED
Vue d'ensemble
| Nom de la société | GREAT GARDENS OF ENGLAND INVESTMENTS LIMITED |
|---|---|
| Statut de la société | Dissoute |
| Forme juridique | Société à responsabilité limitée |
| Numéro de société | 00761460 |
| Juridiction | Angleterre/Pays de Galles |
| Date de création | |
| Date de cessation d'activité |
Résumé
| A des PSCs super sécurisés | Non |
|---|---|
| A des charges | Oui |
| A un historique d'insolvabilité | Non |
| Le siège social est contesté | Non |
Où se situe GREAT GARDENS OF ENGLAND INVESTMENTS LIMITED ?
| Adresse du siège social | Wyevale Garden Centres Syon Park London Road TW8 8JF Brentford Middlesex England |
|---|---|
| Adresse du siège social non livrable | Non |
Quels sont les derniers comptes de GREAT GARDENS OF ENGLAND INVESTMENTS LIMITED ?
| Derniers comptes | |
|---|---|
| Derniers comptes arrêtés au | 31 déc. 2017 |
Quels sont les derniers dépôts pour GREAT GARDENS OF ENGLAND INVESTMENTS LIMITED ?
| Date | Description | Document | Type | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bulletin officiel final dissous par radiation volontaire | 1 pages | GAZ2(A) | ||||||||||
Déclaration de confirmation établie le 28 avr. 2019 sans mise à jour | 3 pages | CS01 | ||||||||||
Premier avis au Bulletin officiel pour la radiation volontaire | 1 pages | GAZ1(A) | ||||||||||
Demande de radiation de la société du registre du commerce | 3 pages | DS01 | ||||||||||
Cessation de la nomination de Roger Mclaughlan en tant que directeur le 01 févr. 2019 | 1 pages | TM01 | ||||||||||
Comptes pour une société dormante établis au 31 déc. 2017 | 8 pages | AA | ||||||||||
Déclaration de confirmation établie le 28 avr. 2018 sans mise à jour | 3 pages | CS01 | ||||||||||
Cessation de la nomination de Mary Elizabeth Bourlet en tant que secrétaire le 01 févr. 2018 | 1 pages | TM02 | ||||||||||
Nomination de Laura Harradine-Greene en tant que secrétaire le 01 févr. 2018 | 2 pages | AP03 | ||||||||||
Comptes de micro-entité établis au 25 déc. 2016 | 4 pages | AA | ||||||||||
Modification des coordonnées du secrétaire Mary Elizabeth Murray le 12 mai 2017 | 1 pages | CH03 | ||||||||||
Déclaration de confirmation établie le 28 avr. 2017 avec mises à jour | 5 pages | CS01 | ||||||||||
Modification des coordonnées de l'administrateur Mr Anthony Gerald Jones le 03 avr. 2017 | 2 pages | CH01 | ||||||||||
Cessation de la nomination de Justin Matthew King en tant que directeur le 31 oct. 2016 | 1 pages | TM01 | ||||||||||
Nomination de Mary Elizabeth Murray en tant que secrétaire le 25 août 2016 | 2 pages | AP03 | ||||||||||
Comptes pour une société dormante établis au 27 déc. 2015 | 9 pages | AA | ||||||||||
Deuxième dépôt pour la cessation de fonctions de Nils Olin Steinmeyer en tant qu'administrateur | 4 pages | RP04TM01 | ||||||||||
Deuxième dépôt pour la cessation de fonctions de Kevin Michael Bradshaw en tant qu'administrateur | 4 pages | RP04TM01 | ||||||||||
Nomination de Mr Justin Matthew King en tant qu'administrateur le 18 août 2016 | 2 pages | AP01 | ||||||||||
Cessation de la nomination de Stephen Thomas Murphy en tant que directeur le 18 août 2016 | 1 pages | TM01 | ||||||||||
Modification des coordonnées de l'administrateur Mr Anthony Gerald Jones le 22 juil. 2016 | 2 pages | CH01 | ||||||||||
Déclaration annuelle jusqu'au 28 avr. 2016 avec liste complète des actionnaires | 4 pages | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Nomination de Mr Stephen Thomas Murphy en tant qu'administrateur le 06 avr. 2016 | 2 pages | AP01 | ||||||||||
Nomination de Mr Roger Mclaughlan en tant qu'administrateur le 10 mars 2016 | 2 pages | AP01 | ||||||||||
Cessation de la nomination de Nils Olin Steinmeyer en tant que directeur le 06 avr. 2016 | 2 pages | TM01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Qui sont les dirigeants de GREAT GARDENS OF ENGLAND INVESTMENTS LIMITED ?
| Nom | Nommé le | Date de démission | Rôle | Adresse | Identification de la société | Pays de résidence | Nationalité | Date de naissance | Profession | Numéro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HARRADINE-GREENE, Laura | Secrétaire | Syon Park London Road TW8 8JF Brentford Wyevale Garden Centres Middlesex England | 242724460001 | |||||||
| JONES, Anthony Gerald | Administrateur | Syon Park London Road TW8 8JF Brentford Wyevale Garden Centres Middlesex England | England | British | 212265950002 | |||||
| ALLAN, John Michael | Secrétaire | 37 Cavendish Drive Claygate KT10 0QE Esher Surrey | British | 17536370001 | ||||||
| BOURLET, Mary Elizabeth | Secrétaire | Syon Park London Road TW8 8JF Brentford Wyevale Garden Centres Middlesex England | 217311710002 | |||||||
| COX, Peter John | Secrétaire | 57 Gleneldon Road Streatham SW16 2BH London | British | 58964650001 | ||||||
| JONES, Anthony David | Secrétaire | 14 Brownhill Crescent LE7 7LA Rothley Leicestershire | British | 73622510001 | ||||||
| MURFIN, Stephen | Secrétaire | The Kymin Westhide HR1 3RG Hereford Herefordshire | British | 8690590001 | ||||||
| RATCLIFFE, Sarah Elizabeth | Secrétaire | 59b Grange Road SM2 6SP Sutton Surrey | British | 76162020001 | ||||||
| SOUTHWELL, Alan David | Secrétaire | 41 Rectory Lane Byfleet KT14 7LR West Byfleet Surrey | British | 17536350001 | ||||||
| ALLAN, John Michael | Administrateur | 37 Cavendish Drive Claygate KT10 0QE Esher Surrey | British | 17536370001 | ||||||
| BRADSHAW, Kevin Michael | Administrateur | Syon Park London Road TW8 8JF Brentford Wyevale Garden Centres Middlesex England | England | British | 124019940001 | |||||
| BRIGDEN, Peter | Administrateur | 16 Woodstock Gardens Appleton WA4 5HN Warrington Cheshire | United Kingdom | British | 195802400001 | |||||
| CHARLTON, John Fraser | Administrateur | 4 Selwood Place SW7 3QQ London | British | 17536360001 | ||||||
| COX, Peter John | Administrateur | 57 Gleneldon Road Streatham SW16 2BH London | British | 58964650001 | ||||||
| FAVELL, Gary Alan | Administrateur | Yates House Foldshaw Lane Braithwaite HG3 4AN Harrogate Yorks | United Kingdom | British | 107699240001 | |||||
| FISHER, Guy Norman | Administrateur | 1 Beverley Road SW13 0LX London | United Kingdom | British | 17536380002 | |||||
| HEWITT, Robert John | Administrateur | The Old Cider Mill 2 Cotts Farm Cotts Lane HR1 3ND Lugwardine Herefordshire | United Kingdom | British | 15486070002 | |||||
| HODKINSON, James Clifford | Administrateur | 29b Western Avenue Branksome Park BH13 7AN Poole Dorset | England | British | 606430001 | |||||
| JENKINSON, Antonia Scarlett | Administrateur | Syon Park TW8 8JF Brentford The Garden Centre Group Middlesex England | United Kingdom | British | 72128340003 | |||||
| KING, Justin Matthew | Administrateur | Syon Park London Road TW8 8JF Brentford Wyevale Garden Centres Middlesex England | England | British | 213043730001 | |||||
| KOZLOWSKI, Richard Leon | Administrateur | 34 Stubbs Wood HP6 6EX Amersham Buckinghamshire | England | British | 124967710001 | |||||
| LIVINGSTON, William Andrew | Administrateur | 3 Barnes Close St Cross SO23 9QX Winchester Hampshire | England | British | 111439220001 | |||||
| MARSHALL, Nicholas Charles Gilmour | Administrateur | Syon Park TW8 8JF Brentford The Garden Centre Group Middlesex England | Wales | British | 1470180001 | |||||
| MCINTYRE, Duncan Keith | Administrateur | 24 Rounton Road Church Crookham GU13 0HB Fleet Hampshire | British | 29885580001 | ||||||
| MCLAUGHLAN, Roger | Administrateur | Syon Park London Road TW8 8JF Brentford Wyevale Garden Centres Middlesex England | England | British | 206428840001 | |||||
| MURFIN, Stephen | Administrateur | The Kymin Westhide HR1 3RG Hereford Herefordshire | British | 8690590001 | ||||||
| MURPHY, Stephen Thomas | Administrateur | Syon Park London Road TW8 8JF Brentford Wyevale Garden Centres Middlesex England | United Kingdom | British | 207509410001 | |||||
| PIERPOINT, David Julian | Administrateur | 33 West Street RH7 6QP Dormsland Rockvale Surrey | England | British | 138653690001 | |||||
| PRICE, Glyn John | Administrateur | Mill End Ash Ingen Mews Bridstow HR9 6QA Ross On Wye Herefordshire | United Kingdom | British | 73470720001 | |||||
| RATCLIFFE, Sarah Elizabeth | Administrateur | 59b Grange Road SM2 6SP Sutton Surrey | England | British | 76162020001 | |||||
| STEINMEYER, Nils Olin | Administrateur | Syon Park London Road TW8 8JF Brentford Wyevale Garden Centres Middlesex England | United Kingdom | German | 126422100002 | |||||
| STEVENSON, Barry John | Administrateur | Cherry Trees Cane End RG4 9HG Reading Berkshire | England | British | 102595670001 |
Qui sont les personnes ayant un contrôle significatif sur GREAT GARDENS OF ENGLAND INVESTMENTS LIMITED ?
| Nom | Notifié le | Adresse | Cessé | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wyevale Garden Centre Holdings Limited | 06 avr. 2016 | Syon Park, London Road TW8 8JF Brentford Wyevale Garden Centres England | Non | ||||||||||
| |||||||||||||
Nature du contrôle
| |||||||||||||
GREAT GARDENS OF ENGLAND INVESTMENTS LIMITED a-t-elle des charges ?
| Classification | Dates | Statut | Détails | |
|---|---|---|---|---|
| Security agreement | Créé le 24 févr. 2009 Livré le 04 mars 2009 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from each obligor to any secured creditor on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Brèves mentions All of its mortgaged property,investments,plant and machinery,credit balances see image for full details. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
| Mortgage debenture | Créé le 23 févr. 1995 Livré le 06 mars 1995 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brèves mentions A specific equitable charge over all freehold and leasehold properties and/or the proceeds of sale thereof fixed and floating charges over undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts and the benefits of any licences. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
| Legal mortgage | Créé le 23 févr. 1995 Livré le 06 mars 1995 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brèves mentions F/Hold property known as land lying to the north east of rousebarn lane chandlers cross hertfordshire and the proceeds of sale thereof; t/no.hd 183142. floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment and an assignment of the goodwill and connection of any business together with the full benefit of all licences. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
| Legal mortgage | Créé le 23 févr. 1995 Livré le 06 mars 1995 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brèves mentions F/Hold property known as marlow garden centre (formerly thames valley garden centre) little marlow buckinghamshire and the proceeds of sale thereof. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment and an assignment of the goodwill and connection of any business together with the full benefit of all licences. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
| Legal mortgage | Créé le 23 févr. 1995 Livré le 06 mars 1995 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brèves mentions F/Hold property known as palmers nurseries fir tree hill chandlers cross sarratt hertfordshire and the proceeds of sale thereof; t/no.hd 92718. floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment and an assignment of the goodwill and connection of any business together with the full benefit of all licences. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
Source de données
- Companies House du Royaume-Uni
Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers. - Licence: CC0