ALPHA BIRMINGHAM

  • Vue d'ensemble
  • Résumé
  • Objet social
  • Adresse
  • Dénominations sociales précédentes
  • Comptes
  • Dépôts
  • Dirigeants
  • Charges
  • Source de données
  • Vue d'ensemble

    Nom de la sociétéALPHA BIRMINGHAM
    Statut de la sociétéDissoute
    Forme juridiqueSociété privée à responsabilité illimitée
    Numéro de société 00765178
    JuridictionAngleterre/Pays de Galles
    Date de création
    Date de cessation d'activité

    Résumé

    A des PSCs super sécurisésNon
    A des chargesOui
    A un historique d'insolvabilitéNon
    Le siège social est contestéNon

    Quel est l'objet de ALPHA BIRMINGHAM ?

    • (9999) /

    Où se situe ALPHA BIRMINGHAM ?

    Adresse du siège social
    Vertu House Fifth Avenue Business Park
    Team Valley
    NE11 0XA Gateshead
    Tyne And Wear
    Adresse du siège social non livrableNon

    Quels étaient les noms précédents de ALPHA BIRMINGHAM ?

    Dénominations sociales précédentes
    Nom de la sociétéDeJusqu'au
    BRISTOL STREET BIRMINGHAM LIMITED01 janv. 199601 janv. 1996
    BRISTOL STREET MOTORS LIMITED24 juin 196324 juin 1963

    Quels sont les derniers comptes de ALPHA BIRMINGHAM ?

    Derniers comptes
    Derniers comptes arrêtés au

    Quels sont les derniers dépôts pour ALPHA BIRMINGHAM ?

    Dépôts
    DateDescriptionDocumentType

    Bulletin officiel final dissous par radiation d'office

    1 pagesGAZ2

    Changement d'adresse du siège social de Vertu House Kingsway North Team Valley Gateshead Tyne and Wear NE11 0JH à Vertu House Fifth Avenue Business Park Team Valley Gateshead Tyne and Wear NE11 0XA le 12 avr. 2016

    2 pagesAD01

    La procédure de radiation d'office a été suspendue

    DISS16(SOAS)

    Premier avis au Bulletin officiel pour la radiation volontaire

    1 pagesGAZ1(A)

    Premier avis au Bulletin officiel pour la radiation d'office

    1 pagesGAZ1

    Premier avis au Bulletin officiel pour la radiation d'office

    1 pagesGAZ1

    Changement d'adresse du siège social de * Rotterdam House 116 Quayside Newcastle upon Tyne Tyne and Wear NE1 3DY* le 06 avr. 2010

    2 pagesAD01

    Nomination de Muckle Secretary Limited en tant que secrétaire

    3 pagesAP04

    Changement d'adresse du siège social de * Watchmoor Point Watchmoor Road Camberley Surrey GU15 3EX* le 14 déc. 2009

    1 pagesAD01

    Cessation de la nomination de Britax International Services Limited en tant que secrétaire

    1 pagesTM02

    legacy

    4 pages288a

    legacy

    1 pages288b

    Résolutions

    Resolutions
    4 pagesRESOLUTIONS
    Résolutions
    CatégorieDateDescriptionType
    miscellaneous

    Résolutions

    Resmisc- variation order
    RESMISC

    legacy

    1 pages287

    legacy

    1 pages288b

    Restauration par ordonnance du tribunal

    3 pagesAC92

    Bulletin officiel final dissous par radiation volontaire

    1 pagesGAZ2(A)

    Premier avis au Bulletin officiel pour la radiation volontaire

    1 pagesGAZ1(A)

    legacy

    1 pages652a

    Résolutions

    Resolutions
    1 pagesRESOLUTIONS
    Résolutions
    CatégorieDateDescriptionType
    capital

    Résolution d'autorisation d'achat d'un certain nombre d'actions

    RES09

    Certificat de réimmatriculation de société à responsabilité limitée à société de personnes à responsabilité illimitée

    1 pagesCERT3

    Réenregistrement des statuts

    3 pagesMAR

    legacy

    2 pages49(8)(b)

    legacy

    1 pages49(8)(a)

    legacy

    2 pages49(1)

    Qui sont les dirigeants de ALPHA BIRMINGHAM ?

    Dirigeants
    NomNommé leDate de démissionRôleAdresseIdentification de la sociétéPays de résidenceNationalitéDate de naissanceProfessionNuméro
    MUCKLE SECRETARY LIMITED
    c/o Muckle Llp
    32 Gallowgate
    NE1 4BF Newcastle Upon Tyne
    Time Central
    Tyne & Wear
    Secrétaire
    c/o Muckle Llp
    32 Gallowgate
    NE1 4BF Newcastle Upon Tyne
    Time Central
    Tyne & Wear
    Type d'identificationEEE
    Numéro d'enregistrement5276019
    101749170003
    ANDERSON, Karen
    Town Farm House
    Ryton Village
    NE40 3QQ Ryton
    Tyne & Wear
    Administrateur
    Town Farm House
    Ryton Village
    NE40 3QQ Ryton
    Tyne & Wear
    United KingdomBritishFinance Director118122030001
    BRITAX INTERNATIONAL SERVICES LIMITED
    Seton House
    Warwick Technology Park Gallows Hill
    CV34 6DE Warwick
    Secrétaire
    Seton House
    Warwick Technology Park Gallows Hill
    CV34 6DE Warwick
    109290004
    ALDEN, Miles
    8 Church Avenue
    Clent
    DY9 9QT Stourbridge
    West Midlands
    Administrateur
    8 Church Avenue
    Clent
    DY9 9QT Stourbridge
    West Midlands
    BritishManaging Director81132530001
    CANNON, Thomas Charles
    90 Knowle Wood Road
    Dorridge
    B93 8JP Solihull
    West Midlands
    Administrateur
    90 Knowle Wood Road
    Dorridge
    B93 8JP Solihull
    West Midlands
    BritishChartered Secretary2756000001
    DAWSON, Anthony David
    Flat 21 Hillbrow
    Richmond Hill
    TW10 6BH Richmond
    Surrey
    Administrateur
    Flat 21 Hillbrow
    Richmond Hill
    TW10 6BH Richmond
    Surrey
    United KingdomBritishChartered Accountant89317200001
    DUFFIELD, Stephen Leslie
    Hook End Barn Bellemere Road
    Hampton-In-Arden
    B92 0AN Solihull
    West Midlands
    Administrateur
    Hook End Barn Bellemere Road
    Hampton-In-Arden
    B92 0AN Solihull
    West Midlands
    BritishCompany Director24487000001
    ELLSMORE, Mark Anthony
    Moor Cottage
    Eversley Centre
    RG27 0NB Hook
    Administrateur
    Moor Cottage
    Eversley Centre
    RG27 0NB Hook
    BritishFinance Director58979090001
    HAMER, Mark Rhodes
    Berrymans
    GL53 9PB Elkstone
    Cheltenham
    Administrateur
    Berrymans
    GL53 9PB Elkstone
    Cheltenham
    BritishManaging Director50472840004
    HILTON, Malcolm
    38 Shelbourne Road
    CV37 9JP Stratford Upon Avon
    Warwickshire
    Administrateur
    38 Shelbourne Road
    CV37 9JP Stratford Upon Avon
    Warwickshire
    BritishChartered Accountant48475900001
    MARTON, Richard Egerton Christopher
    Capernwray
    6 Kier Park
    SL5 7DS Ascot
    Berkshire
    Administrateur
    Capernwray
    6 Kier Park
    SL5 7DS Ascot
    Berkshire
    BritishDirector34653220001
    SPENCE, Joseph
    Ambleside Dunsley Bank
    Kinver
    DY7 6NA Stourbridge
    West Midlands
    Administrateur
    Ambleside Dunsley Bank
    Kinver
    DY7 6NA Stourbridge
    West Midlands
    BritishFinancial Director34896120002
    THORNE, Raymond
    60 Silhill Hall Road
    B91 1JS Solihull
    West Midlands
    Administrateur
    60 Silhill Hall Road
    B91 1JS Solihull
    West Midlands
    BritishChartered Accountant2756010001
    TURNBULL, Peter
    Much Binding
    Marsh
    HP17 8SS Aylesbury
    Buckinghamshire
    Administrateur
    Much Binding
    Marsh
    HP17 8SS Aylesbury
    Buckinghamshire
    BritishChartered Accountant41591930001
    TUSTAIN, John Bernard
    Clattercut Lane
    Rushock
    WR9 0NN Droitwich
    The Old Oak Barn
    Worcestershire
    United Kingdom
    Administrateur
    Clattercut Lane
    Rushock
    WR9 0NN Droitwich
    The Old Oak Barn
    Worcestershire
    United Kingdom
    United KingdomBritishDirector128982570002
    WHEELWRIGHT, Derek Arthur
    3 Carnwath Road
    B73 6JP Sutton Coldfield
    West Midlands
    Administrateur
    3 Carnwath Road
    B73 6JP Sutton Coldfield
    West Midlands
    BritishDirector15325110001
    WILLIAMS, Paul Raymond
    Summerfields House
    Stoke Pound Lane Stoke Prior
    B60 4LE Bromsgrove
    Worcestershire
    Administrateur
    Summerfields House
    Stoke Pound Lane Stoke Prior
    B60 4LE Bromsgrove
    Worcestershire
    BritishManaging Director15080230001

    ALPHA BIRMINGHAM a-t-elle des charges ?

    Charges
    ClassificationDatesStatutDétails
    Charge
    Créé le 21 déc. 1989
    Livré le 06 janv. 1990
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of an agreement dated 25-10-89
    Brèves mentions
    Such amount standing to the credit of an account no 7021 8790 and designated the company re-cornhill hogg robinson gardner mountain PLC.
    Personnes ayant droit
    • Cornhill Insurance Public Limited Company
    Transactions
    • 06 janv. 1990Enregistrement d'une charge
    • 29 janv. 1997Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Deed of charge
    Créé le 21 déc. 1984
    Livré le 10 janv. 1985
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    First fixed charge all book debts and other debts now and from time to time due or owing to the company.
    Personnes ayant droit
    • Barclays Bank PLC
    Transactions
    • 10 janv. 1985Enregistrement d'une charge
    Floating charge
    Créé le 30 juil. 1984
    Livré le 17 août 1984
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    1) all used motor vehicles 2) all sub-hiring contracts relating thereto. 3) proceeds of sale and insurance monies relating to vehicles the subject of this charge.
    Personnes ayant droit
    • Ford Motor Credit Company Limited
    Transactions
    • 17 août 1984Enregistrement d'une charge
    • 20 déc. 1988Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Floating charge
    Créé le 21 mars 1984
    Livré le 04 avr. 1984
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    All motor vehicles detailed in the appendix to the charge all sub hiring contracts relating thereto proceeds of sale relating to vehicles the subject of this charge.
    Personnes ayant droit
    • Fold Motor Credit Company Limited
    Transactions
    • 04 avr. 1984Enregistrement d'une charge
    Floating charge
    Créé le 20 janv. 1983
    Livré le 07 févr. 1983
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    All motor vehicles all sub-hiring cointracts relating thereto. Proceeds of sale and insurance monies relating to vehicles subject of this charge.
    Personnes ayant droit
    • Ford Motor Credit Company Limited
    Transactions
    • 07 févr. 1983Enregistrement d'une charge
    Floating charge
    Créé le 16 avr. 1982
    Livré le 28 avr. 1982
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    1. all motor vehicles specified first scheduel to charge 2. all sub-hiring contrcts relating thereto 3. proceeds of sale & insurance monies.
    Personnes ayant droit
    • Ford Motor Credit Company Limited
    Transactions
    • 28 avr. 1982Enregistrement d'une charge
    Charge
    Créé le 03 août 1981
    Livré le 24 août 1981
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    1. all motor vehicles specified first schedule to charge 2 all sub-hiring contracts relating thereto 3. proceeds of sale & insurance monies.
    Personnes ayant droit
    • Ford Motor Credit Company Limited
    Transactions
    • 24 août 1981Enregistrement d'une charge
    Legal charge
    Créé le 21 nov. 1980
    Livré le 09 déc. 1980
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    L/Hold lower ground floor monza house bristol street birmingham title no wm 171554.
    Personnes ayant droit
    • Barclays Bank PLC
    Transactions
    • 09 déc. 1980Enregistrement d'une charge
    A registered charge
    Créé le 03 juin 1980
    Livré le 19 juin 1980
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    1. all motor vehicles specified in first schedule attached to the charge. 2. all sub-hiring contracts relating thereto. 3. proceeds of sale & insurance monies relating to vehicles the subject of this charge. (See doc M89).
    Personnes ayant droit
    • Ford Motor Credit Company Limited
    Transactions
    • 19 juin 1980Enregistrement d'une charge
    Floating charge
    Créé le 28 mai 1980
    Livré le 14 juin 1980
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    1. all motor vehicles specified in first schedule attached to the charge. 2. all sub-hiring contracts relating thereof. 3. proceeds of sale & insurance monies relating to vehicles the subject of this charge. (See do M88).
    Personnes ayant droit
    • Ford Motor Credit Company Limited
    Transactions
    • 14 juin 1980Enregistrement d'une charge
    Floating charge
    Créé le 08 févr. 1980
    Livré le 27 févr. 1980
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    1. all motor vehicles specified in frist schedule attached to the charge. 2. all sub-hiring contracts relating thereto. 3. proceeds of sale & insurance monies reltaing to vehicles the subject of this charge. (See doc M85).
    Personnes ayant droit
    • Ford Motor Credit Company Limited
    Transactions
    • 27 févr. 1980Enregistrement d'une charge
    Trust deed
    Créé le 27 déc. 1968
    Livré le 06 janv. 1969
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    Debenture stock of british street group!limited amounting to £2,500,000
    Brèves mentions
    The properties listed below together with all buildings and erections and fixtures fixed plant & machinery belonging to the company thereon and with the benefit of the existing leases, under leases tenamies right.(i)33/48 clarks henry street & 2/20 adelside street, birmingham 12 (ii) alcester rd, portway, warwicks (iii) victoria works, smeth wick. (Iv) 152/154 & 155/162 charles henry street, birmingham-12 (v) former london alumunium works 123/136 charles henry street and 44 & 46 macdonald street, birmingham 12 (vi) long acre, nicholls, birmingham-7.
    Personnes ayant droit
    • The Prudential Assurance Company LTD
    Transactions
    • 06 janv. 1969Enregistrement d'une charge
    • 12 mai 1989Déclaration que tout ou partie de la propriété d'une charge flottante a été libérée (403b)
    • 04 févr. 1997Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)

    Source de données

    • Companies House du Royaume-Uni
      Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers.
    • Licence: CC0