TREADFAST TYRES LIMITED
Vue d'ensemble
Nom de la société | TREADFAST TYRES LIMITED |
---|---|
Statut de la société | Dissoute |
Forme juridique | Société à responsabilité limitée |
Numéro de société | 00774524 |
Juridiction | Angleterre/Pays de Galles |
Date de création | |
Date de cessation d'activité |
Résumé
A des PSCs super sécurisés | Non |
---|---|
A des charges | Oui |
A un historique d'insolvabilité | Non |
Le siège social est contesté | Non |
Où se situe TREADFAST TYRES LIMITED ?
Adresse du siège social | Micheldever Micheldever Station SO21 3AP Winchester Hampshire |
---|---|
Adresse du siège social non livrable | Non |
Quels sont les derniers comptes de TREADFAST TYRES LIMITED ?
Derniers comptes | |
---|---|
Derniers comptes arrêtés au | 31 mars 2017 |
Quels sont les derniers dépôts pour TREADFAST TYRES LIMITED ?
Date | Description | Document | Type | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bulletin officiel final dissous par radiation volontaire | 1 pages | GAZ2(A) | ||||||||||
Déclaration de confirmation établie le 11 mars 2018 sans mise à jour | 3 pages | CS01 | ||||||||||
Premier avis au Bulletin officiel pour la radiation volontaire | 1 pages | GAZ1(A) | ||||||||||
Les registres ont été transférés au lieu d'inspection enregistré Belmont House Station Way Crawley RH10 1JA | 1 pages | AD03 | ||||||||||
L'adresse d'inspection du registre a été modifiée à Belmont House Station Way Crawley RH10 1JA | 1 pages | AD02 | ||||||||||
Demande de radiation de la société du registre du commerce | 3 pages | DS01 | ||||||||||
Période comptable actuelle raccourcie du 31 mars 2018 au 31 déc. 2017 | 1 pages | AA01 | ||||||||||
Comptes pour une société dormante établis au 31 mars 2017 | 5 pages | AA | ||||||||||
Déclaration de confirmation établie le 13 mars 2017 avec mises à jour | 5 pages | CS01 | ||||||||||
Déclaration de confirmation établie le 07 déc. 2016 avec mises à jour | 4 pages | CS01 | ||||||||||
Déclaration de confirmation établie le 03 déc. 2016 avec mises à jour | 7 pages | CS01 | ||||||||||
Comptes pour une petite entreprise établis au 31 mars 2016 | 6 pages | AA | ||||||||||
Période comptable précédente prolongée du 11 déc. 2015 au 31 mars 2016 | 1 pages | AA01 | ||||||||||
Comptes pour une petite entreprise établis au 11 déc. 2014 | 6 pages | AA | ||||||||||
Période comptable actuelle raccourcie du 31 mars 2015 au 11 déc. 2014 | 1 pages | AA01 | ||||||||||
Déclaration annuelle jusqu'au 03 déc. 2015 avec liste complète des actionnaires | 4 pages | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Divers Section 519 | 2 pages | MISC | ||||||||||
Période comptable actuelle raccourcie du 30 sept. 2015 au 31 mars 2015 | 3 pages | AA01 | ||||||||||
Cessation de la nomination de Mark Frederick Harris en tant que secrétaire le 12 déc. 2014 | 2 pages | TM02 | ||||||||||
Cessation de la nomination de Barbara Gail Bowden en tant que directeur le 12 déc. 2014 | 2 pages | TM01 | ||||||||||
Cessation de la nomination de Kerry Clay en tant que directeur le 12 déc. 2014 | 2 pages | TM01 | ||||||||||
Cessation de la nomination de John Martin Handley en tant que directeur le 12 déc. 2014 | 2 pages | TM01 | ||||||||||
Cessation de la nomination de Denise Anne Mccarron en tant que directeur le 12 déc. 2014 | 2 pages | TM01 | ||||||||||
Cessation de la nomination de Michael John Peter Mc Carron en tant que directeur le 12 déc. 2014 | 2 pages | TM01 | ||||||||||
Nomination de Jonathan Robert Cowles en tant que secrétaire le 12 déc. 2014 | 3 pages | AP03 | ||||||||||
Qui sont les dirigeants de TREADFAST TYRES LIMITED ?
Nom | Nommé le | Date de démission | Rôle | Adresse | Identification de la société | Pays de résidence | Nationalité | Date de naissance | Profession | Numéro |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COWLES, Jonathan Robert | Secrétaire | Micheldever Station SO21 3AP Winchester Micheldever Hampshire England | British | 193974400001 | ||||||
COWLES, Jonathan Robert | Administrateur | Micheldever Station SO21 3AP Winchester Micheldever Hampshire England | England | British | Chartered Accountant | 122658610002 | ||||
WILKES, Duncan Stewart | Administrateur | Micheldever Station SO21 3AP Winchester Micheldever Hampshire England | England | British | Company Director | 75861610001 | ||||
FELLOWS, Robert Bruce | Secrétaire | 2 Elmstone Close DY1 3LZ Dudley West Midlands | British | Company Director | 16046570002 | |||||
HARRIS, Mark Frederick | Secrétaire | Micheldever Station SO21 3AP Winchester Micheldever Hampshire England | 160157340001 | |||||||
MCCARRON, Michael John Peter | Secrétaire | The Hyde Kinver DY7 6LS Stourbridge Hyde House West Midlands | British | Company Director | 138422430001 | |||||
BOWDEN, Barbara Gail | Administrateur | Tagg Farm Kidderminster Road DY10 4RA Chaddesley Corbett Worcs | England | British | Director | 161261040001 | ||||
BROWN, Francis William | Administrateur | Cranham House Shenstone DY10 4DL Kidderminster Worcestershire | United Kingdom | British | Director | 20746810001 | ||||
CLAY, Kerry | Administrateur | Micheldever Station SO21 3AP Winchester Micheldever Hampshire England | England | British | Company Director | 174538200001 | ||||
FELLOWS, Robert Bruce | Administrateur | 2 Elmstone Close DY1 3LZ Dudley West Midlands | United Kingdom | British | Company Director | 16046570002 | ||||
HANDLEY, John Martin | Administrateur | Cakebole DY10 4RF Chaddesley Corbett Mintz Cottage Worcestershire | England | British | Company Director | 75640920001 | ||||
HARRIS, Mark Frederick | Administrateur | Tagg Farm Kidderminster Road DY10 4RA Chaddesley Corbet Worcestershire | United Kingdom | British | Company Director | 94136100001 | ||||
HARRIS, Ronald Michael | Administrateur | Tagg Farm Kidderminster Road DY10 4RA Chaddersley Corbett Worcestershire | British | Director | 12896380002 | |||||
MC CARRON, Michael John Peter | Administrateur | Hyde House The Hyde Kinver DY7 6LS Stourbridge West Midlands | United Kingdom | British | Director | 25345570002 | ||||
MC GREGOR, Charles Alexander | Administrateur | Kingmoor Grange Kingstown Road CA3 0AX Carlisle Cumbria | British | Director | 25345580001 | |||||
MCCARRON, Denise Anne | Administrateur | Micheldever Station SO21 3AP Winchester Micheldever Hampshire England | United Kingdom | British | Company Director | 174705270001 |
Qui sont les personnes ayant un contrôle significatif sur TREADFAST TYRES LIMITED ?
Nom | Notifié le | Adresse | Cessé | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Treadfast Cradley Ltd | 10 févr. 2017 | Micheldever Station SO21 3AP Winchester Micheldever Tyre Services Ltd England | Non | ||||||||||
| |||||||||||||
Nature du contrôle
| |||||||||||||
Graphite Capital Gp Llp | 06 avr. 2016 | Berkeley Square W1J 6BQ London Berkeley Square House England | Oui | ||||||||||
| |||||||||||||
Nature du contrôle
| |||||||||||||
Graphite Capital Management Llp | 06 avr. 2016 | Berkeley Square W1J 6BQ London Berkeley Square House England | Oui | ||||||||||
| |||||||||||||
Nature du contrôle
|
TREADFAST TYRES LIMITED a-t-elle des charges ?
Classification | Dates | Statut | Détails | |
---|---|---|---|---|
Fixed and floating charge | Créé le 20 janv. 1994 Livré le 24 janv. 1994 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brèves mentions Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including uncalled capital goodwill bookdebts and patents. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
Mortgage debenture | Créé le 06 sept. 1991 Livré le 17 sept. 1991 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from the company to the chargee pursuant to the draft agreement of even date | |
Brèves mentions By way of specific charge the fixed assets by way of floating security those assets charged by way of specific charge pursuant to the foregoing paragraph (see form 395). | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
Legal charge | Créé le 27 févr. 1991 Livré le 06 mars 1991 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brèves mentions F/H land & premises on the south side of milton road weston super mare title no:- av 134367. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
Legal charge | Créé le 26 oct. 1988 Livré le 01 nov. 1988 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brèves mentions Stanwix garage, 54 scotland road, stanwix, carlisle cumbria. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
Legal charge | Créé le 26 oct. 1988 Livré le 01 nov. 1988 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brèves mentions Land & premises on the south side of march end road, wednesfield wolverhampton title no. Sf 46225. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
Legal charge | Créé le 26 oct. 1988 Livré le 01 nov. 1988 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brèves mentions F/H tudor garage, 262 & 264 milton road, weston super mare. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
Legal charge | Créé le 26 oct. 1988 Livré le 01 nov. 1988 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brèves mentions 52 scotland road, stanwix carlisle, cumbria. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
Legal charge | Créé le 26 oct. 1988 Livré le 01 nov. 1988 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brèves mentions F/H land situate at kingmoor road, st. Ann's, carlisle cumbria. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
Standard security presented for registration in scotland 4/9/85. | Créé le 24 août 1985 Livré le 12 sept. 1985 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from the company to the chargee | |
Brèves mentions 8/10 scotts street, annan dumfriesshire bounded on the north by scotts street along which it extends 55 yards or thereby. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
Legal charge | Créé le 01 août 1985 Livré le 07 août 1985 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brèves mentions Endurance works maynpold fields cradley. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
Charge over all book debts | Créé le 09 déc. 1983 Livré le 14 déc. 1983 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brèves mentions All book debts and other debts now and from time to time hereafter due owing or incurred to the company. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
Legal charge | Créé le 19 avr. 1982 Livré le 27 avr. 1982 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brèves mentions F/H land & premises known as audnam garage camp hill wordsley near stourbridge west midlands title no sf 44235. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
Legal charge | Créé le 19 avr. 1982 Livré le 27 avr. 1982 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brèves mentions F/H land & premises known as albert avenue weston-super-mare somerset. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
|
Source de données
- Companies House du Royaume-Uni
Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers. - Licence: CC0