SECKLOE 183 LIMITED

  • Vue d'ensemble
  • Résumé
  • Objet social
  • Adresse
  • Dénominations sociales précédentes
  • Comptes
  • Dépôts
  • Dirigeants
  • Personnes ayant un contrôle significatif
  • Charges
  • Source de données
  • Vue d'ensemble

    Nom de la sociétéSECKLOE 183 LIMITED
    Statut de la sociétéDissoute
    Forme juridiqueSociété à responsabilité limitée
    Numéro de société 00776237
    JuridictionAngleterre/Pays de Galles
    Date de création
    Date de cessation d'activité

    Résumé

    A des PSCs super sécurisésNon
    A des chargesOui
    A un historique d'insolvabilitéNon
    Le siège social est contestéNon

    Quel est l'objet de SECKLOE 183 LIMITED ?

    • Société inactive (99999) / Activités des organisations et organismes extraterritoriaux

    Où se situe SECKLOE 183 LIMITED ?

    Adresse du siège social
    C/O Barts Spices Limited
    York Road
    BS3 4AD Bedminster
    Bristol
    Adresse du siège social non livrableNon

    Quels étaient les noms précédents de SECKLOE 183 LIMITED ?

    Dénominations sociales précédentes
    Nom de la sociétéDeJusqu'au
    BART SPICES LIMITED07 mars 198807 mars 1988
    BART PRINTS LIMITED04 oct. 196304 oct. 1963

    Quels sont les derniers comptes de SECKLOE 183 LIMITED ?

    Derniers comptes
    Derniers comptes arrêtés au31 mars 2017

    Quels sont les derniers dépôts pour SECKLOE 183 LIMITED ?

    Dépôts
    DateDescriptionDocumentType

    Bulletin officiel final dissous par radiation volontaire

    1 pagesGAZ2(A)

    Premier avis au Bulletin officiel pour la radiation volontaire

    1 pagesGAZ1(A)

    Déclaration de confirmation établie le 30 sept. 2018 avec mises à jour

    4 pagesCS01
    X7FUD263

    Demande de radiation de la société du registre du commerce

    3 pagesDS01
    A7EZK7RF

    État du capital au 29 août 2018

    • Capital: GBP 1.00
    3 pagesSH19
    A7DCTAI1

    legacy

    1 pagesSH20
    S7DCSOT4

    legacy

    1 pagesCAP-SS
    S7DCSOT0

    Résolutions

    Resolutions
    2 pagesRESOLUTIONS
    Résolutions
    CatégorieDateDescriptionType
    capital

    Résolution de réduction du capital social émis

    RES06

    Cessation de la nomination de Damien Mead en tant que directeur le 01 mars 2018

    1 pagesTM01
    X70S0LPA

    Nomination de Mr Jörg Herden en tant qu'administrateur le 19 oct. 2017

    2 pagesAP01
    X6HW4FQZ

    Déclaration de confirmation établie le 30 sept. 2017 sans mise à jour

    3 pagesCS01
    X6GVGJS9

    Comptes pour une société dormante établis au 31 mars 2017

    2 pagesAA
    X6DWG6YG

    Comptes d'exonération totale pour petite entreprise établis au 31 mars 2016

    3 pagesAA
    X5K12VA2

    Nomination de Mr Damien Mead en tant qu'administrateur le 08 nov. 2016

    2 pagesAP01
    X5JYEK76

    Déclaration de confirmation établie le 30 sept. 2016 avec mises à jour

    6 pagesCS01
    X5GWCKGB

    Cessation de la nomination de Keith James Crossley en tant que secrétaire le 29 janv. 2016

    1 pagesTM02
    X50VVW3E

    Cessation de la nomination de Keith James Crossley en tant que directeur le 29 janv. 2016

    1 pagesTM01
    X50VVW7U

    Comptes pour une société dormante établis au 31 mars 2015

    2 pagesAA
    X4YXBXRM

    Déclaration annuelle jusqu'au 30 sept. 2015 avec liste complète des actionnaires

    4 pagesAR01
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    capital28 oct. 2015

    État du capital au 28 oct. 2015

    • Capital: GBP 60,000
    SH01
    X4IZL1T5

    Comptes pour une société dormante établis au 31 mars 2014

    2 pagesAA
    X3LXCJQ9

    Déclaration annuelle jusqu'au 30 sept. 2014 avec liste complète des actionnaires

    4 pagesAR01
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    capital03 oct. 2014

    État du capital au 03 oct. 2014

    • Capital: GBP 60,000
    SH01
    X3HQIBEP

    Satisfaction de la charge 14 en totalité

    1 pagesMR04
    X36WZO5K

    Inscription de la charge 007762370015

    31 pagesMR01
    A35GGL62

    Comptes pour une société dormante établis au 31 mars 2013

    2 pagesAA
    X2NKBBUI

    Déclaration annuelle jusqu'au 30 sept. 2013 avec liste complète des actionnaires

    4 pagesAR01
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    capital15 oct. 2013

    État du capital au 15 oct. 2013

    • Capital: GBP 60,000
    SH01
    X2J0W04A

    Qui sont les dirigeants de SECKLOE 183 LIMITED ?

    Dirigeants
    NomNommé leDate de démissionRôleAdresseIdentification de la sociétéPays de résidenceNationalitéDate de naissanceProfessionNuméro
    COLLARD, David John
    C/O Barts Spices Limited
    York Road
    BS3 4AD Bedminster
    Bristol
    Administrateur
    C/O Barts Spices Limited
    York Road
    BS3 4AD Bedminster
    Bristol
    EnglandBritishCeo109277440001
    HERDEN, Jörg
    Industriestrabe
    49201 Dissen
    25
    Germany
    Administrateur
    Industriestrabe
    49201 Dissen
    25
    Germany
    GermanyGermanDirector239484930001
    BARTLAM, Josephine
    Longwood House Clevedon Road
    Failand
    BS8 3TL Bristol
    Secrétaire
    Longwood House Clevedon Road
    Failand
    BS8 3TL Bristol
    English4433650001
    CROSSLEY, Keith James
    C/O Barts Spices Limited
    York Road
    BS3 4AD Bedminster
    Bristol
    Secrétaire
    C/O Barts Spices Limited
    York Road
    BS3 4AD Bedminster
    Bristol
    169652300001
    MARTIN, Alan Renwick
    2b The Crosspath
    WD7 8HN Radlett
    Hertfordshire
    Secrétaire
    2b The Crosspath
    WD7 8HN Radlett
    Hertfordshire
    British1776940001
    TAPE, Julie
    C/O Barts Spices Limited
    York Road
    BS3 4AD Bedminster
    Bristol
    Secrétaire
    C/O Barts Spices Limited
    York Road
    BS3 4AD Bedminster
    Bristol
    BritishFinance Director95053190001
    THOMAS, Keith Leslie
    62 Old Dover Road
    Capel Le Ferne
    CT18 7HW Folkestone
    Kent
    Secrétaire
    62 Old Dover Road
    Capel Le Ferne
    CT18 7HW Folkestone
    Kent
    British16622820001
    WAINE, Deborah Lynne
    560 Wells Road
    Whitchurch
    BS14 9BB Bristol
    Secrétaire
    560 Wells Road
    Whitchurch
    BS14 9BB Bristol
    BritishSecretary95095690001
    BARD, Stanley
    7 Crooked Usage
    N3 3HD London
    Administrateur
    7 Crooked Usage
    N3 3HD London
    BritishCompany Director8229370001
    BARTLAM, Andrew James
    25 St Oswalds Court
    St Oswalds Road
    BS6 7HX Bristol
    Avon
    Administrateur
    25 St Oswalds Court
    St Oswalds Road
    BS6 7HX Bristol
    Avon
    BritishCompany Director39431620001
    BARTLAM, Josephine
    Longwood House Clevedon Road
    Failand
    BS8 3TL Bristol
    Administrateur
    Longwood House Clevedon Road
    Failand
    BS8 3TL Bristol
    EnglishCompany Director4433650001
    BARTLAM, Reginald Joseph
    Longwood House Clevedon Road
    Failand
    BS8 3TL Bristol
    Administrateur
    Longwood House Clevedon Road
    Failand
    BS8 3TL Bristol
    BritishManaging Director4433670001
    BOYD, Stephen Alexander
    Church Lane
    LE15 8EY Edith Weston
    12
    Rutland
    Administrateur
    Church Lane
    LE15 8EY Edith Weston
    12
    Rutland
    EnglandBritishDirector142394800001
    BRENNAN, John Edward
    Sagamore House Hedgerley Lane
    SL9 7NP Gerrards Cross
    Buckinghamshire
    Administrateur
    Sagamore House Hedgerley Lane
    SL9 7NP Gerrards Cross
    Buckinghamshire
    United KingdomBritishMarketing Director48192180002
    CAMPION, David Bardsley
    Monarchy Hall Farm
    Utkinton
    CW6 0JZ Tarporley
    Cheshire
    Administrateur
    Monarchy Hall Farm
    Utkinton
    CW6 0JZ Tarporley
    Cheshire
    United KingdomBritishCompany Director9623060001
    CROSSLEY, Keith James
    C/O Barts Spices Limited
    York Road
    BS3 4AD Bedminster
    Bristol
    Administrateur
    C/O Barts Spices Limited
    York Road
    BS3 4AD Bedminster
    Bristol
    United KingdomBritishCfo169651660001
    FORD, Peter Michael
    White Strake Hawksdown Road
    Walmer
    CT14 7PW Deal
    Kent
    Administrateur
    White Strake Hawksdown Road
    Walmer
    CT14 7PW Deal
    Kent
    EnglandBritishChartered Accountant16613000001
    GARLAND, Roderick John
    Huntleigh Hadham Cross
    SG10 6AL Much Hadham
    Hertfordshire
    Administrateur
    Huntleigh Hadham Cross
    SG10 6AL Much Hadham
    Hertfordshire
    United KingdomEnglishDirector3661150002
    GARLAND, Roderick John
    Huntleigh Hadham Cross
    SG10 6AL Much Hadham
    Hertfordshire
    Administrateur
    Huntleigh Hadham Cross
    SG10 6AL Much Hadham
    Hertfordshire
    United KingdomEnglishFinance Director3661150002
    JOYNER, Gene Austin
    Brook House
    Mill Lane Compton Martin
    BS40 6NA Bristol
    Bath And North Somerset
    Administrateur
    Brook House
    Mill Lane Compton Martin
    BS40 6NA Bristol
    Bath And North Somerset
    United KingdomBritishDirector95053150002
    MEAD, Damien
    C/O Barts Spices Limited
    York Road
    BS3 4AD Bedminster
    Bristol
    Administrateur
    C/O Barts Spices Limited
    York Road
    BS3 4AD Bedminster
    Bristol
    EnglandBritishFinance Director189835980001
    SHARPE, Clive Richard
    Knighton Rise
    LE2 2RE Leicester
    18
    Leics
    Administrateur
    Knighton Rise
    LE2 2RE Leicester
    18
    Leics
    EnglandBritishDirector134995270001
    SHAW, Edward Clive Vernon
    The Old Barn
    4 Seavale Mews
    BS21 7QB Clevedon
    North Somerset
    Administrateur
    The Old Barn
    4 Seavale Mews
    BS21 7QB Clevedon
    North Somerset
    British41937220002
    SHAW, Matthew
    C/O Barts Spices Limited
    York Road
    BS3 4AD Bedminster
    Bristol
    Administrateur
    C/O Barts Spices Limited
    York Road
    BS3 4AD Bedminster
    Bristol
    United KingdomBritishDirector163272250001
    STOTT, Keith John
    Whitecroft Church Lane
    SG8 0SE Abington Pigotts
    Cambridgeshire
    Administrateur
    Whitecroft Church Lane
    SG8 0SE Abington Pigotts
    Cambridgeshire
    EnglandBritishChief Executive180692390001
    TAPE, Julie
    C/O Barts Spices Limited
    York Road
    BS3 4AD Bedminster
    Bristol
    Administrateur
    C/O Barts Spices Limited
    York Road
    BS3 4AD Bedminster
    Bristol
    United KingdomBritishDirector95053190001
    TAPE, Julie
    The Garden House
    Butcombe Court
    BS40 5TR Redhill
    North Somerset
    Administrateur
    The Garden House
    Butcombe Court
    BS40 5TR Redhill
    North Somerset
    United KingdomBritishFinance Director95053190001

    Qui sont les personnes ayant un contrôle significatif sur SECKLOE 183 LIMITED ?

    Personnes ayant un contrôle significatif
    NomNotifié leAdresseCessé
    York Road
    Bedminster
    BS3 4AD Bristol
    Bart Ingredients
    England
    06 avr. 2016
    York Road
    Bedminster
    BS3 4AD Bristol
    Bart Ingredients
    England
    Non
    Forme juridiqueLimited Company
    Pays d'enregistrementUnited Kingdom
    Autorité légaleCompanies Act 2006
    Lieu d'enregistrementCompanies House
    Numéro d'enregistrement04937130
    Nature du contrôle
    • La personne détient, directement ou indirectement, plus de 75 % des actions de la société.

    SECKLOE 183 LIMITED a-t-elle des charges ?

    Charges
    ClassificationDatesStatutDétails
    A registered charge
    Créé le 01 avr. 2014
    Livré le 09 avr. 2014
    En cours
    La charge flottante couvre tout: Oui
    Contient une promesse négative: Oui
    Contient une charge flottante: Oui
    Contient une charge fixe: Oui
    Personnes ayant droit
    • Santander UK PLC
    Transactions
    • 09 avr. 2014Enregistrement d'une charge (MR01)
    Debenture
    Créé le 04 mai 2010
    Livré le 14 mai 2010
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    Personnes ayant droit
    • Hsbc Bank PLC
    Transactions
    • 14 mai 2010Enregistrement d'une charge (MG01)
    • 30 avr. 2014Satisfaction d'une charge (MR04)
    Debenture
    Créé le 10 août 2009
    Livré le 21 août 2009
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    Personnes ayant droit
    • Rbs Invoice Finance Limited
    Transactions
    • 21 août 2009Enregistrement d'une charge (395)
    • 08 mai 2010Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (MG02)
    Debenture
    Créé le 22 déc. 2003
    Livré le 24 déc. 2003
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transactions
    • 24 déc. 2003Enregistrement d'une charge (395)
    • 29 sept. 2009Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Legal charge
    Créé le 22 déc. 2003
    Livré le 24 déc. 2003
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    Warehouse premises fronting mead street,york road and st lukes rd,bedminster,bristol; AV215197. Fixed charge all buildings and other structures fixed to the property fixed charge any goodwill relating to the property fixed charge all plant machinery and other items affixed to the property assignment of the rental sums together with the benefit of all rights and remedies fixed charge the proceeds of any claim made under insurance policy relating to the property floating charge all unattached plant machinery chattels and goods on or in or used in connection with the property or the business or undertaking at the property.
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transactions
    • 24 déc. 2003Enregistrement d'une charge (395)
    • 29 sept. 2009Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Legal charge
    Créé le 22 déc. 2003
    Livré le 24 déc. 2003
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    Warehouse premises fronting mead street and york road,bedminster,bristol; BL63264. Fixed charge all buildings and other structures fixed to the property fixed charge any goodwill relating to the property fixed charge all plant machinery and other items affixed to the property assignment of the rental sums together with the benefit of all rights and remedies fixed charge the proceeds of any claim made under insurance policy relating to the property floating charge all unattached plant machinery chattels and goods on or in or used in connection with the property or the business or undertaking at the property.
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transactions
    • 24 déc. 2003Enregistrement d'une charge (395)
    • 29 sept. 2009Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    A deed of accession pursuant to a debenture dated 5TH october 2001
    Créé le 15 janv. 2002
    Livré le 05 févr. 2002
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due by each obligor to the chargees under each or any of the senior finance documents and the mezzanine finance documents
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personnes ayant droit
    • Cooperative Centrale Raiffeisen-Boerenleenbank B.Atrading as Rabobank International London Branch, as Agent and Trustee for Itself and Each of the Lenders
    Transactions
    • 05 févr. 2002Enregistrement d'une charge (395)
    • 16 janv. 2004Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Guarantee & debenture
    Créé le 04 mai 2000
    Livré le 12 mai 2000
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All present and future obligations and liabilities due or to become due from the company to any of the secured parties under or pursuant to any of the financing documents (as defined therein)
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • National Westminster Bank PLC as Agent and Trustee for the Secured Parties
    Transactions
    • 12 mai 2000Enregistrement d'une charge (395)
    • 31 janv. 2002Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Mortgage debenture
    Créé le 30 janv. 1998
    Livré le 10 févr. 1998
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    A specific equitable charge over all freehold and leasehold properties and/or the proceeds of sale thereof fixed and floating charges over undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts and the benefits of any licences.
    Personnes ayant droit
    • National Westminster Bank PLC
    Transactions
    • 10 févr. 1998Enregistrement d'une charge (395)
    • 04 sept. 2001Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Mortgage debenture
    Créé le 26 mars 1993
    Livré le 01 avr. 1993
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    A specific equitable charge over all freehold and leasehold properties and/or the proceeds of sale thereof fixed and floating charges over undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts and the benefits of any licences.
    Personnes ayant droit
    • National Westminster Bank PLC
    Transactions
    • 01 avr. 1993Enregistrement d'une charge (395)
    • 12 oct. 1996Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Legal mortgage
    Créé le 26 mars 1993
    Livré le 01 avr. 1993
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    L/H land and buildings on the south east side of york road bedminster bristol avon t/no.AV215197 and the proceeds of sale thereof and an assignment of goodwill and connection of any business and full benefit of all licences. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Personnes ayant droit
    • National Westminster Bank PLC
    Transactions
    • 01 avr. 1993Enregistrement d'une charge (395)
    • 20 mars 1997Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Fixed and floating charge
    Créé le 08 août 1984
    Livré le 13 août 1984
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Fixed & floating charge over undertaking and all property and assets present and future including bookdebts uncalled capital.
    Personnes ayant droit
    • Midland Bank PLC
    Transactions
    • 13 août 1984Enregistrement d'une charge
    • 29 juil. 1993Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Legal mortgage
    Créé le 02 juil. 1980
    Livré le 08 juil. 1980
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    L/H land at premises at mead st, york road & st lukes road bristol together with all fixtures.
    Personnes ayant droit
    • Midland Bank PLC
    Transactions
    • 08 juil. 1980Enregistrement d'une charge
    • 29 juil. 1993Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Charge over agreement to lease
    Créé le 02 févr. 1979
    Livré le 07 févr. 1979
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    All the right title & interest of the company in the property being leasehold land situate at & having frontage on to mead street. York road & st. Lukes road bristol by virtue of an agreement dated 1.1.79 made between the company & the city council of bristol.
    Personnes ayant droit
    • Midland Bank PLC
    Transactions
    • 07 févr. 1979Enregistrement d'une charge
    • 29 juil. 1993Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Floating charge
    Créé le 02 févr. 1979
    Livré le 07 févr. 1979
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Floating charge on. Undertaking and all property and assets present and future including uncalled capital.
    Personnes ayant droit
    • Midland Bank PLC
    Transactions
    • 07 févr. 1979Enregistrement d'une charge
    • 29 juil. 1993Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)

    Source de données

    • Companies House du Royaume-Uni
      Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers.
    • Licence: CC0