TOWRY PENSION TRUSTEES LIMITED

TOWRY PENSION TRUSTEES LIMITED

  • Vue d'ensemble
  • Résumé
  • Objet social
  • Adresse
  • Dénominations sociales précédentes
  • Comptes
  • Dépôts
  • Dirigeants
  • Personnes ayant un contrôle significatif
  • Charges
  • Insolvabilité
  • Source de données
  • Vue d'ensemble

    Nom de la sociétéTOWRY PENSION TRUSTEES LIMITED
    Statut de la sociétéDissoute
    Forme juridiqueSociété à responsabilité limitée
    Numéro de société 00781047
    JuridictionAngleterre/Pays de Galles
    Date de création
    Date de cessation d'activité

    Résumé

    A des PSCs super sécurisésNon
    A des chargesOui
    A un historique d'insolvabilitéOui
    Le siège social est contestéNon

    Quel est l'objet de TOWRY PENSION TRUSTEES LIMITED ?

    • Autres activités professionnelles, scientifiques et techniques n.c.a. (74909) / Activités spécialisées, scientifiques et techniques

    Où se situe TOWRY PENSION TRUSTEES LIMITED ?

    Adresse du siège social
    The Observatory
    Western Road
    RG12 1TL Bracknell
    United Kingdom
    Adresse du siège social non livrableNon

    Quels étaient les noms précédents de TOWRY PENSION TRUSTEES LIMITED ?

    Dénominations sociales précédentes
    Nom de la sociétéDeJusqu'au
    TOWRY LAW PENSION TRUSTEES LIMITED04 juin 200704 juin 2007
    JS&P PENSION TRUSTEES LIMITED14 oct. 200514 oct. 2005
    JS & P PENSION TRUSTEES LIMITED 04 juil. 199404 juil. 1994
    BUILDING SOCIETIES BROKERS LIMITED31 déc. 198031 déc. 1980
    SCOTT, WARBURG & PARTNERS LIMITED15 nov. 196315 nov. 1963

    Quels sont les derniers comptes de TOWRY PENSION TRUSTEES LIMITED ?

    Derniers comptes
    Derniers comptes arrêtés au31 déc. 2018

    Quels sont les derniers dépôts pour TOWRY PENSION TRUSTEES LIMITED ?

    Dépôts
    DateDescriptionDocumentType

    Gazette finale dissoute à la suite d'une liquidation

    1 pagesGAZ2

    legacy

    1 pagesSH20

    État du capital au 12 juin 2020

    • Capital: GBP 1
    5 pagesSH19

    legacy

    1 pagesCAP-SS

    Résolutions

    Resolutions
    3 pagesRESOLUTIONS
    Résolutions
    CatégorieDateDescriptionType
    capital

    Résolution de réduction du capital social émis

    RES06

    legacy

    1 pagesSH20

    legacy

    1 pagesCAP-SS

    Résolutions

    Resolutions
    2 pagesRESOLUTIONS
    Résolutions
    CatégorieDateDescriptionType
    capital

    Résolution de réduction du capital social émis

    RES06

    Retour de la réunion finale dans une liquidation volontaire des membres

    8 pagesLIQ13

    Nomination d'un liquidateur volontaire

    3 pages600

    Résolutions

    Resolutions
    1 pagesRESOLUTIONS
    Résolutions
    CatégorieDateDescriptionType
    liquidation

    Résolution spéciale pour la liquidation au 30 sept. 2019

    LRESSP

    Déclaration de solvabilité

    6 pagesLIQ01

    Cessation de la nomination de Christopher Woodhouse en tant que directeur le 06 sept. 2019

    1 pagesTM01

    Cessation de la nomination de Donald William Sherret Reid en tant que directeur le 06 sept. 2019

    1 pagesTM01

    Cessation de la nomination de Paul Martin Fraser Frame en tant que directeur le 06 sept. 2019

    1 pagesTM01

    Cessation de la nomination de Alan William Edwards en tant que directeur le 06 sept. 2019

    1 pagesTM01

    Satisfaction de la charge 3 en totalité

    1 pagesMR04

    Satisfaction de la charge 4 en totalité

    1 pagesMR04

    Satisfaction de la charge 1 en totalité

    2 pagesMR04

    Satisfaction de la charge 2 en totalité

    1 pagesMR04

    Comptes annuels établis au 31 déc. 2018

    12 pagesAA

    Changement d'adresse du siège social de C/O Rehana Hasan, Company Secretary Towry House Western Road Bracknell Berkshire RG12 1TL England à The Observatory Western Road Bracknell RG12 1TL le 28 janv. 2019

    1 pagesAD01

    Déclaration de confirmation établie le 01 oct. 2018 avec mises à jour

    4 pagesCS01

    Comptes annuels établis au 31 déc. 2017

    11 pagesAA

    Nomination de Mr Andrew Martin Baddeley en tant qu'administrateur le 12 sept. 2018

    2 pagesAP01

    Qui sont les dirigeants de TOWRY PENSION TRUSTEES LIMITED ?

    Dirigeants
    NomNommé leDate de démissionRôleAdresseIdentification de la sociétéPays de résidenceNationalitéDate de naissanceProfessionNuméro
    HASAN, Rehana
    Western Road
    RG12 1TL Bracknell
    The Observatory
    United Kingdom
    Secrétaire
    Western Road
    RG12 1TL Bracknell
    The Observatory
    United Kingdom
    217633660001
    BADDELEY, Andrew Martin
    Chesterfield Gardens
    W1J 5BQ London
    6
    England
    England
    Administrateur
    Chesterfield Gardens
    W1J 5BQ London
    6
    England
    England
    United KingdomBritish82469460001
    BRIDGES, Arthur Robert
    Standon Homestead
    Ockley
    RH5 5QR Dorking
    Surrey
    Secrétaire
    Standon Homestead
    Ockley
    RH5 5QR Dorking
    Surrey
    British3183710001
    EDWARDS, Beverley Joan
    The Hawthorns
    Nags Head Lane
    HP16 0HG Great Missenden
    Buckinghamshire
    Secrétaire
    The Hawthorns
    Nags Head Lane
    HP16 0HG Great Missenden
    Buckinghamshire
    British66469530001
    GARDNER, Brian Arthur
    25 Kinghorn Park
    SL6 7TX Maidenhead
    Berkshire
    Secrétaire
    25 Kinghorn Park
    SL6 7TX Maidenhead
    Berkshire
    British19910910001
    GREGORY, Jacqueline Anne
    c/o C/O Jacqui Gregory, Company Secretary
    Western Road
    RG12 1TL Bracknell
    Towry House
    Berkshire
    England
    Secrétaire
    c/o C/O Jacqui Gregory, Company Secretary
    Western Road
    RG12 1TL Bracknell
    Towry House
    Berkshire
    England
    British57375770004
    HILL, Alan Michael
    121 Claygate Lane
    KT10 0BH Esher
    Surrey
    Secrétaire
    121 Claygate Lane
    KT10 0BH Esher
    Surrey
    British19706650001
    AMOR, John Leonard
    19 Llangar Grove
    RG45 6EA Crowthorne
    Berkshire
    Administrateur
    19 Llangar Grove
    RG45 6EA Crowthorne
    Berkshire
    EnglandBritish19706590001
    ANDERSON-BESANT, Robert
    14 Blenheim Gardens
    RG1 5QG Reading
    Berkshire
    Administrateur
    14 Blenheim Gardens
    RG1 5QG Reading
    Berkshire
    British6117040001
    BARKER, Ronald
    Glebe Farm
    Sharncote
    GL7 6DE Cirencester
    Gloucestershire
    Administrateur
    Glebe Farm
    Sharncote
    GL7 6DE Cirencester
    Gloucestershire
    British17758000001
    BRIDGES, Arthur Robert
    Standon Homestead
    Ockley
    RH5 5QR Dorking
    Surrey
    Administrateur
    Standon Homestead
    Ockley
    RH5 5QR Dorking
    Surrey
    British3183710001
    DEVEY, Robert Alan
    c/o C/O Jacqui Gregory, Company Secretary
    Western Road
    RG12 1TL Bracknell
    Towry House
    Berkshire
    England
    Administrateur
    c/o C/O Jacqui Gregory, Company Secretary
    Western Road
    RG12 1TL Bracknell
    Towry House
    Berkshire
    England
    United KingdomBritish146956760001
    DOWNING, Wadham St. John
    c/o Rehana Hasan, Company Secretary
    Western Road
    RG12 1TL Bracknell
    Towry House
    Berkshire
    England
    Administrateur
    c/o Rehana Hasan, Company Secretary
    Western Road
    RG12 1TL Bracknell
    Towry House
    Berkshire
    England
    EnglandBritish203301710001
    EDWARDS, Alan William
    Western Road
    RG12 1TL Bracknell
    The Observatory
    United Kingdom
    Administrateur
    Western Road
    RG12 1TL Bracknell
    The Observatory
    United Kingdom
    EnglandBritish211677950001
    FISHER, Andrew Charles
    Western Road
    RG12 1TL Bracknell
    Towry House
    Berkshire
    United Kingdom
    Administrateur
    Western Road
    RG12 1TL Bracknell
    Towry House
    Berkshire
    United Kingdom
    EnglandBritish107491560043
    FRAME, Paul Martin Fraser
    Western Road
    RG12 1TL Bracknell
    The Observatory
    United Kingdom
    Administrateur
    Western Road
    RG12 1TL Bracknell
    The Observatory
    United Kingdom
    ScotlandBritish114027290001
    GARDNER, Brian Arthur
    25 Kinghorn Park
    SL6 7TX Maidenhead
    Berkshire
    Administrateur
    25 Kinghorn Park
    SL6 7TX Maidenhead
    Berkshire
    British19910910001
    HALL, Peter Lindop
    c/o Rehana Hasan, Company Secretary
    Western Road
    RG12 1TL Bracknell
    Towry House
    Berkshire
    England
    Administrateur
    c/o Rehana Hasan, Company Secretary
    Western Road
    RG12 1TL Bracknell
    Towry House
    Berkshire
    England
    EnglandBritish212005290001
    PERCY, David
    c/o C/O Jacqui Gregory, Company Secretary
    Western Road
    RG12 1TL Bracknell
    Towry House
    Berkshire
    England
    Administrateur
    c/o C/O Jacqui Gregory, Company Secretary
    Western Road
    RG12 1TL Bracknell
    Towry House
    Berkshire
    England
    United KingdomBritish135616610001
    REID, Donald William Sherret
    Western Road
    RG12 1TL Bracknell
    The Observatory
    United Kingdom
    Administrateur
    Western Road
    RG12 1TL Bracknell
    The Observatory
    United Kingdom
    EnglandBritish212004930001
    RICHARDSON, John Andrew
    Western Road
    RG12 1TL Bracknell
    Towry House
    Berkshire
    United Kingdom
    Administrateur
    Western Road
    RG12 1TL Bracknell
    Towry House
    Berkshire
    United Kingdom
    EnglandBritish67287620002
    RICKARD, Alexandra Lucy Jane
    Western Road
    RG12 1TL Bracknell
    Towry House
    Berkshire
    United Kingdom
    Administrateur
    Western Road
    RG12 1TL Bracknell
    Towry House
    Berkshire
    United Kingdom
    EnglandBritish213258030001
    SCOTT, John Philip Bruce
    36 Hornton Court
    W8 7RU London
    Administrateur
    36 Hornton Court
    W8 7RU London
    British19706740001
    SCOTT, Michael Henry
    11 Gloucester Road
    SW7 4PP London
    Administrateur
    11 Gloucester Road
    SW7 4PP London
    British3730880001
    WALTHAM, Antony
    10 Morecambe Avenue
    Caversham
    RG4 7NL Reading
    Berkshire
    Administrateur
    10 Morecambe Avenue
    Caversham
    RG4 7NL Reading
    Berkshire
    British39936240001
    WARDROP, Alan Watt
    2 Widbury Stonewall Park Road
    Langton Green
    TN3 0HW Tunbridge Wells
    Kent
    Administrateur
    2 Widbury Stonewall Park Road
    Langton Green
    TN3 0HW Tunbridge Wells
    Kent
    EnglandBritish64800850002
    WOODHOUSE, Christopher
    Chesterfield Gardens
    W1J 5BQ London
    6
    England
    England
    Administrateur
    Chesterfield Gardens
    W1J 5BQ London
    6
    England
    England
    EnglandBritish238888480001
    WRIGHT, Paul Vernon
    Western Road
    RG12 1TL Bracknell
    Towry House
    Berkshire
    United Kingdom
    Administrateur
    Western Road
    RG12 1TL Bracknell
    Towry House
    Berkshire
    United Kingdom
    United KingdomBritish137936580001

    Qui sont les personnes ayant un contrôle significatif sur TOWRY PENSION TRUSTEES LIMITED ?

    Personnes ayant un contrôle significatif
    NomNotifié leAdresseCessé
    Western Road
    RG12 1TL Bracknell
    Towry House
    England
    06 avr. 2016
    Western Road
    RG12 1TL Bracknell
    Towry House
    England
    Non
    Forme juridiqueLimited By Shares
    Pays d'enregistrementEngland
    Autorité légaleUnited Kingdom (England And Wales)
    Lieu d'enregistrementCompanies House
    Numéro d'enregistrement5721344
    Nature du contrôle
    • La personne détient, directement ou indirectement, plus de 75 % des actions de la société.
    • La personne détient, directement ou indirectement, plus de 75 % des droits de vote dans la société.
    • La personne détient, directement ou indirectement, le droit de nommer ou de révoquer une majorité des membres du conseil d'administration de la société.

    TOWRY PENSION TRUSTEES LIMITED a-t-elle des charges ?

    Charges
    ClassificationDatesStatutDétails
    Legal charge
    Créé le 14 janv. 2008
    Livré le 24 janv. 2008
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company and/or weybourne property limited, brian ronald streatfield, deborah margaret streatfield, richard mark poole and/or kim hazel poole to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    F/H property k/a weybourne house, 2-4 london street, chertsey, surrey t/no SY574390.
    Personnes ayant droit
    • Barclays Bank PLC
    Transactions
    • 24 janv. 2008Enregistrement d'une charge (395)
    • 25 sept. 2019Satisfaction d'une charge (MR04)
    Legal charge
    Créé le 10 févr. 2003
    Livré le 11 févr. 2003
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    The leasehold property shortly known as ground floor premises 4-8 bartholomew street newbury berkshire t/n BK379685.
    Personnes ayant droit
    • Threshold Land & Estates Limited
    Transactions
    • 11 févr. 2003Enregistrement d'une charge (395)
    • 25 sept. 2019Satisfaction d'une charge (MR04)
    Debenture
    Créé le 07 mai 1999
    Livré le 22 mai 1999
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever but limited to the value of the assets of the college of petroleum and energy studies directors' pension fund from time to time available
    Brèves mentions
    .. fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transactions
    • 22 mai 1999Enregistrement d'une charge (395)
    • 25 sept. 2019Satisfaction d'une charge (MR04)
    Legal charge
    Créé le 26 févr. 1999
    Livré le 09 mars 1999
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due from the company, peter kamel george haddad and ilse de greef to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    91 east street epson surrey together with all buildings and fixtures fittings plant and machinery and goodwill. Floating charge over all undertaking other property assets and rights .. floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Skipton Building Society
    Transactions
    • 09 mars 1999Enregistrement d'une charge (395)
    • 25 sept. 2019Satisfaction d'une charge (MR04)

    TOWRY PENSION TRUSTEES LIMITED a-t-elle des procédures d'insolvabilité ?

    Numéro de dossierDatesTypePraticiensAutre
    1
    DateType
    30 sept. 2019Commencement of winding up
    04 août 2020Dissolved on
    Members voluntary liquidation
    NomRôleAdresseNommé leCessé le
    Laura May Waters
    Pricewaterhousecoopers Llp 7 More London Riverside
    SE1 2RT London
    practitioner
    Pricewaterhousecoopers Llp 7 More London Riverside
    SE1 2RT London
    Steven Sherry
    Pricewaterhousecoopers Llp, 7 More London Riverside
    SE1 2RT London
    practitioner
    Pricewaterhousecoopers Llp, 7 More London Riverside
    SE1 2RT London

    Source de données

    • Companies House du Royaume-Uni
      Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers.
    • Licence: CC0