MIDFAIR PROPERTIES LIMITED

  • Vue d'ensemble
  • Résumé
  • Objet social
  • Adresse
  • Comptes
  • Dépôts
  • Dirigeants
  • Charges
  • Insolvabilité
  • Source de données
  • Vue d'ensemble

    Nom de la sociétéMIDFAIR PROPERTIES LIMITED
    Statut de la sociétéDissoute
    Forme juridiqueSociété à responsabilité limitée
    Numéro de société 00782749
    JuridictionAngleterre/Pays de Galles
    Date de création
    Date de cessation d'activité

    Résumé

    A des PSCs super sécurisésNon
    A des chargesOui
    A un historique d'insolvabilitéOui
    Le siège social est contestéNon

    Quel est l'objet de MIDFAIR PROPERTIES LIMITED ?

    • (7011) /

    Où se situe MIDFAIR PROPERTIES LIMITED ?

    Adresse du siège social
    BEGBIES TRAYNOR (CENTRAL) LLP
    31st Floor 40 Bank Street
    E14 5NR London
    Adresse du siège social non livrableNon

    Quels sont les derniers comptes de MIDFAIR PROPERTIES LIMITED ?

    Derniers comptes
    Derniers comptes arrêtés au31 mars 2009

    Quels sont les derniers dépôts pour MIDFAIR PROPERTIES LIMITED ?

    Dépôts
    DateDescriptionDocumentType

    Gazette finale dissoute à la suite d'une liquidation

    1 pagesGAZ2

    Retour de la réunion finale dans une liquidation volontaire des créanciers

    20 pagesLIQ14

    Résumé des recettes et paiements du récepteur jusqu'au 07 août 2017

    2 pages3.6

    Cessation de la nomination de F & C Reit (Corporate Services) Limited en tant que secrétaire le 08 août 2017

    2 pagesTM02

    Résumé des recettes et paiements du récepteur jusqu'au 07 févr. 2017

    2 pages3.6

    Déclaration des reçus et paiements des liquidateurs jusqu'à 20 janv. 2017

    19 pages4.68

    Résumé des recettes et paiements du récepteur jusqu'au 07 août 2016

    2 pages3.6

    Cessation de la nomination de Christopher George White en tant que directeur le 11 avr. 2016

    2 pagesTM01

    Déclaration des reçus et paiements des liquidateurs jusqu'à 20 janv. 2016

    19 pages4.68

    Résumé des recettes et paiements du récepteur jusqu'au 07 févr. 2016

    2 pages3.6

    Résumé des recettes et paiements du récepteur jusqu'au 07 août 2015

    2 pages3.6

    Déclaration des reçus et paiements des liquidateurs jusqu'à 20 janv. 2015

    18 pages4.68

    Résumé des recettes et paiements du récepteur jusqu'au 07 févr. 2015

    2 pages3.6

    Changement d'adresse du siège social de C/O Begbies Traynor 32 Cornhill London EC3V 3BT England à 31St Floor 40 Bank Street London E14 5NR le 26 sept. 2014

    2 pagesAD01

    Résumé des recettes et paiements du récepteur jusqu'au 07 août 2014

    2 pages3.6

    Nomination d'un administrateur judiciaire ou d'un gérant

    4 pagesRM01

    Avis de cessation d'activité en tant qu'administrateur judiciaire ou gérant

    4 pagesRM02

    Déclaration des reçus et paiements des liquidateurs jusqu'à 20 janv. 2013

    19 pages4.68

    Déclaration des reçus et paiements des liquidateurs jusqu'à 20 janv. 2012

    18 pages4.68

    Déclaration des reçus et paiements des liquidateurs jusqu'à 20 janv. 2014

    18 pages4.68

    Résumé des recettes et paiements du récepteur jusqu'au 07 févr. 2014

    2 pages3.6

    Résumé des recettes et paiements du récepteur jusqu'au 07 août 2013

    3 pages3.6

    Déclaration des reçus et paiements des liquidateurs jusqu'à 20 janv. 2012

    19 pages4.68

    Résumé des recettes et paiements du récepteur jusqu'au 07 févr. 2013

    3 pages3.6

    Résumé des recettes et paiements du récepteur jusqu'au 07 août 2012

    3 pages3.6

    Qui sont les dirigeants de MIDFAIR PROPERTIES LIMITED ?

    Dirigeants
    NomNommé leDate de démissionRôleAdresseIdentification de la sociétéPays de résidenceNationalitéDate de naissanceProfessionNuméro
    BENADY, Maurice Moses
    Line Wall Road
    Gibraltar
    57/63
    Gibraltar
    Administrateur
    Line Wall Road
    Gibraltar
    57/63
    Gibraltar
    GibraltarBritishSolicitor69435160001
    TRAFALGAR OFFICERS LIMITED
    5 Wigmore Street
    W1U 1PB London
    3rd Floor
    Administrateur
    5 Wigmore Street
    W1U 1PB London
    3rd Floor
    Type d'identificationEEE
    Numéro d'enregistrement6745658
    135316290001
    HOLLAND, Philip John
    9 Royle Close
    Chalfont St. Peter
    SL9 0BA Buckinghamshire
    Secrétaire
    9 Royle Close
    Chalfont St. Peter
    SL9 0BA Buckinghamshire
    BritishChief Acc74688330002
    ROBERTS, Geoffrey Michael
    Brenchley 8 Hamilton Road
    DA15 7HB Sidcup
    Kent
    Secrétaire
    Brenchley 8 Hamilton Road
    DA15 7HB Sidcup
    Kent
    British29217560001
    WHITE, Christine
    31 Denmark Street
    WD17 4YA Watford
    Hertfordshire
    Secrétaire
    31 Denmark Street
    WD17 4YA Watford
    Hertfordshire
    British74900200002
    F&C REIT (CORPORATE SERVICES) LIMITED
    5 Wigmore Street
    W1U 1PB London
    Secrétaire
    5 Wigmore Street
    W1U 1PB London
    Type d'identificationEEE
    Numéro d'enregistrement3143222
    79571870006
    BLOOMFIELD, David William
    Hillcroft
    The Drive Harefield Place
    UB10 8AQ Ickenham
    Middlesex
    Administrateur
    Hillcroft
    The Drive Harefield Place
    UB10 8AQ Ickenham
    Middlesex
    BritishCompany Director7927670001
    CLEGG, Barry Stuart
    The Gate House
    18a Ducks Hill Road
    HA6 2NR Northwood
    Middlesex
    Administrateur
    The Gate House
    18a Ducks Hill Road
    HA6 2NR Northwood
    Middlesex
    United KingdomBritishCompany Director11296610002
    CULL, David Geoffrey Maurice
    8 Centennial Court
    High Street
    WD3 1AW Rickmansworth
    Hertfordshire
    Administrateur
    8 Centennial Court
    High Street
    WD3 1AW Rickmansworth
    Hertfordshire
    BritishCompany Director84076630001
    DOSSETT, Roger John
    Charlecote
    Harewood Road
    HP8 4UA Chalfont St Giles
    Buckinghamshire
    Administrateur
    Charlecote
    Harewood Road
    HP8 4UA Chalfont St Giles
    Buckinghamshire
    EnglandBritishCompany Director116927100001
    HOLLAND, Philip John
    61 Badgers Gate
    LU6 2BF Dunstable
    Bedfordshire
    Administrateur
    61 Badgers Gate
    LU6 2BF Dunstable
    Bedfordshire
    EnglandBritishChief Accountant163838050001
    MALONE, Kenneth Daniel
    One Tree Cottage 18 Woodside Avenue
    HP9 1JJ Beaconsfield
    Buckinghamshire
    Administrateur
    One Tree Cottage 18 Woodside Avenue
    HP9 1JJ Beaconsfield
    Buckinghamshire
    BritishChartered Surveyor60687110001
    TAYLOR, Robert Patrick
    Lanreath Ditton Hill
    KT6 5EH Surbiton
    Surrey
    Administrateur
    Lanreath Ditton Hill
    KT6 5EH Surbiton
    Surrey
    EnglandBritishCompany Director7862560003
    WHITE, Christopher George
    Line Wall Road
    Gibraltar
    57/63
    Gibraltar
    Administrateur
    Line Wall Road
    Gibraltar
    57/63
    Gibraltar
    GibraltarBritishBarrister At Law80132540006
    REIT(CORPORATE DIRECTORS) LIMITED
    5 Wigmore Street
    W1U 1PB London
    Administrateur
    5 Wigmore Street
    W1U 1PB London
    74030120002

    MIDFAIR PROPERTIES LIMITED a-t-elle des charges ?

    Charges
    ClassificationDatesStatutDétails
    Eleventh supplemental trust deed
    Créé le 15 août 2006
    Livré le 16 août 2006
    En cours
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    F/H land and buildings k/a 9, 10, 11, 11A, 12, 12A, 13, 13A, 14, 14A, 15, 15A, 16, 16A, 17, 17A, 18, 18A the parade delta way delta gain carpenters park watford hertfordshire t/no HD53553 together with all buildings and erections and fixtures and fittings and fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Capita Irg Trustees Limited
    Transactions
    • 16 août 2006Enregistrement d'une charge (395)
    • 210 févr. 2011Nomination d'un administrateur ou d'un gestionnaire (LQ01)
    • 210 juin 2014Avis de cessation d'exercer en tant qu'administrateur ou gestionnaire (RM02)
    • 210 juin 2014Nomination d'un administrateur ou d'un gestionnaire (RM01)
      • Numéro de dossier 2
    Debenture
    Créé le 15 sept. 2004
    Livré le 29 sept. 2004
    En cours
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the chargor to any finance party on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    By way of fixed charge the real property other than the real property listed in part ii of schedule 2 of the debenture; all plant and machinery etc. and all related property rights; all debts; all of its securities and intellectual property rights; all goodwill and uncalled capital; and the insurance policies and the insurance proceeds. By way of assignment the insurance policies and the insurance proceeds; all rental income; any guarantee of rental income contained in or relating to any lease document; any hedging arrangements; each managing agent agreement; and each building contract and all related property rights. By way of first floating charge (I) the whole of its assets present and future and (ii) the whole of its assets situated in scotland.. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Hypo Real Estate Bank International (The "Security Trustee")
    Transactions
    • 29 sept. 2004Enregistrement d'une charge (395)
    Supplemental debenture
    Créé le 24 août 1998
    Livré le 25 août 1998
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee as security trustee for the secured parties (as defined in the composite guarantee and mortgage debenture), the payment and discharge of which are the subject of covenants, undertakings, guarnatees, and agreements contained in the composite guarantee and mortgage debenture and the supplemental debenture
    Brèves mentions
    F/H 49/51 cambridge road hastings east sussex t/n-ESX45916 and all that f/h land being y dolydd llanfyllin powys and land on the north east side of the road leading from llanfyllin powys and land on the north east side of the road leading from llanfyllin to meifod t/n-WA478878 and WA54386 together with the proceeds of sale of the same together with any property and land already charged to the security trustee by way of legal mortgage by the company.
    Personnes ayant droit
    • National Westminster Bank PLC
    Transactions
    • 25 août 1998Enregistrement d'une charge (395)
    • 10 mai 2004Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Legal charge
    Créé le 12 août 1992
    Livré le 24 août 1992
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due from the company, david william bloomfield and estates & general PLC to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    L/H property k/a flat 1, 19 green street, london t/no. NGL667992.
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transactions
    • 24 août 1992Enregistrement d'une charge (395)
    • 11 janv. 1997Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Legal charge
    Créé le 12 août 1992
    Livré le 17 août 1992
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due from the company and estates & general PLC to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    F/H property k/a 49 & 51 cambridge road, hastings, east sussex t/no. ESX45916.
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transactions
    • 17 août 1992Enregistrement d'une charge (395)
    • 10 mai 2004Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Legal charge
    Créé le 12 août 1992
    Livré le 17 août 1992
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due from the company and estates & general PLC to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    F/H property being land at y dolydd, llanfyllin, powys, montgomeryshire and the l/h land on the north east side of the road leading from y dolydd, llanfyllin to meifod t/nos. WA478878 and WA543863.
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transactions
    • 17 août 1992Enregistrement d'une charge (395)
    • 10 mai 2004Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Composite guarantee and debenture
    Créé le 04 août 1992
    Livré le 19 août 1992
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due from the company to the chargee as security trustee for itself and the secured parties (all as defined therein) and to the secured parties on any account whatsoever under the terms of this deed
    Brèves mentions
    (For full details see form 395 tc ref: M34). A specific equitable charge over all freehold and leasehold properties and/or the proceeds of sale thereof fixed and floating charges over undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts and the benefits of any licences.
    Personnes ayant droit
    • National Westminster Bank PLC
    Transactions
    • 19 août 1992Enregistrement d'une charge (395)
    • 10 mai 2004Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Legal charge
    Créé le 30 juil. 1992
    Livré le 14 août 1992
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due from estates & general PLC to the chargee under the terms of the charge
    Brèves mentions
    Property k/a the rex cinema, high street, berkhamsted.
    Personnes ayant droit
    • Commerzbank Ag
    Transactions
    • 14 août 1992Enregistrement d'une charge (395)
    • 16 déc. 1997Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Equitable mortgage
    Créé le 10 juil. 1992
    Livré le 13 juil. 1992
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from estates & general PLC to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    F/H property k/a y dolydd llanfyllin montgomeryshire t/no. WA478878 & l/h property k/a land on the north east side of the road leading from llanfyllin to meifod t/no. WA543863.
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transactions
    • 13 juil. 1992Enregistrement d'une charge (395)
    • 06 févr. 1997Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Equitable mortgage
    Créé le 29 janv. 1992
    Livré le 04 févr. 1992
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due from estates & general PLC to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    F/H land & buildings k/a 49 & 51 cambridge road hastings E. sussex t/no. Esx 45916.
    Personnes ayant droit
    • Bank of Scotland
    Transactions
    • 04 févr. 1992Enregistrement d'une charge (395)
    • 11 janv. 1997Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Equitable charge
    Créé le 31 déc. 1991
    Livré le 15 janv. 1992
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the estates & general PLC to the chargee under the terms of the charge
    Brèves mentions
    Land and buildings including the rex cinema,berkhamsted,hertfordshire t/no hd 1067.
    Personnes ayant droit
    • Commerzbank a G
    Transactions
    • 15 janv. 1992Enregistrement d'une charge (395)
    • 22 août 1992Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Legal mortgage
    Créé le 19 janv. 1987
    Livré le 23 janv. 1987
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from estates and general investments PLC to the chargee on any account whatsoever.
    Brèves mentions
    49/53 cambridge road hastings east sussex title no. Esx 45916 and the proceeds of sale thereof.. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Personnes ayant droit
    • National Westminster Bank PLC
    Transactions
    • 23 janv. 1987Enregistrement d'une charge
    • 11 janv. 1997Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Legal mortgage
    Créé le 02 janv. 1987
    Livré le 13 janv. 1987
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All moneys due or to become due from estates and general investments PLC to the chargee one any account whatsoever.
    Brèves mentions
    49/53 cambridge road hastings east sussex. Title no:- esx 45916. and the proceeds of sale thereof.. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Personnes ayant droit
    • National Westminster Bank PLC
    Transactions
    • 13 janv. 1987Enregistrement d'une charge
    • 11 janv. 1997Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Deed of release and further charge of even date
    Créé le 19 sept. 1986
    Livré le 30 sept. 1986
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of a legal charge d/D. 11/2/85.
    Brèves mentions
    Land and buildings on the south side of downmill road bracknell berks. Title no:- bk 188867.
    Personnes ayant droit
    • Citibank N.A.
    Transactions
    • 30 sept. 1986Enregistrement d'une charge
    Legal charge
    Créé le 20 déc. 1985
    Livré le 23 déc. 1985
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due to the bank from estates and general investments PLC on any account whatsoever and from the co. Under the terms of the charge.
    Brèves mentions
    L/H property k/a land at salisbury road and wallingford road uxbridge.
    Personnes ayant droit
    • Midland Bank PLC
    Transactions
    • 23 déc. 1985Enregistrement d'une charge
    • 11 janv. 1997Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Legal charge
    Créé le 11 févr. 1985
    Livré le 18 févr. 1985
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the guarantee of even date
    Brèves mentions
    Land and buildings on the south side of dowmill road bracknell berkshire title no BK188867 together with all buildings trade and other fixtures fixed plant and machinery. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Personnes ayant droit
    • Citibank N.A
    Transactions
    • 18 févr. 1985Enregistrement d'une charge
    Legal mortgage
    Créé le 28 juin 1982
    Livré le 09 juil. 1982
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    For securing all monies due or to become due from the company and/or estates & general investments public limited company to the chargee not exceeding £570,000
    Brèves mentions
    F/H 9 north street, leatherhead surrey. T.no. Sy 494073. floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Personnes ayant droit
    • National Westminster Bank PLC
    Transactions
    • 09 juil. 1982Enregistrement d'une charge
    Legal charge
    Créé le 10 déc. 1981
    Livré le 18 déc. 1981
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company and/or estates 0ND general investments PLC to the chargee on any account whatsoever.
    Brèves mentions
    L/H georgian house, bury street, st. James, westminster. S.W.1.
    Personnes ayant droit
    • Barclays Bank LTD
    Transactions
    • 18 déc. 1981Enregistrement d'une charge
    Legal mortgage
    Créé le 04 déc. 1980
    Livré le 09 déc. 1980
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    F/H land at 12/16 west road, tottenham, london N.17 title no. Ngl 357592.. floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Personnes ayant droit
    • National Westminster Bank PLC
    Transactions
    • 09 déc. 1980Enregistrement d'une charge
    Charge
    Créé le 25 avr. 1980
    Livré le 30 avr. 1980
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    An assignment over all the building agreement relating to land situated at factory lane croydon further details see doc M53.. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Personnes ayant droit
    • National Westminster Bank PLC
    Transactions
    • 30 avr. 1980Enregistrement d'une charge
    Legal charge
    Créé le 11 avr. 1980
    Livré le 22 avr. 1980
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    7-12 bury street & 17 ryder street westminster london. Together with all buildings and erections thereon and all fixtures whatsoever now or at any time hereafter affixed or attached to the property or any part thereof other than trade machinery as defined by section 5 of the bills of sale act 1878.
    Personnes ayant droit
    • Standard Chartered Bank LTD
    Transactions
    • 22 avr. 1980Enregistrement d'une charge
    Legal charge
    Créé le 21 janv. 1980
    Livré le 04 févr. 1980
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Land & building having a frontage partly to elloe rd, partly to simmonds rd and partly to ire farm lane in the london borough of waltham forest.
    Personnes ayant droit
    • Allied Irish Investments Bank LTD
    Transactions
    • 04 févr. 1980Enregistrement d'une charge
    • 11 janv. 1997Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Mortgage
    Créé le 18 janv. 1980
    Livré le 23 janv. 1980
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    F/H 54 high street amersham, bucks.
    Personnes ayant droit
    • United Dominions Trust LTD
    Transactions
    • 23 janv. 1980Enregistrement d'une charge

    MIDFAIR PROPERTIES LIMITED a-t-elle des procédures d'insolvabilité ?

    Numéro de dossierDatesTypePraticiensAutre
    1
    DateType
    21 janv. 2011Commencement of winding up
    21 mai 2018Dissolved on
    Creditors voluntary liquidation
    NomRôleAdresseNommé leCessé le
    Kirstie Jane Provan
    32 Cornhill
    EC3V 3BT London
    practitioner
    32 Cornhill
    EC3V 3BT London
    Mark Robert Fry
    Begbies Traynor Central Llp
    32 Cornhill
    EC3V 3BT London
    practitioner
    Begbies Traynor Central Llp
    32 Cornhill
    EC3V 3BT London
    2Receiver/Manager appointed
    NomRôleAdresseNommé leCessé le
    Nicholas Guy Edwards
    Deloitte Llp Po Box 810 66 Shoe Lane
    EC4A 3WA London
    receiver manager
    Deloitte Llp Po Box 810 66 Shoe Lane
    EC4A 3WA London
    Louise Mary Brittain
    Po Box 810 66 Shoe Lane
    EC4A 3WA London
    receiver manager
    Po Box 810 66 Shoe Lane
    EC4A 3WA London
    Lee Antony Manning
    Athene Place 66 Shoe Lane
    EC4A 3BQ London
    receiver manager
    Athene Place 66 Shoe Lane
    EC4A 3BQ London

    Source de données

    • Companies House du Royaume-Uni
      Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers.
    • Licence: CC0