TRANSTAR LIMITED
Vue d'ensemble
| Nom de la société | TRANSTAR LIMITED |
|---|---|
| Statut de la société | Dissoute |
| Forme juridique | Société à responsabilité limitée |
| Numéro de société | 00785717 |
| Juridiction | Angleterre/Pays de Galles |
| Date de création | |
| Date de cessation d'activité |
Résumé
| A des PSCs super sécurisés | Non |
|---|---|
| A des charges | Oui |
| A un historique d'insolvabilité | Non |
| Le siège social est contesté | Non |
Où se situe TRANSTAR LIMITED ?
| Adresse du siège social | Unit 3a C/O Victor Products Ltd, Tyne Dock East Side Port Of Tyne NE33 5SQ South Shields Tyne And Wear England |
|---|---|
| Adresse du siège social non livrable | Non |
Quels sont les derniers comptes de TRANSTAR LIMITED ?
| Derniers comptes | |
|---|---|
| Derniers comptes arrêtés au | 31 déc. 2016 |
Quels sont les derniers dépôts pour TRANSTAR LIMITED ?
| Date | Description | Document | Type | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bulletin officiel final dissous par radiation volontaire | 1 pages | GAZ2(A) | ||||||||||
Premier avis au Bulletin officiel pour la radiation volontaire | 1 pages | GAZ1(A) | ||||||||||
État du capital au 24 juil. 2018
| 3 pages | SH19 | ||||||||||
Demande de radiation de la société du registre du commerce | 3 pages | DS01 | ||||||||||
legacy | 1 pages | SH20 | ||||||||||
legacy | 1 pages | CAP-SS | ||||||||||
Résolutions Resolutions | 1 pages | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
Déclaration de confirmation établie le 16 mars 2018 sans mise à jour | 3 pages | CS01 | ||||||||||
Cessation de la nomination de Barry Wilson en tant que directeur le 15 janv. 2018 | 1 pages | TM01 | ||||||||||
Nomination de Mr Michael Ejupi en tant qu'administrateur le 13 oct. 2017 | 2 pages | AP01 | ||||||||||
Nomination de Ms Svetlana Vinokur en tant qu'administrateur le 13 oct. 2017 | 2 pages | AP01 | ||||||||||
Nomination de Mr Ian Hudson en tant qu'administrateur le 13 oct. 2017 | 2 pages | AP01 | ||||||||||
Cessation de la nomination de Stephen Paul Turner en tant que directeur le 13 oct. 2017 | 1 pages | TM01 | ||||||||||
Cessation de la nomination de Stephen Paul Turner en tant que secrétaire le 13 oct. 2017 | 1 pages | TM02 | ||||||||||
Comptes pour une société dormante établis au 31 déc. 2016 | 6 pages | AA | ||||||||||
Notification de Victor Products Holdings Ltd en tant que personne disposant d'un contrôle significatif le 06 avr. 2016 | 2 pages | PSC02 | ||||||||||
Changement d'adresse du siège social de New York Way New York Industrial Park Newcastle upon Tyne Tyne & Wear NE27 0QF à Unit 3a C/O Victor Products Ltd, Tyne Dock East Side Port of Tyne South Shields Tyne and Wear NE33 5SQ le 17 juil. 2017 | 1 pages | AD01 | ||||||||||
Déclaration de confirmation établie le 16 mars 2017 avec mises à jour | 5 pages | CS01 | ||||||||||
Comptes pour une société dormante établis au 31 déc. 2015 | 6 pages | AA | ||||||||||
Nomination de Mr Stephen Paul Turner en tant qu'administrateur le 25 août 2016 | 2 pages | AP01 | ||||||||||
Cessation de la nomination de Guy Hetherington en tant que directeur le 10 mai 2016 | 1 pages | TM01 | ||||||||||
Déclaration annuelle jusqu'au 16 mars 2016 avec liste complète des actionnaires | 4 pages | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Comptes pour une société dormante établis au 31 déc. 2014 | 6 pages | AA | ||||||||||
Déclaration annuelle jusqu'au 16 mars 2015 avec liste complète des actionnaires | 4 pages | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Comptes pour une société dormante établis au 31 déc. 2013 | 6 pages | AA | ||||||||||
Qui sont les dirigeants de TRANSTAR LIMITED ?
| Nom | Nommé le | Date de démission | Rôle | Adresse | Identification de la société | Pays de résidence | Nationalité | Date de naissance | Profession | Numéro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EJUPI, Michael | Administrateur | C/O Victor Products Ltd, Tyne Dock East Side Port Of Tyne NE33 5SQ South Shields Unit 3a Tyne And Wear England | United States | American | 212491340001 | |||||
| HUDSON, Ian | Administrateur | C/O Victor Products Ltd, Tyne Dock East Side Port Of Tyne NE33 5SQ South Shields Unit 3a Tyne And Wear England | United States | American | 238992200001 | |||||
| VINOKUR, Svetlana | Administrateur | C/O Victor Products Ltd, Tyne Dock East Side Port Of Tyne NE33 5SQ South Shields Unit 3a Tyne And Wear England | United States | American | 238990610001 | |||||
| CLAY, David Nicholas | Secrétaire | 37 Larkhill Lane Formby L37 1LT Liverpool Merseyside | British | 45215990001 | ||||||
| CLAY, David Nicholas | Secrétaire | 37 Larkhill Lane Formby L37 1LT Liverpool Merseyside | British | 45215990001 | ||||||
| CRAIG, Charles Thomas | Secrétaire | 18 Manor House Road Jesmond NE2 2LU Newcastle Upon Tyne Tyne & Wear | British | 8699370001 | ||||||
| DIXON, John | Secrétaire | 6 Shawbrow Close Dalesford Green NE7 7GW Newcastle Upon Tyne | British | 64250670002 | ||||||
| JORDAN, Margaret Elizabeth | Secrétaire | 63 Harington Green L37 1PN Formby Merseyside | British | 47125150001 | ||||||
| NICHOLSON, Clive | Secrétaire | Dene Holme Lucy Street NE21 5PU Blaydon Tyne & Wear | British | 38845730003 | ||||||
| NICHOLSON, Clive | Secrétaire | 7 Mary Agnes Street South Gosforth NE3 3XB Newcastle Tyne & Wear | British | 38845730002 | ||||||
| TURNER, Stephen Paul | Secrétaire | C/O Victor Products Ltd, Tyne Dock East Side Port Of Tyne NE33 5SQ South Shields Unit 3a Tyne And Wear England | British | 109249450003 | ||||||
| WARREN, John Emmerson | Secrétaire | 1 Gellesfield Chare Whickham NE16 5TQ Newcastle Upon Tyne | British | 796200001 | ||||||
| ALLAN, Gerard | Administrateur | 2 Glastonbury Close Priors Green DL16 6XP Spennymoor Durham | British | 44566730001 | ||||||
| CONE, Harry Douglas | Administrateur | 5 The Orchard Hepscott NE61 6HT Morpeth Northumberland | British | 796210001 | ||||||
| DIXON, John | Administrateur | 6 Shawbrow Close Dalesford Green NE7 7GW Newcastle Upon Tyne | British | 64250670002 | ||||||
| GUILE, Peter Richard | Administrateur | 516 Durham Drive Frankfort Il 60423 Usa | British | 56096610002 | ||||||
| HANKINS, Michael Freeman | Administrateur | Flat 2 Guisnes Court Chapel Road Tolleshunt Darcy CM9 8TL Maldon Essex | British | 12578790001 | ||||||
| HEARNE, John Thomas | Administrateur | 16947 Pineview Drive Lockport Illinois 60441 Usa | Usa Citizen | 70629260001 | ||||||
| HETHERINGTON, Guy | Administrateur | New York Way New York Industrial Park NE27 0QF Newcastle Upon Tyne Tyne & Wear | United Kingdom | British | 109820740003 | |||||
| JACKSON, Hugh Graham | Administrateur | 41 Eastern Way Ponteland NE20 9RD Newcastle Upon Tyne Tyne & Wear | British | 8699390001 | ||||||
| JORDAN, Keith Stuart | Administrateur | 63 Harington Green Formby L37 1PN Liverpool Silverdale | England | British | 139201050001 | |||||
| MARSH, Anthony Richard | Administrateur | 197 Melton Road NG12 4BU Nottingham Nottinghamshire | Irish | 34189400002 | ||||||
| NICHOLSON, Clive | Administrateur | 7 Mary Agnes Street South Gosforth NE3 3XB Newcastle Tyne & Wear | British | 38845730002 | ||||||
| NICHOLSON, Clive | Administrateur | Dene Holme Lucy Street NE21 5PU Blaydon Tyne & Wear | British | 38845730003 | ||||||
| PICKERING, James Gordon | Administrateur | Silverhill House 270a Ecclesall Road South S11 9PS Sheffield South Yorkshire | British | 37974600001 | ||||||
| TURNER, Stephen Paul | Administrateur | C/O Victor Products Ltd, Tyne Dock East Side Port Of Tyne NE33 5SQ South Shields Unit 3a Tyne And Wear England | Great Britain | British | 212939770001 | |||||
| WILSON, Barry | Administrateur | C/O Victor Products Ltd, Tyne Dock East Side Port Of Tyne NE33 5SQ South Shields Unit 3a Tyne And Wear England | Usa | British | 79691350003 |
Qui sont les personnes ayant un contrôle significatif sur TRANSTAR LIMITED ?
| Nom | Notifié le | Adresse | Cessé | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Victor Products Holdings Ltd | 06 avr. 2016 | Tyne Dock East Side Port Of Tyne NE33 5SQ South Shields Unit 3a Tyne And Wear England | Non | ||||||||||
| |||||||||||||
Nature du contrôle
| |||||||||||||
Quelles sont les dernières déclarations sur les personnes ayant un contrôle significatif pour TRANSTAR LIMITED ?
| Notifié le | Cessé le | Déclaration |
|---|---|---|
| 16 mars 2017 | La société a identifié une personne enregistrable en relation avec la société, mais toutes les informations requises sur cette personne n'ont pas été confirmées. |
TRANSTAR LIMITED a-t-elle des charges ?
| Classification | Dates | Statut | Détails | |
|---|---|---|---|---|
| Debenture | Créé le 27 févr. 1994 Livré le 04 mai 1994 | Totalement satisfaite | Montant garanti A term loan facility in the maximum principal amount of £4,000,000 and the revolving credit facility and working capital facility in the maximum aggregate amount of £2,000,000 due or to become due from tiposon limited to the chargee as defined in a facilities agreement | |
Brèves mentions The l/h property k/as site numbers bt 98/1 and 98/7 victoria road,west hebburn.t/no.TY69123 and any other f/h or l/h property vested in the company on 26 february 1994 and fixed equitable charge all its right title and interest in any f/h or l/h property acquired at any time after 26 february 1994.by way of charge over all those other assets undertakings and rights of the company present and future.equitable assignment the benefit of all those rights and remedies specified in clause 3.3 of the debenture.floating charge the company's undertaking and all its property rights and assets. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
| Legal charge | Créé le 27 févr. 1994 Livré le 04 mai 1994 | Totalement satisfaite | Montant garanti A term loan facility in the maximum principal amount of £4,000,000 and the revolving credit facility and working capital facility in the maximum principal amount of £2,000,000 due or to become due from tiposon limited under the terms of a facilities agreement and this charge | |
Brèves mentions The f/h property k/as site numbers BT98/1 and 98/7 victoria road,west hebburn.t/no.TY69123.fixed charge all those rights benefits and interests set out in clause 3.2 of the legal charge.by way of assignment in equity the benefit of all those rights remedies and interests specified in clause 3.3 of the legal charge. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
| Guarantee and collateral debenture | Créé le 27 févr. 1994 Livré le 08 mars 1994 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from tiposon limited to the chargee on any account whatsoever | |
Brèves mentions The l/h property k/as site numbers BT98/1 and 98/7 victoria road,west hebburn tyne and wear.t/no.TY69123. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
| Debenture | Créé le 18 sept. 1964 Livré le 05 oct. 1964 | En cours | Montant garanti All moneys due etc. | |
Brèves mentions Undertaking and goodwill all property and assets rpesent and future including uncalled capital. Fixed plant and machinery (see doc 10). | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
Source de données
- Companies House du Royaume-Uni
Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers. - Licence: CC0