TRANSTAR LIMITED

  • Vue d'ensemble
  • Résumé
  • Objet social
  • Adresse
  • Comptes
  • Dépôts
  • Dirigeants
  • Personnes ayant un contrôle significatif
  • Déclarations des personnes ayant un contrôle significatif
  • Charges
  • Source de données
  • Vue d'ensemble

    Nom de la sociétéTRANSTAR LIMITED
    Statut de la sociétéDissoute
    Forme juridiqueSociété à responsabilité limitée
    Numéro de société 00785717
    JuridictionAngleterre/Pays de Galles
    Date de création
    Date de cessation d'activité

    Résumé

    A des PSCs super sécurisésNon
    A des chargesOui
    A un historique d'insolvabilitéNon
    Le siège social est contestéNon

    Quel est l'objet de TRANSTAR LIMITED ?

    • Société inactive (99999) / Activités des organisations et organismes extraterritoriaux

    Où se situe TRANSTAR LIMITED ?

    Adresse du siège social
    Unit 3a C/O Victor Products Ltd, Tyne Dock East Side
    Port Of Tyne
    NE33 5SQ South Shields
    Tyne And Wear
    England
    Adresse du siège social non livrableNon

    Quels sont les derniers comptes de TRANSTAR LIMITED ?

    Derniers comptes
    Derniers comptes arrêtés au31 déc. 2016

    Quels sont les derniers dépôts pour TRANSTAR LIMITED ?

    Dépôts
    DateDescriptionDocumentType

    Bulletin officiel final dissous par radiation volontaire

    1 pagesGAZ2(A)

    Premier avis au Bulletin officiel pour la radiation volontaire

    1 pagesGAZ1(A)

    État du capital au 24 juil. 2018

    • Capital: GBP 1
    3 pagesSH19

    Demande de radiation de la société du registre du commerce

    3 pagesDS01

    legacy

    1 pagesSH20

    legacy

    1 pagesCAP-SS

    Résolutions

    Resolutions
    1 pagesRESOLUTIONS
    Résolutions
    CatégorieDateDescriptionType
    capital

    Résolution de réduction du capital social émis

    RES06

    Déclaration de confirmation établie le 16 mars 2018 sans mise à jour

    3 pagesCS01

    Cessation de la nomination de Barry Wilson en tant que directeur le 15 janv. 2018

    1 pagesTM01

    Nomination de Mr Michael Ejupi en tant qu'administrateur le 13 oct. 2017

    2 pagesAP01

    Nomination de Ms Svetlana Vinokur en tant qu'administrateur le 13 oct. 2017

    2 pagesAP01

    Nomination de Mr Ian Hudson en tant qu'administrateur le 13 oct. 2017

    2 pagesAP01

    Cessation de la nomination de Stephen Paul Turner en tant que directeur le 13 oct. 2017

    1 pagesTM01

    Cessation de la nomination de Stephen Paul Turner en tant que secrétaire le 13 oct. 2017

    1 pagesTM02

    Comptes pour une société dormante établis au 31 déc. 2016

    6 pagesAA

    Notification de Victor Products Holdings Ltd en tant que personne disposant d'un contrôle significatif le 06 avr. 2016

    2 pagesPSC02

    Changement d'adresse du siège social de New York Way New York Industrial Park Newcastle upon Tyne Tyne & Wear NE27 0QF à Unit 3a C/O Victor Products Ltd, Tyne Dock East Side Port of Tyne South Shields Tyne and Wear NE33 5SQ le 17 juil. 2017

    1 pagesAD01

    Déclaration de confirmation établie le 16 mars 2017 avec mises à jour

    5 pagesCS01

    Comptes pour une société dormante établis au 31 déc. 2015

    6 pagesAA

    Nomination de Mr Stephen Paul Turner en tant qu'administrateur le 25 août 2016

    2 pagesAP01

    Cessation de la nomination de Guy Hetherington en tant que directeur le 10 mai 2016

    1 pagesTM01

    Déclaration annuelle jusqu'au 16 mars 2016 avec liste complète des actionnaires

    4 pagesAR01
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    capital06 avr. 2016

    État du capital au 06 avr. 2016

    • Capital: GBP 40,400
    SH01

    Comptes pour une société dormante établis au 31 déc. 2014

    6 pagesAA

    Déclaration annuelle jusqu'au 16 mars 2015 avec liste complète des actionnaires

    4 pagesAR01
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    capital24 mars 2015

    État du capital au 24 mars 2015

    • Capital: GBP 40,400
    SH01

    Comptes pour une société dormante établis au 31 déc. 2013

    6 pagesAA

    Qui sont les dirigeants de TRANSTAR LIMITED ?

    Dirigeants
    NomNommé leDate de démissionRôleAdresseIdentification de la sociétéPays de résidenceNationalitéDate de naissanceProfessionNuméro
    EJUPI, Michael
    C/O Victor Products Ltd, Tyne Dock East Side
    Port Of Tyne
    NE33 5SQ South Shields
    Unit 3a
    Tyne And Wear
    England
    Administrateur
    C/O Victor Products Ltd, Tyne Dock East Side
    Port Of Tyne
    NE33 5SQ South Shields
    Unit 3a
    Tyne And Wear
    England
    United StatesAmerican212491340001
    HUDSON, Ian
    C/O Victor Products Ltd, Tyne Dock East Side
    Port Of Tyne
    NE33 5SQ South Shields
    Unit 3a
    Tyne And Wear
    England
    Administrateur
    C/O Victor Products Ltd, Tyne Dock East Side
    Port Of Tyne
    NE33 5SQ South Shields
    Unit 3a
    Tyne And Wear
    England
    United StatesAmerican238992200001
    VINOKUR, Svetlana
    C/O Victor Products Ltd, Tyne Dock East Side
    Port Of Tyne
    NE33 5SQ South Shields
    Unit 3a
    Tyne And Wear
    England
    Administrateur
    C/O Victor Products Ltd, Tyne Dock East Side
    Port Of Tyne
    NE33 5SQ South Shields
    Unit 3a
    Tyne And Wear
    England
    United StatesAmerican238990610001
    CLAY, David Nicholas
    37 Larkhill Lane
    Formby
    L37 1LT Liverpool
    Merseyside
    Secrétaire
    37 Larkhill Lane
    Formby
    L37 1LT Liverpool
    Merseyside
    British45215990001
    CLAY, David Nicholas
    37 Larkhill Lane
    Formby
    L37 1LT Liverpool
    Merseyside
    Secrétaire
    37 Larkhill Lane
    Formby
    L37 1LT Liverpool
    Merseyside
    British45215990001
    CRAIG, Charles Thomas
    18 Manor House Road
    Jesmond
    NE2 2LU Newcastle Upon Tyne
    Tyne & Wear
    Secrétaire
    18 Manor House Road
    Jesmond
    NE2 2LU Newcastle Upon Tyne
    Tyne & Wear
    British8699370001
    DIXON, John
    6 Shawbrow Close
    Dalesford Green
    NE7 7GW Newcastle Upon Tyne
    Secrétaire
    6 Shawbrow Close
    Dalesford Green
    NE7 7GW Newcastle Upon Tyne
    British64250670002
    JORDAN, Margaret Elizabeth
    63 Harington Green
    L37 1PN Formby
    Merseyside
    Secrétaire
    63 Harington Green
    L37 1PN Formby
    Merseyside
    British47125150001
    NICHOLSON, Clive
    Dene Holme
    Lucy Street
    NE21 5PU Blaydon
    Tyne & Wear
    Secrétaire
    Dene Holme
    Lucy Street
    NE21 5PU Blaydon
    Tyne & Wear
    British38845730003
    NICHOLSON, Clive
    7 Mary Agnes Street
    South Gosforth
    NE3 3XB Newcastle
    Tyne & Wear
    Secrétaire
    7 Mary Agnes Street
    South Gosforth
    NE3 3XB Newcastle
    Tyne & Wear
    British38845730002
    TURNER, Stephen Paul
    C/O Victor Products Ltd, Tyne Dock East Side
    Port Of Tyne
    NE33 5SQ South Shields
    Unit 3a
    Tyne And Wear
    England
    Secrétaire
    C/O Victor Products Ltd, Tyne Dock East Side
    Port Of Tyne
    NE33 5SQ South Shields
    Unit 3a
    Tyne And Wear
    England
    British109249450003
    WARREN, John Emmerson
    1 Gellesfield Chare
    Whickham
    NE16 5TQ Newcastle Upon Tyne
    Secrétaire
    1 Gellesfield Chare
    Whickham
    NE16 5TQ Newcastle Upon Tyne
    British796200001
    ALLAN, Gerard
    2 Glastonbury Close
    Priors Green
    DL16 6XP Spennymoor
    Durham
    Administrateur
    2 Glastonbury Close
    Priors Green
    DL16 6XP Spennymoor
    Durham
    British44566730001
    CONE, Harry Douglas
    5 The Orchard
    Hepscott
    NE61 6HT Morpeth
    Northumberland
    Administrateur
    5 The Orchard
    Hepscott
    NE61 6HT Morpeth
    Northumberland
    British796210001
    DIXON, John
    6 Shawbrow Close
    Dalesford Green
    NE7 7GW Newcastle Upon Tyne
    Administrateur
    6 Shawbrow Close
    Dalesford Green
    NE7 7GW Newcastle Upon Tyne
    British64250670002
    GUILE, Peter Richard
    516 Durham Drive
    Frankfort
    Il 60423
    Usa
    Administrateur
    516 Durham Drive
    Frankfort
    Il 60423
    Usa
    British56096610002
    HANKINS, Michael Freeman
    Flat 2 Guisnes Court
    Chapel Road Tolleshunt Darcy
    CM9 8TL Maldon
    Essex
    Administrateur
    Flat 2 Guisnes Court
    Chapel Road Tolleshunt Darcy
    CM9 8TL Maldon
    Essex
    British12578790001
    HEARNE, John Thomas
    16947 Pineview Drive
    Lockport
    Illinois 60441
    Usa
    Administrateur
    16947 Pineview Drive
    Lockport
    Illinois 60441
    Usa
    Usa Citizen70629260001
    HETHERINGTON, Guy
    New York Way
    New York Industrial Park
    NE27 0QF Newcastle Upon Tyne
    Tyne & Wear
    Administrateur
    New York Way
    New York Industrial Park
    NE27 0QF Newcastle Upon Tyne
    Tyne & Wear
    United KingdomBritish109820740003
    JACKSON, Hugh Graham
    41 Eastern Way
    Ponteland
    NE20 9RD Newcastle Upon Tyne
    Tyne & Wear
    Administrateur
    41 Eastern Way
    Ponteland
    NE20 9RD Newcastle Upon Tyne
    Tyne & Wear
    British8699390001
    JORDAN, Keith Stuart
    63 Harington Green
    Formby
    L37 1PN Liverpool
    Silverdale
    Administrateur
    63 Harington Green
    Formby
    L37 1PN Liverpool
    Silverdale
    EnglandBritish139201050001
    MARSH, Anthony Richard
    197 Melton Road
    NG12 4BU Nottingham
    Nottinghamshire
    Administrateur
    197 Melton Road
    NG12 4BU Nottingham
    Nottinghamshire
    Irish34189400002
    NICHOLSON, Clive
    7 Mary Agnes Street
    South Gosforth
    NE3 3XB Newcastle
    Tyne & Wear
    Administrateur
    7 Mary Agnes Street
    South Gosforth
    NE3 3XB Newcastle
    Tyne & Wear
    British38845730002
    NICHOLSON, Clive
    Dene Holme
    Lucy Street
    NE21 5PU Blaydon
    Tyne & Wear
    Administrateur
    Dene Holme
    Lucy Street
    NE21 5PU Blaydon
    Tyne & Wear
    British38845730003
    PICKERING, James Gordon
    Silverhill House
    270a Ecclesall Road South
    S11 9PS Sheffield
    South Yorkshire
    Administrateur
    Silverhill House
    270a Ecclesall Road South
    S11 9PS Sheffield
    South Yorkshire
    British37974600001
    TURNER, Stephen Paul
    C/O Victor Products Ltd, Tyne Dock East Side
    Port Of Tyne
    NE33 5SQ South Shields
    Unit 3a
    Tyne And Wear
    England
    Administrateur
    C/O Victor Products Ltd, Tyne Dock East Side
    Port Of Tyne
    NE33 5SQ South Shields
    Unit 3a
    Tyne And Wear
    England
    Great BritainBritish212939770001
    WILSON, Barry
    C/O Victor Products Ltd, Tyne Dock East Side
    Port Of Tyne
    NE33 5SQ South Shields
    Unit 3a
    Tyne And Wear
    England
    Administrateur
    C/O Victor Products Ltd, Tyne Dock East Side
    Port Of Tyne
    NE33 5SQ South Shields
    Unit 3a
    Tyne And Wear
    England
    UsaBritish79691350003

    Qui sont les personnes ayant un contrôle significatif sur TRANSTAR LIMITED ?

    Personnes ayant un contrôle significatif
    NomNotifié leAdresseCessé
    Victor Products Holdings Ltd
    Tyne Dock East Side
    Port Of Tyne
    NE33 5SQ South Shields
    Unit 3a
    Tyne And Wear
    England
    06 avr. 2016
    Tyne Dock East Side
    Port Of Tyne
    NE33 5SQ South Shields
    Unit 3a
    Tyne And Wear
    England
    Non
    Forme juridiquePrivate Limited Company
    Pays d'enregistrementEngland
    Autorité légaleCompanies Act 2006
    Lieu d'enregistrementCompanies House, Cardiff
    Numéro d'enregistrement00241316
    Nature du contrôle
    • La personne détient, directement ou indirectement, plus de 75 % des actions de la société.
    • La personne détient, directement ou indirectement, plus de 75 % des droits de vote dans la société.
    • La personne détient, directement ou indirectement, le droit de nommer ou de révoquer une majorité des membres du conseil d'administration de la société.

    Quelles sont les dernières déclarations sur les personnes ayant un contrôle significatif pour TRANSTAR LIMITED ?

    Déclarations des personnes ayant un contrôle significatif
    Notifié leCessé leDéclaration
    16 mars 2017La société a identifié une personne enregistrable en relation avec la société, mais toutes les informations requises sur cette personne n'ont pas été confirmées.

    TRANSTAR LIMITED a-t-elle des charges ?

    Charges
    ClassificationDatesStatutDétails
    Debenture
    Créé le 27 févr. 1994
    Livré le 04 mai 1994
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    A term loan facility in the maximum principal amount of £4,000,000 and the revolving credit facility and working capital facility in the maximum aggregate amount of £2,000,000 due or to become due from tiposon limited to the chargee as defined in a facilities agreement
    Brèves mentions
    The l/h property k/as site numbers bt 98/1 and 98/7 victoria road,west hebburn.t/no.TY69123 and any other f/h or l/h property vested in the company on 26 february 1994 and fixed equitable charge all its right title and interest in any f/h or l/h property acquired at any time after 26 february 1994.by way of charge over all those other assets undertakings and rights of the company present and future.equitable assignment the benefit of all those rights and remedies specified in clause 3.3 of the debenture.floating charge the company's undertaking and all its property rights and assets.
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transactions
    • 04 mai 1994Enregistrement d'une charge (395)
    • 21 oct. 1997Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Legal charge
    Créé le 27 févr. 1994
    Livré le 04 mai 1994
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    A term loan facility in the maximum principal amount of £4,000,000 and the revolving credit facility and working capital facility in the maximum principal amount of £2,000,000 due or to become due from tiposon limited under the terms of a facilities agreement and this charge
    Brèves mentions
    The f/h property k/as site numbers BT98/1 and 98/7 victoria road,west hebburn.t/no.TY69123.fixed charge all those rights benefits and interests set out in clause 3.2 of the legal charge.by way of assignment in equity the benefit of all those rights remedies and interests specified in clause 3.3 of the legal charge. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transactions
    • 04 mai 1994Enregistrement d'une charge (395)
    • 21 oct. 1997Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Guarantee and collateral debenture
    Créé le 27 févr. 1994
    Livré le 08 mars 1994
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from tiposon limited to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    The l/h property k/as site numbers BT98/1 and 98/7 victoria road,west hebburn tyne and wear.t/no.TY69123. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • 3I Plcas Agent
    Transactions
    • 08 mars 1994Enregistrement d'une charge (395)
    • 21 juin 1996Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Debenture
    Créé le 18 sept. 1964
    Livré le 05 oct. 1964
    En cours
    Montant garanti
    All moneys due etc.
    Brèves mentions
    Undertaking and goodwill all property and assets rpesent and future including uncalled capital. Fixed plant and machinery (see doc 10).
    Personnes ayant droit
    • Martins Bank LTD
    Transactions
    • 05 oct. 1964Enregistrement d'une charge

    Source de données

    • Companies House du Royaume-Uni
      Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers.
    • Licence: CC0