MW (OLDCO) LIMITED
Vue d'ensemble
| Nom de la société | MW (OLDCO) LIMITED |
|---|---|
| Statut de la société | Dissoute |
| Forme juridique | Société à responsabilité limitée |
| Numéro de société | 00785935 |
| Juridiction | Angleterre/Pays de Galles |
| Date de création | |
| Date de cessation d'activité |
Résumé
| A des PSCs super sécurisés | Non |
|---|---|
| A des charges | Oui |
| A un historique d'insolvabilité | Non |
| Le siège social est contesté | Non |
Où se situe MW (OLDCO) LIMITED ?
| Adresse du siège social | 1 Chamberlain Square Cs B3 3AX Birmingham United Kingdom |
|---|---|
| Adresse du siège social non livrable | Non |
Quels sont les derniers comptes de MW (OLDCO) LIMITED ?
| Derniers comptes | |
|---|---|
| Derniers comptes arrêtés au | 31 mai 2020 |
Quels sont les derniers dépôts pour MW (OLDCO) LIMITED ?
| Date | Description | Document | Type | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bulletin officiel final dissous par radiation volontaire | 1 pages | GAZ2(A) | ||||||||||
La procédure de radiation volontaire a été suspendue. | 1 pages | SOAS(A) | ||||||||||
Premier avis au Bulletin officiel pour la radiation volontaire | 1 pages | GAZ1(A) | ||||||||||
Demande de radiation de la société du registre du commerce | 4 pages | DS01 | ||||||||||
Déclaration de confirmation établie le 25 mai 2022 avec mises à jour | 5 pages | CS01 | ||||||||||
État du capital au 25 avr. 2022
| 3 pages | SH19 | ||||||||||
legacy | 3 pages | SH20 | ||||||||||
legacy | 3 pages | CAP-SS | ||||||||||
Résolutions Resolutions | 2 pages | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
Modification des détails de Morrells Woodfinishes Limited en tant que personne disposant d'un contrôle significatif le 30 juil. 2021 | 2 pages | PSC05 | ||||||||||
Changement d'adresse du siège social de Hays Galleria 1 Hays Lane London SE1 2rd à 1 Chamberlain Square Cs Birmingham B3 3AX le 30 juil. 2021 | 1 pages | AD01 | ||||||||||
Déclaration de confirmation établie le 25 mai 2021 sans mise à jour | 3 pages | CS01 | ||||||||||
Comptes annuels établis au 31 mai 2020 | 35 pages | AA | ||||||||||
Modification des détails de F T Morrwll & Company Limited en tant que personne disposant d'un contrôle significatif le 27 févr. 2021 | 2 pages | PSC05 | ||||||||||
Résolutions Resolutions | 2 pages | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
Avis de changement de nom" | 2 pages | CONNOT | ||||||||||
Déclaration de confirmation établie le 25 mai 2020 sans mise à jour | 3 pages | CS01 | ||||||||||
Nomination de Johnny W. Green Jr en tant qu'administrateur le 28 févr. 2020 | 2 pages | AP01 | ||||||||||
Cessation de la nomination de Lesley Philippa Bridgwater en tant que directeur le 28 févr. 2020 | 1 pages | TM01 | ||||||||||
Cessation de la nomination de Anthony Stuart O'connor en tant que directeur le 28 févr. 2020 | 1 pages | TM01 | ||||||||||
Comptes annuels établis au 31 mai 2019 | 34 pages | AA | ||||||||||
Déclaration de confirmation établie le 25 mai 2019 sans mise à jour | 3 pages | CS01 | ||||||||||
Cessation de la nomination de Stephen James Knoop en tant que directeur le 15 mars 2019 | 1 pages | TM01 | ||||||||||
Comptes annuels établis au 31 mai 2018 | 32 pages | AA | ||||||||||
Déclaration de confirmation établie le 25 mai 2018 sans mise à jour | 3 pages | CS01 | ||||||||||
Qui sont les dirigeants de MW (OLDCO) LIMITED ?
| Nom | Nommé le | Date de démission | Rôle | Adresse | Identification de la société | Pays de résidence | Nationalité | Date de naissance | Profession | Numéro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DRAYTON, Scott Geoffrey Cameron | Administrateur | Chamberlain Square Cs B3 3AX Birmingham 1 United Kingdom | England | British | 64518310003 | |||||
| GREEN JR, Johnny W. | Administrateur | Chamberlain Square Cs B3 3AX Birmingham 1 United Kingdom | United States | American | 269441510001 | |||||
| HOLMAN, Ronnie Gene | Administrateur | Chamberlain Square Cs B3 3AX Birmingham 1 United Kingdom | United States | American | 197026090001 | |||||
| BRIDGWATER, Lesley Philippa | Secrétaire | St. Margarets Street CT1 2TU Canterbury 37 Kent England | 148880010001 | |||||||
| MORRELL, Graham | Secrétaire | 24 Davenport Park Road SK2 6JS Stockport Cheshire | British | 39067760002 | ||||||
| MORRELL, Peter Henry | Secrétaire | 5 Tollgate Close Bromham MK43 8QN Bedford Bedfordshire | British | 12082820001 | ||||||
| PRIOR, Michael John | Secrétaire | 9 Gaddum Road Bowdon WA14 3PD Altrincham Cheshire | British | 69677460003 | ||||||
| BOYLE, Alexander Stewart | Administrateur | 5 Forge Close Kirklington NG22 8GZ Newark Nottinghamshire | British | 1106110003 | ||||||
| BRANDON, Robin Nichol | Administrateur | High Field Woodhouse End Road, Gawsworth SK11 9QS Macclesfield Cheshire | British | 66402440001 | ||||||
| BRIDGWATER, Lesley Philippa | Administrateur | 1 Hays Lane SE1 2RD London Hays Galleria | England | British | 95186950001 | |||||
| CAMPBELL, Anthony Reginald | Administrateur | Manor Farm Barn Little Hadham SG11 2DD Bishops Stortford Herts | United Kingdom | British | 127223200001 | |||||
| CHURCHMAN, Anthony | Administrateur | 13a Eastfield Road SG8 7ED Royston Hertfordshire | British | 48018980001 | ||||||
| FYNN, Jeremy Martin Newnham | Administrateur | 7 Richmond Road Heaton Hersey SK4 3BZ Stockport Cheshire | England | British | 98086980001 | |||||
| KNOOP, Stephen James | Administrateur | 1 Hays Lane SE1 2RD London Hays Galleria | United States | American | 197026110001 | |||||
| MOORE, Edward Winslow | Administrateur | 1 Hays Lane SE1 2RD London Hays Galleria | United States | American | 151290070001 | |||||
| MORRELL, Graham | Administrateur | 24 Davenport Park Road SK2 6JS Stockport Cheshire | British | 39067760002 | ||||||
| MORRELL, Joseph Bertram | Administrateur | 15 Chipperfield Road WD4 9JB Kings Langley Herts | England | British | 12082830001 | |||||
| MORRELL, Peter Henry | Administrateur | 5 Tollgate Close Bromham MK43 8QN Bedford Bedfordshire | British | 12082820001 | ||||||
| O'CONNOR, Anthony Stuart | Administrateur | 1 Hays Lane SE1 2RD London Hays Galleria | United Kingdom | British | 71023900003 | |||||
| POOLEY, John | Administrateur | 5 Hampshire Close SK13 8SA Glossop Derbyshire | British | 66402360001 | ||||||
| RICE, Ronald Albert | Administrateur | 1 Hays Lane SE1 2RD London Hays Galleria | United States | American | 115014650001 |
Qui sont les personnes ayant un contrôle significatif sur MW (OLDCO) LIMITED ?
| Nom | Notifié le | Adresse | Cessé | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Morrells Woodfinishes Limited | 06 avr. 2016 | Chamberlain Square Cs B3 3AX Birmingham 1 United Kingdom | Non | ||||||||||
| |||||||||||||
Nature du contrôle
| |||||||||||||
MW (OLDCO) LIMITED a-t-elle des charges ?
| Classification | Dates | Statut | Détails | |
|---|---|---|---|---|
| A registered charge | Créé le 04 août 2017 Livré le 04 août 2017 | En cours | ||
Brève description None. Contient une promesse négative: Oui Contient une charge fixe: Oui | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
| Debenture | Créé le 20 mai 2010 Livré le 28 mai 2010 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brèves mentions Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
| Debenture | Créé le 04 janv. 2002 Livré le 05 janv. 2002 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brèves mentions Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
| Guarantee & debenture | Créé le 15 févr. 2001 Livré le 07 mars 2001 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever | |
Brèves mentions Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
| Guarantee & debenture | Créé le 19 déc. 2000 Livré le 08 janv. 2001 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever | |
Brèves mentions Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
| Debenture | Créé le 13 mars 1997 Livré le 18 mars 1997 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brèves mentions Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
| Legal charge | Créé le 27 juil. 1994 Livré le 29 juil. 1994 | Totalement satisfaite | Montant garanti £300,000 and all other monies due or to become due from the company to the chargee | |
Brèves mentions Wood house (formerly alban court) being part of brownfields welwyn garden city t/n HD232337. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
| Legal charge | Créé le 01 déc. 1993 Livré le 14 déc. 1993 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brèves mentions Botany mill and land lying north of woodlands drive woodley greater manchester title no GM107143. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
| Legal charge | Créé le 27 janv. 1989 Livré le 09 févr. 1989 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brèves mentions 212 acton lane l/b of brent title no ngl 458972. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
| Legal charge | Créé le 08 déc. 1977 Livré le 20 déc. 1977 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brèves mentions 214 acton lane, harlesden, brent, london, nw 10 as comprised in a lease dated 11.11.76. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
Source de données
- Companies House du Royaume-Uni
Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers. - Licence: CC0