FENCLOVE CONTROLLERS LIMITED

FENCLOVE CONTROLLERS LIMITED

  • Vue d'ensemble
  • Résumé
  • Objet social
  • Adresse
  • Dénominations sociales précédentes
  • Comptes
  • Dépôts
  • Dirigeants
  • Personnes ayant un contrôle significatif
  • Charges
  • Insolvabilité
  • Source de données
  • Vue d'ensemble

    Nom de la sociétéFENCLOVE CONTROLLERS LIMITED
    Statut de la sociétéDissoute
    Forme juridiqueSociété à responsabilité limitée
    Numéro de société 00786405
    JuridictionAngleterre/Pays de Galles
    Date de création
    Date de cessation d'activité

    Résumé

    A des PSCs super sécurisésNon
    A des chargesOui
    A un historique d'insolvabilitéOui
    Le siège social est contestéNon

    Quel est l'objet de FENCLOVE CONTROLLERS LIMITED ?

    • fabrication d'appareils de distribution et de contrôle de l'électricité (27120) / Industries manufacturières

    Où se situe FENCLOVE CONTROLLERS LIMITED ?

    Adresse du siège social
    C/O Larking Gowen 1st Floor Prospect House
    Rouen Road
    NR1 1RE Norwich
    Adresse du siège social non livrableNon

    Quels étaient les noms précédents de FENCLOVE CONTROLLERS LIMITED ?

    Dénominations sociales précédentes
    Nom de la sociétéDeJusqu'au
    SUNVIC CONTROLS LIMITED01 mai 198801 mai 1988
    PEGLER-SUNVIC LIMITED13 juin 198513 juin 1985
    SATCHWELL SUNVIC LIMITED01 janv. 196401 janv. 1964

    Quels sont les derniers comptes de FENCLOVE CONTROLLERS LIMITED ?

    Derniers comptes
    Derniers comptes arrêtés au30 juin 2017

    Quels sont les derniers dépôts pour FENCLOVE CONTROLLERS LIMITED ?

    Dépôts
    DateDescriptionDocumentType

    Gazette finale dissoute à la suite d'une liquidation

    1 pagesGAZ2

    Avis de compte final avant dissolution

    17 pagesWU15

    Changement d'adresse du siège social de King Street House 15 Upper King Street Norwich Norfolk NR3 1RB à C/O Larking Gowen 1st Floor Prospect House Rouen Road Norwich NR1 1RE le 02 mars 2023

    2 pagesAD01

    Rapport d'avancement dans une liquidation par le tribunal

    14 pagesWU07

    Satisfaction de la charge 007864050014 en totalité

    4 pagesMR04

    Rapport d'avancement dans une liquidation par le tribunal

    13 pagesWU07

    Rapport d'avancement dans une liquidation par le tribunal

    14 pagesWU07

    Satisfaction de la charge 007864050013 en totalité

    1 pagesMR04

    Changement d'adresse du siège social de C/O Jpc Financial Limited 2nd Floor, Lynton House Station Approach Woking Surrey GU22 7PY England à King Street House 15 Upper King Street Norwich Norfolk NR3 1RB le 17 oct. 2019

    1 pagesAD01

    Nomination d'un liquidateur

    5 pagesWU04

    Ordonnance du tribunal pour liquider

    2 pagesCOCOMP

    Cessation de la nomination de James Hugh David Meddings en tant que directeur le 28 janv. 2019

    1 pagesTM01

    Résolutions

    Resolutions
    3 pagesRESOLUTIONS
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    change-of-name23 janv. 2019

    Changement de nom" par résolution

    NM01
    Résolutions
    CatégorieDateDescriptionType
    change-of-name

    Résolution de changement de nom

    RES15

    Nomination de Sunrae Limited en tant qu'administrateur le 22 janv. 2019

    2 pagesAP02

    Nomination de Mr Yalaju Oritseweyinmi en tant qu'administrateur le 08 janv. 2019

    2 pagesAP01

    Inscription de la charge 007864050014, créée le 16 janv. 2019

    41 pagesMR01

    Déclaration de confirmation établie le 01 janv. 2019 sans mise à jour

    3 pagesCS01

    Cessation de la nomination de David Meddings en tant que directeur le 03 nov. 2018

    1 pagesTM01

    Nomination de Mr David Meddings en tant qu'administrateur le 21 sept. 2018

    2 pagesAP01

    Cessation de la nomination de Niton Associates Llp en tant que directeur le 25 sept. 2018

    1 pagesTM01

    Comptes non audités abrégés arrêtés au 30 juin 2017

    9 pagesAA

    Déclaration de confirmation établie le 01 janv. 2018 avec mises à jour

    4 pagesCS01

    Comptes d'exonération totale pour petite entreprise établis au 30 juin 2016

    4 pagesAA

    Déclaration de confirmation établie le 01 janv. 2017 avec mises à jour

    5 pagesCS01

    Modification des coordonnées de l'administrateur Mr James Hugh David Meddings le 15 août 2016

    2 pagesCH01

    Qui sont les dirigeants de FENCLOVE CONTROLLERS LIMITED ?

    Dirigeants
    NomNommé leDate de démissionRôleAdresseIdentification de la sociétéPays de résidenceNationalitéDate de naissanceProfessionNuméro
    ORITSEWEYINMI, Yalaju
    1st Floor Prospect House
    Rouen Road
    NR1 1RE Norwich
    C/O Larking Gowen
    Administrateur
    1st Floor Prospect House
    Rouen Road
    NR1 1RE Norwich
    C/O Larking Gowen
    NigeriaNigerianDirector254483870001
    SUNRAE LIMITED
    Cadzow Industrial Estate
    ML3 7QU Hamilton
    Block 1, Units 1&2
    Scotland
    Administrateur
    Cadzow Industrial Estate
    ML3 7QU Hamilton
    Block 1, Units 1&2
    Scotland
    Type d'identificationSociété à responsabilité limitée du Royaume-Uni
    Numéro d'enregistrement546308
    254515780001
    BURTON, Denise Patricia
    55 Kingston Hill Place
    Kingston Hill
    KT2 7QY Kingston Upon Thames
    Surrey
    Secrétaire
    55 Kingston Hill Place
    Kingston Hill
    KT2 7QY Kingston Upon Thames
    Surrey
    British47432570002
    MARCHANT, Richard Norman
    60 The Mount
    Curdworth
    B76 9HR Sutton Coldfield
    West Midlands
    Secrétaire
    60 The Mount
    Curdworth
    B76 9HR Sutton Coldfield
    West Midlands
    British26880001
    PAULIN, William Lawrie
    76 Highfield Road
    CM1 2NQ Chelmsford
    Essex
    Secrétaire
    76 Highfield Road
    CM1 2NQ Chelmsford
    Essex
    BritishAccountant67714070004
    WATKINSON, David Scott
    109 Beeleigh Link
    CM2 6PH Chelmsford
    Essex
    Secrétaire
    109 Beeleigh Link
    CM2 6PH Chelmsford
    Essex
    EnglishManufacturer76097370001
    HADENBURY LIMITED
    Pembroke House
    11 Northlands Pavement
    SS13 3DX Pitsea Basildon
    Essex
    Secrétaire
    Pembroke House
    11 Northlands Pavement
    SS13 3DX Pitsea Basildon
    Essex
    93228320001
    BURGESS, Alan Donald
    14 Hillview
    Blackhall
    EH4 2AF Edinburgh
    Midlothian
    Administrateur
    14 Hillview
    Blackhall
    EH4 2AF Edinburgh
    Midlothian
    BritishDirector23248140002
    CONNER, Alan George
    4 Dinmurchie Road
    KA10 7JU Troon
    Ayrshire
    Administrateur
    4 Dinmurchie Road
    KA10 7JU Troon
    Ayrshire
    BritishDirector33143140001
    DUNCAN, Ian Alexander
    Durham House
    Durham Place
    SW3 4ET London
    Administrateur
    Durham House
    Durham Place
    SW3 4ET London
    United KingdomBritishDirector27300002
    FRANCIS, Corinna
    19 Cleves Way
    TW12 2PL Hampton
    Middlesex
    Administrateur
    19 Cleves Way
    TW12 2PL Hampton
    Middlesex
    BritishAdministrator77102960002
    LAING, George Thomas
    6 Lamford Drive
    Doonbank
    KA7 4DE Ayr
    Administrateur
    6 Lamford Drive
    Doonbank
    KA7 4DE Ayr
    BritishDirector33143150001
    MARCHANT, Richard Norman
    60 The Mount
    Curdworth
    B76 9HR Sutton Coldfield
    West Midlands
    Administrateur
    60 The Mount
    Curdworth
    B76 9HR Sutton Coldfield
    West Midlands
    BritishCompany Secretary/Director26880001
    MEDDINGS, David
    c/o Jpc Financial Limited
    Station Approach
    GU22 7PY Woking
    2nd Floor, Lynton House
    Surrey
    England
    Administrateur
    c/o Jpc Financial Limited
    Station Approach
    GU22 7PY Woking
    2nd Floor, Lynton House
    Surrey
    England
    EnglandBritishChartered Accountant250766670001
    MEDDINGS, David William
    c/o Jpc Financial Limited
    Station Approach
    GU22 7PY Woking
    2nd Floor, Lynton House
    Surrey
    England
    Administrateur
    c/o Jpc Financial Limited
    Station Approach
    GU22 7PY Woking
    2nd Floor, Lynton House
    Surrey
    England
    EnglandBritishDirector4416070012
    MEDDINGS, James Hugh David
    c/o Jpc Financial Limited
    Station Approach
    GU22 7PY Woking
    2nd Floor, Lynton House
    Surrey
    England
    Administrateur
    c/o Jpc Financial Limited
    Station Approach
    GU22 7PY Woking
    2nd Floor, Lynton House
    Surrey
    England
    EnglandBritishMarketing & Software Professional205294890002
    MOULTRIE, George Bell
    11 Bishopsgate Gardens
    G21 1XS Glasgow
    Administrateur
    11 Bishopsgate Gardens
    G21 1XS Glasgow
    BritishDirector33143160002
    PAULIN, Dale Murray
    c/o Jpc Financial Limited
    Station Approach
    GU22 7PY Woking
    2nd Floor, Lynton House
    Surrey
    England
    Administrateur
    c/o Jpc Financial Limited
    Station Approach
    GU22 7PY Woking
    2nd Floor, Lynton House
    Surrey
    England
    EnglandBritishManager106440270002
    PAULIN, William Lawrie
    76 Highfield Road
    CM1 2NQ Chelmsford
    Essex
    Administrateur
    76 Highfield Road
    CM1 2NQ Chelmsford
    Essex
    BritishAccountant67714070004
    READING, Anthony John
    16 Heatherside Gardens
    Farnham Common
    SL2 3RR Slough
    Berkshire
    Administrateur
    16 Heatherside Gardens
    Farnham Common
    SL2 3RR Slough
    Berkshire
    United KingdomBritishDirector17110410001
    ROSS, Francis Wright
    63 Saughton Road North
    EH12 7JA Edinburgh
    Midlothian
    Administrateur
    63 Saughton Road North
    EH12 7JA Edinburgh
    Midlothian
    ScotlandBritishFinancial Director66727300001
    ROSS, Francis Wright
    63 Saughton Road North
    EH12 7JA Edinburgh
    Midlothian
    Administrateur
    63 Saughton Road North
    EH12 7JA Edinburgh
    Midlothian
    ScotlandBritishFinance Director66727300001
    SAMBOREK, Peter John
    6 Virginia Gardens
    Milngavie
    G62 6LG Glasgow
    Administrateur
    6 Virginia Gardens
    Milngavie
    G62 6LG Glasgow
    ScotlandBritishDirector280030002
    SMITH, James Charles
    12 Park Road
    SG19 1JB Sandy
    Bedfordshire
    Administrateur
    12 Park Road
    SG19 1JB Sandy
    Bedfordshire
    EnglandBritishDirector77399290001
    STARK, John David Sinclair
    Tara 15 Copsem Drive
    KT10 9HD Esher
    Surrey
    Administrateur
    Tara 15 Copsem Drive
    KT10 9HD Esher
    Surrey
    BritishDirector27350001
    WILLIAMS, Alan Arthur
    7 Heath Road
    ML9 2JE Larkhall
    Lanarkshire
    Administrateur
    7 Heath Road
    ML9 2JE Larkhall
    Lanarkshire
    BritishDirector33143170001
    BESTBRAY LIMITED
    Pembroke House11 Northlands
    Pavement
    SS13 3DX Pitsea
    Essex
    Administrateur
    Pembroke House11 Northlands
    Pavement
    SS13 3DX Pitsea
    Essex
    99032820001
    CORROBAN LTD
    11 Northlands Pavement
    Pitsea
    SS13 3DX Basildon
    Essex
    Administrateur
    11 Northlands Pavement
    Pitsea
    SS13 3DX Basildon
    Essex
    92801740001
    HADENBURY LTD
    11 Northlands Pavement
    Pitsea
    SS13 3DX Basildon
    Essex
    Administrateur
    11 Northlands Pavement
    Pitsea
    SS13 3DX Basildon
    Essex
    92801660001
    NITON ASSOCIATES LLP
    Temple Chambers
    5-7 Temple Avenue
    EC4Y 0HP London
    135
    England
    Administrateur
    Temple Chambers
    5-7 Temple Avenue
    EC4Y 0HP London
    135
    England
    Forme juridiqueLIMITED LIABILITY PARTNERSHIP
    Type d'identificationHors EEE
    Autorité légaleLIMITED LIABILITY PARTNERSHIPS ACT
    Numéro d'enregistrementOC398586
    205269510001

    Qui sont les personnes ayant un contrôle significatif sur FENCLOVE CONTROLLERS LIMITED ?

    Personnes ayant un contrôle significatif
    NomNotifié leAdresseCessé
    Mr James Hugh David Meddings
    1st Floor Prospect House
    Rouen Road
    NR1 1RE Norwich
    C/O Larking Gowen
    01 janv. 2017
    1st Floor Prospect House
    Rouen Road
    NR1 1RE Norwich
    C/O Larking Gowen
    Non
    Nationalité: British
    Pays de résidence: England
    Nature du contrôle
    • La personne a le droit d'exercer, ou exerce effectivement, une influence ou un contrôle significatif sur la société.

    FENCLOVE CONTROLLERS LIMITED a-t-elle des charges ?

    Charges
    ClassificationDatesStatutDétails
    A registered charge
    Créé le 16 janv. 2019
    Livré le 18 janv. 2019
    Totalement satisfaite
    Brève description
    Plant & machinery. Contains fixed(s). Contains floating charge(s) (floating charge covers all the property or undertaking of the company). Contains negative pledge.
    La charge flottante couvre tout: Oui
    Contient une promesse négative: Oui
    Contient une charge flottante: Oui
    Contient une charge fixe: Oui
    Personnes ayant droit
    • Ktwo Brands Limited
    Transactions
    • 18 janv. 2019Enregistrement d'une charge (MR01)
    • 26 mai 2022Satisfaction d'une charge (MR04)
    A registered charge
    Créé le 02 mars 2016
    Livré le 09 mars 2016
    Totalement satisfaite
    Brève description
    All of the freehold and leasehold property now vested in the company including, but not limited to, the properties short particulars of which is or are set out in schedule 1 of the factoring debenture.. All buildings and fixtures (including trade fixtures, tenant's fixtures and fixed plant and equipment) on all freehold and leasehold property or interest of the company in any of the same mortgaged or charged under the factoring debenture and includes any part of it.. Goodwill (which shall include all brand names), licenses, trademarks and service marks, patents, patent applications, designs, copyrights, confidential information, know-how, computer software and all other intellectual or intangible property or rights now and from time to time belonging to the company.
    La charge flottante couvre tout: Oui
    Contient une promesse négative: Oui
    Contient une charge flottante: Oui
    Contient une charge fixe: Oui
    Personnes ayant droit
    • Paragon Bank Business Finance PLC
    Transactions
    • 09 mars 2016Enregistrement d'une charge (MR01)
    • 25 sept. 2020Satisfaction d'une charge (MR04)
    All assets debenture
    Créé le 27 juil. 2012
    Livré le 31 juil. 2012
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    Personnes ayant droit
    • Rbs Invoice Finance Limited
    Transactions
    • 31 juil. 2012Enregistrement d'une charge (MG01)
    • 05 mai 2016Satisfaction d'une charge (MR04)
    Debenture
    Créé le 17 oct. 2006
    Livré le 25 oct. 2006
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personnes ayant droit
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transactions
    • 25 oct. 2006Enregistrement d'une charge (395)
    • 02 mars 2016Satisfaction d'une charge (MR04)
    Fixed and floating charge
    Créé le 10 févr. 2006
    Livré le 16 févr. 2006
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Rbs Invoice Finance Limited
    Transactions
    • 16 févr. 2006Enregistrement d'une charge (395)
    • 05 mai 2016Satisfaction d'une charge (MR04)
    Standard security which was presented for registration in scotland on 10TH august 2004 and
    Créé le 04 juin 2004
    Livré le 27 août 2004
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee
    Brèves mentions
    All and whole (one) all and whole those subjects k/a unit 1, bellshill road, bothwell park industrial estate, uddingston, glasgow lying the parish of bothwell and county of lanark extending to two hectares and fourteen decimal (2.1HA) metric measure and (two) all and whole the subjects registered under t/no LAN145487 together with by way of security not exception (one) the whole buildings. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transactions
    • 27 août 2004Enregistrement d'une charge (395)
    • 05 sept. 2007Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    A standard security which was presented for registration in scotland on 5 june 2003 and
    Créé le 05 mars 2003
    Livré le 26 juin 2003
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    Subjects on the bellshill road uddingston t/n LAN145487.
    Personnes ayant droit
    • Gmac Commercial Finance PLC
    Transactions
    • 26 juin 2003Enregistrement d'une charge (395)
    • 12 oct. 2006Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Debenture
    Créé le 10 avr. 2002
    Livré le 13 avr. 2002
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personnes ayant droit
    • Davenham Trust PLC
    Transactions
    • 13 avr. 2002Enregistrement d'une charge (395)
    • 22 juin 2004Déclaration que tout ou partie de la propriété d'une charge flottante a été libérée (403b)
    • 12 oct. 2006Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Chattel mortgage
    Créé le 20 nov. 2001
    Livré le 23 nov. 2001
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Brudeler type BSTA41 double column high performance punching press with acoustic surround enclosure s/n 5299; atkin sp 150 500 de-coiler with level rolls s/n W5292 (for full detailsof further equipment charged please refer to form 395).
    Personnes ayant droit
    • Davenham Trust PLC
    Transactions
    • 23 nov. 2001Enregistrement d'une charge (395)
    • 12 oct. 2006Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    A standard security which was presented for registration in scotland on 29 august 2001 and
    Créé le 20 août 2001
    Livré le 07 sept. 2001
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Factory premises k/a unit 1, bellshill road, bothwell park industrial estate, uddingston, glasgow extending to approximately 18 acres.
    Personnes ayant droit
    • Gmac Commercial Credit Limited
    Transactions
    • 07 sept. 2001Enregistrement d'une charge (395)
    • 12 oct. 2006Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    A standard security which was presented for registration in scotland on 9 august 2001 and
    Créé le 30 juil. 2001
    Livré le 17 août 2001
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    The contingent consideration due or to become due from the company to the chargee under the terms of an agreement dated 30 july 2001
    Brèves mentions
    All and whole those subjects lying in the parish of bothwell and county of lanark extending to 18 acres.. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Pegler-Hattersley Limited (Together with Their Assignees Called "Thecreditor")
    Transactions
    • 17 août 2001Enregistrement d'une charge (395)
    • 22 févr. 2003Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    A standard security which was presented for registration in scotland on 09 august 2001 and
    Créé le 30 juil. 2001
    Livré le 17 août 2001
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee
    Brèves mentions
    Factory premises k/a unit 1, bellshill road, bothwell park industrial estate, uddingston, glasgow extending to approximately 18 acres.
    Personnes ayant droit
    • Gmac Commercial Credit Limited
    Transactions
    • 17 août 2001Enregistrement d'une charge (395)
    • 12 oct. 2006Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Composite guarantee and debenture
    Créé le 30 juil. 2001
    Livré le 10 août 2001
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All deferred consideration and the contingent consideration (as defined) together with all present and future obligations and liabilities due or to become due from the company, shadegrid limited or croftacre holdings limited to the chargee on any account whatsoever under the terms of the deed
    Brèves mentions
    F/H properety k/a unit 1 bellshill road uddingston glasgow t/no LAN145487AND f/h property at belshill road uddingston glasgow t/no lan 1454487. fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Pegler Hattersley Limited
    Transactions
    • 10 août 2001Enregistrement d'une charge (395)
    • 22 févr. 2003Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Composite guarantee and debenture
    Créé le 30 juil. 2001
    Livré le 01 août 2001
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All obligations and liabilities owing by any obligor or any chargor to the chargee on any account whatsoever and incurred under any finance document or any other document
    Brèves mentions
    Freehold property known as unit 1 belshill road bothwell park industrial estate uddingston glasgow GL71 6NP ttitle number LAN145487 and freehold/leasehold property known as the undeveloped land and factory extension to the rear of unit 1 belshill road bothwell park industrial estate uddingston glasgow GL71 6NP title number LAN145487. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Gmac Commercial Credit Limited
    Transactions
    • 01 août 2001Enregistrement d'une charge (395)
    • 22 juin 2004Déclaration que tout ou partie de la propriété d'une charge flottante a été libérée (403b)
    • 22 juin 2004Déclaration que tout ou partie de la propriété d'une charge flottante a été libérée (403b)
    • 12 oct. 2006Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)

    FENCLOVE CONTROLLERS LIMITED a-t-elle des procédures d'insolvabilité ?

    Numéro de dossierDatesTypePraticiensAutre
    1
    DateType
    04 sept. 2023Conclusion of winding up
    05 févr. 2019Petition date
    27 mars 2019Commencement of winding up
    13 févr. 2024Dissolved on
    Compulsory liquidation
    NomRôleAdresseNommé leCessé le
    Lee Anthony Green
    King Street House
    15 Upper King Street
    NR3 1RB Norwich
    practitioner
    King Street House
    15 Upper King Street
    NR3 1RB Norwich
    The Official Receiver Or Croydon
    11th Floor Southern House
    Wellesley Grove
    CR0 1XN Croydon
    practitioner
    11th Floor Southern House
    Wellesley Grove
    CR0 1XN Croydon

    Source de données

    • Companies House du Royaume-Uni
      Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers.
    • Licence: CC0