MIDWINTER PROPERTY HOLDINGS LIMITED

MIDWINTER PROPERTY HOLDINGS LIMITED

  • Vue d'ensemble
  • Résumé
  • Objet social
  • Adresse
  • Dénominations sociales précédentes
  • Comptes
  • Déclaration de confirmation
  • Dépôts
  • Dirigeants
  • Personnes ayant un contrôle significatif
  • Charges
  • Insolvabilité
  • Source de données
  • Vue d'ensemble

    Nom de la sociétéMIDWINTER PROPERTY HOLDINGS LIMITED
    Statut de la sociétéLiquidation
    Forme juridiqueSociété à responsabilité limitée
    Numéro de société 00786619
    JuridictionAngleterre/Pays de Galles
    Date de création

    Résumé

    A des PSCs super sécurisésNon
    A des chargesOui
    A un historique d'insolvabilitéOui
    Le siège social est contestéNon

    Quel est l'objet de MIDWINTER PROPERTY HOLDINGS LIMITED ?

    • Achat et vente de biens immobiliers propres (68100) / Activités immobilières

    Où se situe MIDWINTER PROPERTY HOLDINGS LIMITED ?

    Adresse du siège social
    6th Floor 2 London Wall Place
    EC2Y 5AU London
    Adresse du siège social non livrableNon

    Quels étaient les noms précédents de MIDWINTER PROPERTY HOLDINGS LIMITED ?

    Dénominations sociales précédentes
    Nom de la sociétéDeJusqu'au
    BUCKS JOINERY HOLDINGS LIMITED17 nov. 198317 nov. 1983
    BUCKS JOINERY LIMITED02 janv. 196402 janv. 1964

    Quels sont les derniers comptes de MIDWINTER PROPERTY HOLDINGS LIMITED ?

    En retardOui
    Prochains comptes
    Fin de la prochaine période comptable le30 sept. 2021
    Date d'échéance des prochains comptes30 juin 2022
    Derniers comptes
    Derniers comptes arrêtés au30 sept. 2020

    Quel est le statut de la dernière déclaration de confirmation pour MIDWINTER PROPERTY HOLDINGS LIMITED ?

    En retardOui
    Dernière déclaration de confirmation établie jusqu'au06 févr. 2022
    Date d'échéance de la prochaine déclaration de confirmation20 févr. 2022
    Dernière déclaration de confirmation
    Prochaine déclaration de confirmation établie jusqu'au06 févr. 2021
    En retardOui

    Quels sont les derniers dépôts pour MIDWINTER PROPERTY HOLDINGS LIMITED ?

    Dépôts
    DateDescriptionDocumentType

    Déclaration des reçus et paiements des liquidateurs jusqu'à 29 févr. 2024

    9 pagesLIQ03

    Déclaration des reçus et paiements des liquidateurs jusqu'à 28 févr. 2023

    10 pagesLIQ03

    Satisfaction de la charge 3 en totalité

    4 pagesMR04

    Satisfaction de la charge 4 en totalité

    4 pagesMR04

    Satisfaction de la charge 16 en totalité

    4 pagesMR04

    Satisfaction de la charge 5 en totalité

    4 pagesMR04

    Satisfaction de la charge 15 en totalité

    4 pagesMR04

    Satisfaction de la charge 2 en totalité

    4 pagesMR04

    Déclaration des reçus et paiements des liquidateurs jusqu'à 28 févr. 2022

    14 pagesLIQ03

    Résolutions

    Resolutions
    1 pagesRESOLUTIONS
    Résolutions
    CatégorieDateDescriptionType
    liquidation

    Résolution spéciale pour la liquidation au 01 mars 2021

    LRESSP

    Nomination d'un liquidateur volontaire

    3 pages600

    Déclaration de solvabilité

    5 pagesLIQ01

    Changement d'adresse du siège social de 48a,Brook Street. Aston Clinton. Aylesbury. HP22 5ES à 6th Floor 2 London Wall Place London EC2Y 5AU le 19 mars 2021

    2 pagesAD01

    Comptes de micro-entité établis au 30 sept. 2020

    6 pagesAA

    Déclaration de confirmation établie le 06 févr. 2021 avec mises à jour

    4 pagesCS01

    Comptes de micro-entité établis au 30 sept. 2019

    6 pagesAA

    Déclaration de confirmation établie le 06 févr. 2020 avec mises à jour

    4 pagesCS01

    Satisfaction de la charge 13 en totalité

    1 pagesMR04

    Satisfaction de la charge 14 en totalité

    2 pagesMR04

    Satisfaction de la charge 12 en totalité

    2 pagesMR04

    Comptes de micro-entité établis au 30 sept. 2018

    6 pagesAA

    Déclaration de confirmation établie le 06 févr. 2019 avec mises à jour

    4 pagesCS01

    Comptes de micro-entité établis au 30 sept. 2017

    6 pagesAA

    Déclaration de confirmation établie le 06 févr. 2018 avec mises à jour

    4 pagesCS01

    Nomination de Mr Andrew Carver en tant que secrétaire le 02 févr. 2018

    2 pagesAP03

    Qui sont les dirigeants de MIDWINTER PROPERTY HOLDINGS LIMITED ?

    Dirigeants
    NomNommé leDate de démissionRôleAdresseIdentification de la sociétéPays de résidenceNationalitéDate de naissanceProfessionNuméro
    CARVER, Andrew
    School Lane
    MK18 1HD Buckingham
    Chandos House
    Buckinghamshire
    United Kingdom
    Secrétaire
    School Lane
    MK18 1HD Buckingham
    Chandos House
    Buckinghamshire
    United Kingdom
    242740410001
    REDHOUSE, Sandra Irene
    School Lane
    MK18 1HD Buckingham
    Chandos House
    Bucks
    United Kingdom
    Administrateur
    School Lane
    MK18 1HD Buckingham
    Chandos House
    Bucks
    United Kingdom
    United KingdomBritishProperty Developer20578350002
    REDHOUSE, Thomas Peter
    School Lane
    MK18 1HD Buckingham
    Chandos House
    Bucks
    United Kingdom
    Administrateur
    School Lane
    MK18 1HD Buckingham
    Chandos House
    Bucks
    United Kingdom
    EnglandBritishDirector125797910002
    WINKELMANN, Alan
    School Lane
    MK18 1HD Buckingham
    Chandos House
    Bucks
    United Kingdom
    Administrateur
    School Lane
    MK18 1HD Buckingham
    Chandos House
    Bucks
    United Kingdom
    United KingdomBritishBuilder95235670001
    CRAGG, David John
    Mulberry Hill
    Shupps Lane Chearsley
    HP18 0DE Aylesbury
    Buckinghamshire
    Secrétaire
    Mulberry Hill
    Shupps Lane Chearsley
    HP18 0DE Aylesbury
    Buckinghamshire
    BritishSolicitor36541810001
    STALKER, John Lawson
    School Lane
    MK18 1HD Buckingham
    Chandos House
    Bucks
    United Kingdom
    Secrétaire
    School Lane
    MK18 1HD Buckingham
    Chandos House
    Bucks
    United Kingdom
    British106089470001
    TEARLE, John George
    23 Castle Street
    MK18 1BP Buckingham
    Buckinghamshire
    Secrétaire
    23 Castle Street
    MK18 1BP Buckingham
    Buckinghamshire
    British20578330003
    CARVER, Andrew
    West Barn, Northfield Barns
    Stratford Road, Deanshanger
    MK19 6HN Milton Keynes
    Buckinghamshire
    Administrateur
    West Barn, Northfield Barns
    Stratford Road, Deanshanger
    MK19 6HN Milton Keynes
    Buckinghamshire
    United KingdomEnglishAccountant107297690001
    CARVER, Andrew
    West Barn, Northfield Barns
    Stratford Road, Deanshanger
    MK19 6HN Milton Keynes
    Buckinghamshire
    Administrateur
    West Barn, Northfield Barns
    Stratford Road, Deanshanger
    MK19 6HN Milton Keynes
    Buckinghamshire
    United KingdomEnglishAccountant107297690001
    CARVER, Andrew
    West Barn, Northfield Barns
    Stratford Road, Deanshanger
    MK19 6HN Milton Keynes
    Buckinghamshire
    Administrateur
    West Barn, Northfield Barns
    Stratford Road, Deanshanger
    MK19 6HN Milton Keynes
    Buckinghamshire
    United KingdomEnglishAccountant107297690001
    MIDWINTER, Ethel
    170 London Road
    Aston Clinton
    HP22 5LB Aylesbury
    Buckinghamshire
    Administrateur
    170 London Road
    Aston Clinton
    HP22 5LB Aylesbury
    Buckinghamshire
    BritishRetired Secretary20578340001

    Qui sont les personnes ayant un contrôle significatif sur MIDWINTER PROPERTY HOLDINGS LIMITED ?

    Personnes ayant un contrôle significatif
    NomNotifié leAdresseCessé
    Mrs Sandra Irene Redhouse
    School Lane
    MK18 1HD Buckingham
    Chandos House
    Buckinghamshire
    United Kingdom
    06 avr. 2016
    School Lane
    MK18 1HD Buckingham
    Chandos House
    Buckinghamshire
    United Kingdom
    Non
    Nationalité: British
    Pays de résidence: England
    Nature du contrôle
    • La personne détient, directement ou indirectement, plus de 50 % mais pas plus de 75 % des actions de la société.
    • La personne détient, directement ou indirectement, plus de 50 % mais pas plus de 75 % des droits de vote dans la société.

    MIDWINTER PROPERTY HOLDINGS LIMITED a-t-elle des charges ?

    Charges
    ClassificationDatesStatutDétails
    Mortgage
    Créé le 21 janv. 2009
    Livré le 23 janv. 2009
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Unit a shiresroad buckinham road industrial estate brackley t/no:NN110824 together with all buildings & fixtures (including trade fixtures). Fixed plant & machinery by way of fixed charge, all present & future book & other debts, floating charge over all moveable plant machinery, implements, utensils, furniture & equipment by way of assignment. The goodwill of the business (if any), the full benefit of all licences & guarantees.
    Personnes ayant droit
    • Lloyds Tsb Bank PLC
    Transactions
    • 23 janv. 2009Enregistrement d'une charge (395)
    • 01 juin 2022Satisfaction d'une charge (MR04)
    Mortgage deed
    Créé le 15 avr. 2005
    Livré le 20 avr. 2005
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Unit a shires road buckingham road industrial estate brackley northants. Together with all buildings and fixtures (including trade fixtures) fixed plant and machinery by way of fixed charge all present and future book and other debts floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment by way of assignment the goodwill of the business (if any) the full benefit of all licences and all guarantees.
    Personnes ayant droit
    • Lloyds Tsb Bank PLC
    Transactions
    • 20 avr. 2005Enregistrement d'une charge (395)
    • 01 juin 2022Satisfaction d'une charge (MR04)
    Mortgage
    Créé le 10 mars 2005
    Livré le 31 mars 2005
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Unit 1 shires road brackley northants t/no NN185461. Together with all buildings and fixtures (including trade fixtures) fixed plant and machinery by way of fixed charge all present and future book and other debts floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment by way of assignment the goodwill of the business (if any) the full benefit of all licences and all guarantees.
    Personnes ayant droit
    • Lloyds Tsb Bank PLC
    Transactions
    • 31 mars 2005Enregistrement d'une charge (395)
    • 16 sept. 2019Satisfaction d'une charge (MR04)
    Debenture
    Créé le 05 mai 2004
    Livré le 07 mai 2004
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personnes ayant droit
    • Lloyds Tsb Bank PLC
    Transactions
    • 07 mai 2004Enregistrement d'une charge (395)
    • 16 sept. 2019Satisfaction d'une charge (MR04)
    Mortgage
    Créé le 13 févr. 2004
    Livré le 25 févr. 2004
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    The f/h property known as or being unit 1, shires road, bracket, northants t/no NN178661. Together with all buildings and fixtures (including trade fixtures) fixed plant and machinery by way of fixed charge all present and future book and other debts floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment by way of assignment the goodwill of the business (if any) the full benefit of all licences and all guarantees.
    Personnes ayant droit
    • Lloyds Tsb Bank PLC
    Transactions
    • 25 févr. 2004Enregistrement d'une charge (395)
    • 16 sept. 2019Satisfaction d'une charge (MR04)
    Legal charge
    Créé le 24 janv. 2000
    Livré le 31 janv. 2000
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Property k/a land on the south east side of shires road brackley and land lying to the east of county road brackley northamptonshire t/n NN178661 and NN185461.
    Personnes ayant droit
    • Barclays Bank PLC
    Transactions
    • 31 janv. 2000Enregistrement d'une charge (395)
    • 28 oct. 2006Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Legal charge
    Créé le 20 janv. 2000
    Livré le 04 févr. 2000
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Land on the south east side of shires road brackley and land lying to the east of county road brackley northamptonshire t/nos: NN178661 and NN185461.
    Personnes ayant droit
    • Barclays Bank PLC
    Transactions
    • 04 févr. 2000Enregistrement d'une charge (395)
    • 28 oct. 2006Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Legal charge
    Créé le 20 sept. 1999
    Livré le 08 oct. 1999
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Unit 1 shire road industrial estate brackley northamptonshire t/n's NN185461 and part NN178661.
    Personnes ayant droit
    • Barclays Bank PLC
    Transactions
    • 08 oct. 1999Enregistrement d'une charge (395)
    • 28 oct. 2006Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Legal charge
    Créé le 20 sept. 1999
    Livré le 08 oct. 1999
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Unit 2 shire road industrial estate brackley northamptonshire t/n NN178661 (part).
    Personnes ayant droit
    • Barclays Bank PLC
    Transactions
    • 08 oct. 1999Enregistrement d'une charge (395)
    • 28 oct. 2006Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Debenture
    Créé le 20 sept. 1999
    Livré le 30 sept. 1999
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personnes ayant droit
    • Barclays Bank PLC
    Transactions
    • 30 sept. 1999Enregistrement d'une charge (395)
    • 28 oct. 2006Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Legal charge
    Créé le 20 sept. 1999
    Livré le 30 sept. 1999
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Barham lodge,tingewick rd,buckingham,buckinghamshire; BM208808.
    Personnes ayant droit
    • Barclays Bank PLC
    Transactions
    • 30 sept. 1999Enregistrement d'une charge (395)
    • 28 oct. 2006Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Mortgage deed
    Créé le 30 avr. 1998
    Livré le 01 mai 1998
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Land at shires rd,brickley,northamptonshire; nn 185461 and nn 178661. together with all buildings and fixtures (including trade fixtures) fixed plant and machinery by way of fixed charge all present and future book and other debts floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment by way of assignment the goodwill of the business (if any) the full benefit of all licences and all guarantees.
    Personnes ayant droit
    • Lloyds Bank PLC
    Transactions
    • 01 mai 1998Enregistrement d'une charge (395)
    • 01 juin 2022Satisfaction d'une charge (MR04)
    Mortgage
    Créé le 28 nov. 1996
    Livré le 07 déc. 1996
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    29 little orchard aylesbury bucks t/n BM163046 together with all buildings fixtures (inclduing trade fixtures) fixed plant and machinery thereon, fixed charge all present and future book and other debts, assigns goodwill of the business (if any). Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Lloyds Bank PLC
    Transactions
    • 07 déc. 1996Enregistrement d'une charge (395)
    • 01 juin 2022Satisfaction d'une charge (MR04)
    Mortgage
    Créé le 28 nov. 1996
    Livré le 07 déc. 1996
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    31 little orchards aylesbury bucks t/n BM170482 together with all buildings fixtures (including trade fixtures) fixed plant and machinery thereon, fixed charge all present and future book and other debts, assigns goodwill of the business (if any). Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Lloyds Bank PLC
    Transactions
    • 07 déc. 1996Enregistrement d'une charge (395)
    • 01 juin 2022Satisfaction d'une charge (MR04)
    Mortgage
    Créé le 18 sept. 1995
    Livré le 07 oct. 1995
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    F/H property k/a barham lodge tingewick road buckingham with all buildings and fixtures thereon and A. floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Personnes ayant droit
    • Lloyds Bank PLC
    Transactions
    • 07 oct. 1995Enregistrement d'une charge (395)
    • 01 juin 2022Satisfaction d'une charge (MR04)
    Charge
    Créé le 03 avr. 1967
    Livré le 11 avr. 1967
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Land fronting college road, aston clinton, bucks conveyance 7-3-66.
    Personnes ayant droit
    • Barclays Bank LTD
    Transactions
    • 11 avr. 1967Enregistrement d'une charge
    • 28 oct. 2006Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)

    MIDWINTER PROPERTY HOLDINGS LIMITED a-t-elle des procédures d'insolvabilité ?

    Numéro de dossierDatesTypePraticiensAutre
    1
    DateType
    01 mars 2021Commencement of winding up
    01 mars 2021Declaration of solvency sworn on
    Members voluntary liquidation
    NomRôleAdresseNommé leCessé le
    Georgina Marie Eason
    Mha Macintyre Hudson Llp 6th Floor, 2 London Wall Place
    EC2Y 5AU London
    practitioner
    Mha Macintyre Hudson Llp 6th Floor, 2 London Wall Place
    EC2Y 5AU London
    Michael Colin John Sanders
    Mha Macintyre Hudson Llp 6th Floor, 2 London Wall Place
    EC2Y 5AU London
    practitioner
    Mha Macintyre Hudson Llp 6th Floor, 2 London Wall Place
    EC2Y 5AU London

    Source de données

    • Companies House du Royaume-Uni
      Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers.
    • Licence: CC0