CHESTERMOUNT PROPERTIES LIMITED

CHESTERMOUNT PROPERTIES LIMITED

  • Vue d'ensemble
  • Résumé
  • Objet social
  • Adresse
  • Comptes
  • Dépôts
  • Dirigeants
  • Charges
  • Source de données
  • Vue d'ensemble

    Nom de la sociétéCHESTERMOUNT PROPERTIES LIMITED
    Statut de la sociétéDissoute
    Forme juridiqueSociété à responsabilité limitée
    Numéro de société 00787210
    JuridictionAngleterre/Pays de Galles
    Date de création
    Date de cessation d'activité

    Résumé

    A des PSCs super sécurisésNon
    A des chargesOui
    A un historique d'insolvabilitéNon
    Le siège social est contestéNon

    Quel est l'objet de CHESTERMOUNT PROPERTIES LIMITED ?

    • (7011) /
    • (7012) /
    • (7020) /

    Où se situe CHESTERMOUNT PROPERTIES LIMITED ?

    Adresse du siège social
    16 Grosvenor Street
    London
    W1K 4QF
    Adresse du siège social non livrableNon

    Quels sont les derniers comptes de CHESTERMOUNT PROPERTIES LIMITED ?

    Derniers comptes
    Derniers comptes arrêtés au31 mars 2009

    Quels sont les derniers dépôts pour CHESTERMOUNT PROPERTIES LIMITED ?

    Dépôts
    DateDescriptionDocumentType

    Bulletin officiel final dissous par radiation volontaire

    1 pagesGAZ2(A)

    Premier avis au Bulletin officiel pour la radiation volontaire

    1 pagesGAZ1(A)

    Déclaration annuelle jusqu'au 14 nov. 2010 avec liste complète des actionnaires

    7 pagesAR01
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    capital07 déc. 2010

    État du capital au 07 déc. 2010

    • Capital: GBP 2
    SH01

    La procédure de radiation volontaire a été suspendue.

    1 pagesSOAS(A)

    Premier avis au Bulletin officiel pour la radiation volontaire

    1 pagesGAZ1(A)

    Demande de radiation de la société du registre du commerce

    3 pagesDS01

    Nomination de David Nicholas Gavaghan en tant qu'administrateur

    3 pagesAP01

    Cessation de la nomination de Tonianne Dwyer en tant que directeur

    2 pagesTM01

    Comptes pour une société dormante établis au 31 mars 2009

    7 pagesAA

    Déclaration annuelle jusqu'au 14 nov. 2009 avec liste complète des actionnaires

    6 pagesAR01

    Comptes établis au 31 mars 2008

    8 pagesAA

    legacy

    4 pages363a

    Comptes annuels établis au 31 mars 2007

    12 pagesAA

    legacy

    3 pages363a

    legacy

    1 pages288b

    Comptes annuels établis au 31 mars 2006

    12 pagesAA

    legacy

    1 pages288a

    legacy

    3 pages363a

    legacy

    1 pages288b

    Comptes annuels établis au 31 mars 2005

    11 pagesAA

    legacy

    8 pages363s

    legacy

    1 pages287

    Comptes annuels établis au 31 mars 2004

    12 pagesAA

    legacy

    8 pages363s

    legacy

    2 pages288a

    Qui sont les dirigeants de CHESTERMOUNT PROPERTIES LIMITED ?

    Dirigeants
    NomNommé leDate de démissionRôleAdresseIdentification de la sociétéPays de résidenceNationalitéDate de naissanceProfessionNuméro
    DIXON, Susan Elizabeth
    Flat 1 29-31 Dingley Place
    EC1 8BR London
    Secrétaire
    Flat 1 29-31 Dingley Place
    EC1 8BR London
    British90007990001
    GAVAGHAN, David Nicholas
    Grosvenor Street
    W1K 4QF London
    16
    Administrateur
    Grosvenor Street
    W1K 4QF London
    16
    United KingdomBritishFund Manager151855940001
    SHATTOCK, Nicholas Simon Keith
    1 Court Lane
    Dulwich
    SE21 7DH London
    Administrateur
    1 Court Lane
    Dulwich
    SE21 7DH London
    EnglandBritishSolicitor43632680001
    WORTHINGTON, Rebecca Jane
    The Old Cottage 97 The High Street
    RG10 8DD Wargrave
    Berkshire
    Administrateur
    The Old Cottage 97 The High Street
    RG10 8DD Wargrave
    Berkshire
    EnglandBritishAccountant130493170001
    WYATT, Adrian Roger
    Broom Manor
    Cottered
    SG9 9QE Buntingford
    Hertfordshire
    Administrateur
    Broom Manor
    Cottered
    SG9 9QE Buntingford
    Hertfordshire
    EnglandBritishCompany Director42858810002
    EASTWOOD, Charlotte Ind
    16 Edna Street
    SW11 3DP London
    Secrétaire
    16 Edna Street
    SW11 3DP London
    British50099790003
    HUGHES, Paul
    Lark Rise
    5 Greville Park Avenue
    KT21 2QS Ashtead
    Surrey
    Secrétaire
    Lark Rise
    5 Greville Park Avenue
    KT21 2QS Ashtead
    Surrey
    BritishChartered Accountant23950030001
    KIERNAN, David Patrick
    7 The Haydens
    TN9 1NS Tonbridge
    Kent
    Secrétaire
    7 The Haydens
    TN9 1NS Tonbridge
    Kent
    Irish11366290003
    LINDSELL, Philip Edmund
    Southside Cottage
    Stone Lane Axford
    SN8 2EY Marlborough
    Wiltshire
    Secrétaire
    Southside Cottage
    Stone Lane Axford
    SN8 2EY Marlborough
    Wiltshire
    BritishCompany Director101775640001
    ROBSON SKEETE, Gail
    22a Woodpecker Copse
    Locks Heath
    SO31 6WS Southampton
    Hampshire
    Secrétaire
    22a Woodpecker Copse
    Locks Heath
    SO31 6WS Southampton
    Hampshire
    British66939460001
    WORTHINGTON, Rebecca Jane
    The Old Cottage 97 The High Street
    RG10 8DD Wargrave
    Berkshire
    Secrétaire
    The Old Cottage 97 The High Street
    RG10 8DD Wargrave
    Berkshire
    British130493170001
    COSSEY, Robert Duncan
    24 Makepeace Avenue
    N6 6EJ London
    Administrateur
    24 Makepeace Avenue
    N6 6EJ London
    BritishChartered Surveyor14907240001
    DUGDALE, Edward Stratford
    Tickwood Hall
    TF13 6NZ Much Wenlock
    Shropshire
    Administrateur
    Tickwood Hall
    TF13 6NZ Much Wenlock
    Shropshire
    EnglandBritishCompany Director35942980003
    DWYER, Tonianne
    170 Bishops Road
    Fulham
    SW6 7JG London
    Administrateur
    170 Bishops Road
    Fulham
    SW6 7JG London
    United KingdomAustralianProperty Fund Manager94124780001
    ELLIS, Nigel George
    Willmead Farm
    Bovey Tracey
    TQ13 9NP Newton Abbot
    Devon
    Administrateur
    Willmead Farm
    Bovey Tracey
    TQ13 9NP Newton Abbot
    Devon
    BritishChartered Accountant14185110002
    GAMBLE, John Stuart
    The Old Lodge Itchingwood Common
    Limpsfield Chart
    Oxted
    Surrey
    Administrateur
    The Old Lodge Itchingwood Common
    Limpsfield Chart
    Oxted
    Surrey
    BritishChartered Surveyor14687500001
    HAMILTON STUBBER, James Robert
    1 The Regency
    Hide Place
    SW1P 4HD London
    Administrateur
    1 The Regency
    Hide Place
    SW1P 4HD London
    United KingdomBritishDirector84913850002
    HENDERSON WILLIAMS, David Andrew
    Glade
    Earleydene
    SL5 9JY Sunninghill
    Berkshire
    Administrateur
    Glade
    Earleydene
    SL5 9JY Sunninghill
    Berkshire
    United KingdomBritishCompany Director117166560001
    KIERNAN, David Patrick
    7 The Haydens
    TN9 1NS Tonbridge
    Kent
    Administrateur
    7 The Haydens
    TN9 1NS Tonbridge
    Kent
    IrishAccountant11366290003
    LINDSELL, Philip Edmund
    Southside Cottage
    Stone Lane Axford
    SN8 2EY Marlborough
    Wiltshire
    Administrateur
    Southside Cottage
    Stone Lane Axford
    SN8 2EY Marlborough
    Wiltshire
    BritishCompany Director101775640001
    MAXTED, Robert David
    14 Wandon Road
    SW6 2JF London
    Administrateur
    14 Wandon Road
    SW6 2JF London
    BritishChartered Surveyor50790720001
    RILEY, Michael Edward
    Tylers Barn
    Tylers Green Broad Street
    RH17 5DX Cuckfield
    West Sussex
    Administrateur
    Tylers Barn
    Tylers Green Broad Street
    RH17 5DX Cuckfield
    West Sussex
    BritishChartered Surveyor94724020002
    WINGATE, Roger Christopher
    Residence Port Blanc
    Place De Trainant, 2
    1223 Cologny
    Switzerland
    Administrateur
    Residence Port Blanc
    Place De Trainant, 2
    1223 Cologny
    Switzerland
    SwitzerlandBritishChartered Surveyor112630420001

    CHESTERMOUNT PROPERTIES LIMITED a-t-elle des charges ?

    Charges
    ClassificationDatesStatutDétails
    Standard security which was presented for registration in scotland on the 23RD december 1997
    Créé le 22 déc. 1997
    Livré le 06 janv. 1998
    En cours
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    All and whole a one-half pro indiviso share in the subjects known generally as the forge at parkhead, parkhead glasgow which comprise subjects on the west side of duke street glasgow and on the north side of gallowgate being part of the former site of parkhead forge and six ewing place glasgow t/no.GLA18802 and subjects lying to the north of gallowgate glasgow t/no.GLA49868. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transactions
    • 06 janv. 1998Enregistrement d'une charge (395)
    Legal charge
    Créé le 08 avr. 1991
    Livré le 25 avr. 1991
    En cours
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of a facility letter dated 21.12.88
    Brèves mentions
    F/H 126/137 houndsditch london t/no ln 28994.
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transactions
    • 25 avr. 1991Enregistrement d'une charge
    Deed of assignment
    Créé le 24 févr. 1989
    Livré le 04 mars 1989
    En cours
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of a facility letter dated 21.12.88. and a charge of even date and/or this assignment.
    Brèves mentions
    All the right title and interest of the company into and under a building contract dated 16.6.88 etc. property k/a five acre square 126/137 houndsditch, london. EC3. (Please see form M395 m 219C).
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transactions
    • 04 mars 1989Enregistrement d'une charge
    Charge
    Créé le 24 févr. 1989
    Livré le 04 mars 1989
    En cours
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of a facility letter dated 21.12.88.
    Brèves mentions
    All the right title and interest of the company in to and under a building agreement dated 31.7.87 etc. property k/a five acre square 126/137 houndsditch, london. EC3. (Please see form M395 M220C).
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transactions
    • 04 mars 1989Enregistrement d'une charge
    Debenture
    Créé le 24 févr. 1989
    Livré le 04 mars 1989
    En cours
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transactions
    • 04 mars 1989Enregistrement d'une charge

    Source de données

    • Companies House du Royaume-Uni
      Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers.
    • Licence: CC0