ALBEMARLE MARKETING RESEARCH LIMITED
Vue d'ensemble
| Nom de la société | ALBEMARLE MARKETING RESEARCH LIMITED |
|---|---|
| Statut de la société | Dissoute |
| Forme juridique | Société à responsabilité limitée |
| Numéro de société | 00787507 |
| Juridiction | Angleterre/Pays de Galles |
| Date de création | |
| Date de cessation d'activité |
Résumé
| A des PSCs super sécurisés | Non |
|---|---|
| A des charges | Oui |
| A un historique d'insolvabilité | Non |
| Le siège social est contesté | Non |
Où se situe ALBEMARLE MARKETING RESEARCH LIMITED ?
| Adresse du siège social | Pembroke Building Avonmore Road W14 8DG London |
|---|---|
| Adresse du siège social non livrable | Non |
Quels sont les derniers comptes de ALBEMARLE MARKETING RESEARCH LIMITED ?
| Derniers comptes | |
|---|---|
| Derniers comptes arrêtés au | 31 déc. 2016 |
Quels sont les derniers dépôts pour ALBEMARLE MARKETING RESEARCH LIMITED ?
| Date | Description | Document | Type | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bulletin officiel final dissous par radiation volontaire | 1 pages | GAZ2(A) | ||||||||||
Premier avis au Bulletin officiel pour la radiation volontaire | 1 pages | GAZ1(A) | ||||||||||
Demande de radiation de la société du registre du commerce | 3 pages | DS01 | ||||||||||
Comptes annuels établis au 31 déc. 2016 | 21 pages | AA | ||||||||||
Nomination de Ms Nicola Raj en tant que secrétaire le 07 juin 2017 | 2 pages | AP03 | ||||||||||
Nomination de Mr Magnus Djaba Djaba en tant qu'administrateur le 31 mars 2017 | 2 pages | AP01 | ||||||||||
Cessation de la nomination de Richard James Hytner en tant que directeur le 31 mars 2017 | 1 pages | TM01 | ||||||||||
Nomination de Mr Justin Kenneth Billingsley en tant qu'administrateur le 31 mars 2017 | 2 pages | AP01 | ||||||||||
Nomination de Ms Sophie Marie Cassandre Martin-Chantepie en tant qu'administrateur le 31 mars 2017 | 2 pages | AP01 | ||||||||||
Cessation de la nomination de Alex Bekkerman en tant que directeur le 31 mars 2017 | 1 pages | TM01 | ||||||||||
Cessation de la nomination de Robert Senior en tant que directeur le 31 mars 2017 | 1 pages | TM01 | ||||||||||
Déclaration de confirmation établie le 27 mars 2017 avec mises à jour | 5 pages | CS01 | ||||||||||
Cessation de la nomination de Raj Basran en tant que secrétaire le 18 janv. 2017 | 1 pages | TM02 | ||||||||||
Comptes annuels établis au 31 déc. 2015 | 21 pages | AA | ||||||||||
Déclaration annuelle jusqu'au 27 mars 2016 avec liste complète des actionnaires | 6 pages | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Nomination de Mr Richard James Hytner en tant qu'administrateur le 19 nov. 2015 | 2 pages | AP01 | ||||||||||
Cessation de la nomination de Annabelle Jane Spooner en tant que directeur le 19 sept. 2015 | 1 pages | TM01 | ||||||||||
Cessation de la nomination de Alan Harker en tant que directeur le 03 juil. 2015 | 1 pages | TM01 | ||||||||||
Comptes annuels établis au 31 déc. 2014 | 19 pages | AA | ||||||||||
Nomination de Mr Alex Bekkerman en tant qu'administrateur le 26 juin 2015 | 2 pages | AP01 | ||||||||||
Nomination de Miss Joanne Munis en tant que secrétaire le 07 avr. 2015 | 2 pages | AP03 | ||||||||||
Cessation de la nomination de Sarah Anne Bailey en tant que secrétaire le 02 avr. 2015 | 1 pages | TM02 | ||||||||||
Déclaration annuelle jusqu'au 27 mars 2015 avec liste complète des actionnaires | 6 pages | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Changement d'adresse du siège social de Pembroke Building Avonmore Road London W14 8DG à Pembroke Building Avonmore Road London W14 8DG le 08 avr. 2015 | 1 pages | AD01 | ||||||||||
Comptes annuels établis au 31 déc. 2013 | 19 pages | AA | ||||||||||
Qui sont les dirigeants de ALBEMARLE MARKETING RESEARCH LIMITED ?
| Nom | Nommé le | Date de démission | Rôle | Adresse | Identification de la société | Pays de résidence | Nationalité | Date de naissance | Profession | Numéro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MUNIS, Joanne | Secrétaire | Building Avonmore Road W14 8DG London Pembroke | 196628860001 | |||||||
| RAJ, Nicola | Secrétaire | Kensington Village Avonmore Road W14 8DG London Pembroke Building United Kingdom | 233357770001 | |||||||
| BILLINGSLEY, Justin Kenneth | Administrateur | Building Avonmore Road W14 8DG London Pembroke | England | Australian | 228671340001 | |||||
| DJABA, Magnus Djaba | Administrateur | Building Avonmore Road W14 8DG London Pembroke | England | British | 174454590001 | |||||
| MARTIN-CHANTEPIE, Sophie Marie Cassandre | Administrateur | Building Avonmore Road W14 8DG London Pembroke | France | French | 228671040001 | |||||
| BAILEY, Sarah Anne | Secrétaire | Building Avonmore Road W14 8DG London Pembroke England | 185048620001 | |||||||
| BASRAN, Raj | Secrétaire | Building Avonmore Road W14 8DG London Pembroke England | 169960300001 | |||||||
| DAVIS, Robert | Secrétaire | Kensington Village Avonmore Road W14 8DG London Pembroke Building | British | 155457840001 | ||||||
| EARL, Elizabeth Louise Kiernan | Secrétaire | 9 Helena Road SL4 1JN Windsor Berkshire | British | 105197540001 | ||||||
| EVANS, Fiona Maria | Secrétaire | 85 Ravensmede Way Chiswick W4 1TQ London | British | 49259690002 | ||||||
| EWING, Susanna | Secrétaire | 72f Sinclair Road W14 0NJ London | British | 122102410001 | ||||||
| GONZALEZ-GOMEZ, Minna Katariina | Secrétaire | Kensington Village Avonmore Road W14 8DG London Pembroke Building England | Finnish | 119965730001 | ||||||
| JANS, Annamaria | Secrétaire | 20 Underhill Road East Dulwich SE22 0AH London | British | 1085040008 | ||||||
| KURTZ, Catherine Elizabeth Strathmore | Secrétaire | 6 Berkeley Road TN1 1YR Tunbridge Wells Kent | British | 54236170003 | ||||||
| WALLS ECKLEY, Gillian | Secrétaire | Avonmore Road W14 8DG London Pembroke Building England | 160040580001 | |||||||
| WEATHERSEED, David Ian Cameron | Secrétaire | The Larches 22 Claremont Road KT10 0PL Claygate Surrey | British | 37857730001 | ||||||
| WYLLIE, Alison | Secrétaire | Flat 2 186 Ladbroke Grove W10 5LZ London | British | 107811220001 | ||||||
| BEKKERMAN, Alex | Administrateur | Building Avonmore Road W14 8DG London Pembroke | England | American | 198886380001 | |||||
| CHAPMAN, Aidan Gerard | Administrateur | 74 Marshalswick Lane AL1 4XE St Albans Hertfordshire | United Kingdom | British | 51799970001 | |||||
| COURET, Philippe Francois Pierre | Administrateur | Flat 9 1 Prince Of Wales Terrace W8 5PG London | French | 68861790003 | ||||||
| EVANS, Fiona Maria | Administrateur | 85 Ravensmede Way Chiswick W4 1TQ London | British | 49259690002 | ||||||
| GRAHAM, Alec | Administrateur | Linden Lea, Packhorse Road Bessels Green TN13 2QP Sevenoaks Kent | British | 73621260001 | ||||||
| HARKER, Alan | Administrateur | Building Avonmore Road W14 8DG London Pembroke England | England | British | 174823410001 | |||||
| HYTNER, Richard James | Administrateur | Building Avonmore Road W14 8DG London Pembroke | United Kingdom | British | 49370650001 | |||||
| LOWE, Richard | Administrateur | 3 Dukes Avenue N10 2PS London | British | 26494230001 | ||||||
| LUCAS, Martin George | Administrateur | 12 Stavordale Road N5 1NE London | England | British | 61451430002 | |||||
| RANFORD, Paul Frederick | Administrateur | Bacombe Beeches 89 Ellesborough Road Wendover HP22 6ES Aylesbury Buckinghamshire | United Kingdom | British | 35512360002 | |||||
| REBELO, Michael | Administrateur | Charlotte Street W1A 1AQ London 80 England | England | Australian | 133812720001 | |||||
| SENIOR, Robert William | Administrateur | Building Avonmore Road W14 8DG London Pembroke England | England | British | 178019870001 | |||||
| SPOONER, Annabelle Jane | Administrateur | Building Avonmore Road W14 8DG London Pembroke England | England | British | 127871790001 | |||||
| SPOONER, Annabelle Jane | Administrateur | 14 Vanbrugh Hill Blackheath SE3 7UF London | British | 26494240001 | ||||||
| WATSON, Robert Drummond | Administrateur | 2 Whybourne Crest TN2 5BS Tunbridge Wells Kent | British | 11918650001 | ||||||
| WEATHERSEED, David Ian Cameron | Administrateur | The Larches 22 Claremont Road KT10 0PL Claygate Surrey | British | 37857730001 | ||||||
| XAVIER, Johann | Administrateur | Charlotte Street W1A 1AQ London 80 United Kingdom | England | Canadian | 115106400004 |
Qui sont les personnes ayant un contrôle significatif sur ALBEMARLE MARKETING RESEARCH LIMITED ?
| Nom | Notifié le | Adresse | Cessé | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mms Uk Holdings Limited | 06 avr. 2016 | Avonmore Road W14 8DG London Pembroke Building England | Non | ||||||||||
| |||||||||||||
Nature du contrôle
| |||||||||||||
ALBEMARLE MARKETING RESEARCH LIMITED a-t-elle des charges ?
| Classification | Dates | Statut | Détails | |
|---|---|---|---|---|
| Debenture | Créé le 15 déc. 1997 Livré le 24 déc. 1997 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from the company to the chargee under or pursuant to the agreement dated 30TH september 1997 (as defined) and/or the security documents (as defined) when the same become due for payment or discharge | |
Brèves mentions By way of first legal mortgage the property (if any); by way of first fixed charge all present and future f/h and l/h property wheresoever situate; all plant machinery and other equipment; all book and other debts; the goodwill and uncalled capital; by way of first floating charge its undertaking and all its property assets and rights whatsoever and wheresoever both present and future.. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
Source de données
- Companies House du Royaume-Uni
Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers. - Licence: CC0