COUNTY & SUBURBAN INVESTMENTS LIMITED

COUNTY & SUBURBAN INVESTMENTS LIMITED

  • Vue d'ensemble
  • Résumé
  • Objet social
  • Adresse
  • Dénominations sociales précédentes
  • Comptes
  • Dépôts
  • Dirigeants
  • Charges
  • Source de données
  • Vue d'ensemble

    Nom de la sociétéCOUNTY & SUBURBAN INVESTMENTS LIMITED
    Statut de la sociétéDissoute
    Forme juridiqueSociété à responsabilité limitée
    Numéro de société 00787950
    JuridictionAngleterre/Pays de Galles
    Date de création
    Date de cessation d'activité

    Résumé

    A des PSCs super sécurisésNon
    A des chargesOui
    A un historique d'insolvabilitéNon
    Le siège social est contestéNon

    Quel est l'objet de COUNTY & SUBURBAN INVESTMENTS LIMITED ?

    • (7499) /

    Où se situe COUNTY & SUBURBAN INVESTMENTS LIMITED ?

    Adresse du siège social
    5 Wigmore Street
    W1U 1PB London
    United Kingdom
    Adresse du siège social non livrableNon

    Quels étaient les noms précédents de COUNTY & SUBURBAN INVESTMENTS LIMITED ?

    Dénominations sociales précédentes
    Nom de la sociétéDeJusqu'au
    TOWNLINE PROPERTIES LIMITED14 janv. 196414 janv. 1964

    Quels sont les derniers comptes de COUNTY & SUBURBAN INVESTMENTS LIMITED ?

    Derniers comptes
    Derniers comptes arrêtés au31 mars 2011

    Quels sont les derniers dépôts pour COUNTY & SUBURBAN INVESTMENTS LIMITED ?

    Dépôts
    DateDescriptionDocumentType

    Bulletin officiel final dissous par radiation d'office

    1 pagesGAZ2

    Premier avis au Bulletin officiel pour la radiation d'office

    1 pagesGAZ1

    Comptes pour une société dormante établis au 31 mars 2011

    8 pagesAA
    A0OR2H8Y

    Déclaration annuelle jusqu'au 09 juil. 2011 avec liste complète des actionnaires

    6 pagesAR01
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    capital30 août 2011

    État du capital au 30 août 2011

    • Capital: GBP 100
    SH01
    XLQXMX4S

    Comptes pour une société dormante établis au 31 mars 2010

    5 pagesAA
    L8WXYSO0

    Période comptable précédente raccourcie du 31 mars 2010 au 30 mars 2010

    3 pagesAA01
    LDOAZQ6R

    Déclaration annuelle jusqu'au 09 juil. 2010 avec liste complète des actionnaires

    6 pagesAR01
    XWPWNMH4

    Modification des coordonnées de l'administrateur Christopher George White le 01 mai 2010

    3 pagesCH01
    A1G19JTD

    Modification des coordonnées de l'administrateur Mr Maurice Moses Benady le 01 mai 2010

    3 pagesCH01
    A1GWCJTB

    Comptes pour une société dormante établis au 31 mars 2009

    5 pagesAA
    LTR8XH2T

    legacy

    4 pages363a
    X70S2CR1

    legacy

    1 pages190
    X70S1CR0

    legacy

    1 pages353
    X70S0CRZ

    legacy

    1 pages287
    X70RZCRX

    legacy

    1 pages287
    AZVSL7C0

    Comptes établis au 31 mars 2008

    5 pagesAA
    LAS4H6YC

    Résolutions

    Resolutions
    1 pagesRESOLUTIONS
    Résolutions
    CatégorieDateDescriptionType
    capital

    Résolutions

    Section 175 in relation to trafalgar officers LIMITED 10/10/2008
    RES13

    Résolutions

    Resolutions
    1 pagesRESOLUTIONS
    Résolutions
    CatégorieDateDescriptionType
    capital

    Résolutions

    Section 175 in relation to chris white 10/10/2008
    RES13

    Résolutions

    Resolutions
    1 pagesRESOLUTIONS
    Résolutions
    CatégorieDateDescriptionType
    capital

    Résolutions

    Section 175 in relation to mo benady 10/10/2008
    RES13

    Résolutions

    Resolutions
    4 pagesRESOLUTIONS
    Résolutions
    CatégorieDateDescriptionType
    capital

    Résolutions

    Section 175 10/10/2008
    RES13
    incorporation

    Résolution de modification des statuts

    RES01

    legacy

    1 pages288b
    AU45I601

    legacy

    2 pages288a
    AU45060J

    legacy

    4 pages288a
    AU45160K

    legacy

    4 pages288a
    AU44U60C

    legacy

    3 pages363a
    XCCST5OZ

    Qui sont les dirigeants de COUNTY & SUBURBAN INVESTMENTS LIMITED ?

    Dirigeants
    NomNommé leDate de démissionRôleAdresseIdentification de la sociétéPays de résidenceNationalitéDate de naissanceProfessionNuméro
    REIT (CORPORATE SERVICES) LIMITED
    5 Wigmore Street
    W1U 1PB London
    Secrétaire
    5 Wigmore Street
    W1U 1PB London
    79571870001
    BENADY, Maurice Moses
    57/63 Line Wall Road
    Gibraltar
    Administrateur
    57/63 Line Wall Road
    Gibraltar
    GibraltarBritishSolicitor69435160001
    WHITE, Christopher George
    Line Wall Road
    Gibraltar
    57/63
    Gibraltar
    Administrateur
    Line Wall Road
    Gibraltar
    57/63
    Gibraltar
    GibraltarBritishBarrister-At-Law80132540006
    TRAFALGAR OFFICERS LIMITED
    Wigmore Street
    W1U 1PB London
    3rd Floor 5
    Administrateur
    Wigmore Street
    W1U 1PB London
    3rd Floor 5
    135408170001
    HOLLAND, Philip John
    9 Royle Close
    Chalfont St. Peter
    SL9 0BA Buckinghamshire
    Secrétaire
    9 Royle Close
    Chalfont St. Peter
    SL9 0BA Buckinghamshire
    BritishChief Acc74688330002
    ROBERTS, Geoffrey Michael
    Brenchley 8 Hamilton Road
    DA15 7HB Sidcup
    Kent
    Secrétaire
    Brenchley 8 Hamilton Road
    DA15 7HB Sidcup
    Kent
    British29217560001
    WHITE, Christine
    31 Denmark Street
    WD17 4YA Watford
    Hertfordshire
    Secrétaire
    31 Denmark Street
    WD17 4YA Watford
    Hertfordshire
    British74900200002
    BLOOMFIELD, David William
    Hillcroft
    The Drive Harefield Place
    UB10 8AQ Ickenham
    Middlesex
    Administrateur
    Hillcroft
    The Drive Harefield Place
    UB10 8AQ Ickenham
    Middlesex
    BritishCompany Director7927670001
    CLEGG, Barry Stuart
    The Gate House
    18a Ducks Hill Road
    HA6 2NR Northwood
    Middlesex
    Administrateur
    The Gate House
    18a Ducks Hill Road
    HA6 2NR Northwood
    Middlesex
    United KingdomBritishCompany Director11296610002
    CULL, David Geoffrey Maurice
    8 Centennial Court
    High Street
    WD3 1AW Rickmansworth
    Hertfordshire
    Administrateur
    8 Centennial Court
    High Street
    WD3 1AW Rickmansworth
    Hertfordshire
    BritishCompany Director84076630001
    DOSSETT, Roger John
    Charlecote
    Harewood Road
    HP8 4UA Chalfont St Giles
    Buckinghamshire
    Administrateur
    Charlecote
    Harewood Road
    HP8 4UA Chalfont St Giles
    Buckinghamshire
    EnglandBritishCompany Director116927100001
    HOLLAND, Philip John
    61 Badgers Gate
    LU6 2BF Dunstable
    Bedfordshire
    Administrateur
    61 Badgers Gate
    LU6 2BF Dunstable
    Bedfordshire
    EnglandBritishChief Accountant163838050001
    LONGMAN, Karen Sarah
    14b Alexandra Mansions
    West End Lane
    NW6 1LU London
    Administrateur
    14b Alexandra Mansions
    West End Lane
    NW6 1LU London
    BritishCompany Director29163610001
    MALONE, Kenneth Daniel
    One Tree Cottage 18 Woodside Avenue
    HP9 1JJ Beaconsfield
    Buckinghamshire
    Administrateur
    One Tree Cottage 18 Woodside Avenue
    HP9 1JJ Beaconsfield
    Buckinghamshire
    BritishChartered Surveyor60687110001
    REIT(CORPORATE DIRECTORS) LIMITED
    5 Wigmore Street
    W1U 1PB London
    Administrateur
    5 Wigmore Street
    W1U 1PB London
    74030120002

    COUNTY & SUBURBAN INVESTMENTS LIMITED a-t-elle des charges ?

    Charges
    ClassificationDatesStatutDétails
    Debenture
    Créé le 15 sept. 2004
    Livré le 29 sept. 2004
    En cours
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the chargor to any finance party on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    By way of fixed charge the real property other than the real property listed in part ii of schedule 2 of the debenture; all plant and machinery etc. and all related property rights; all debts; all of its securities and intellectual property rights; all goodwill and uncalled capital; and the insurance policies and the insurance proceeds. By way of assignment the insurance policies and the insurance proceeds; all rental income; any guarantee of rental income contained in or relating to any lease document; any hedging arrangements; each managing agent agreement; and each building contract and all related property rights. By way of first floating charge (I) the whole of its assets present and future and (ii) the whole of its assets situated in scotland.. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Hypo Real Estate Bank International (The "Security Trustee")
    Transactions
    • 29 sept. 2004Enregistrement d'une charge (395)
    Supplemental debenture
    Créé le 24 août 1998
    Acquis le 03 juin 1999
    Livré le 12 juin 1999
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    16,18 and 20 bridge street leatherhead with t/no's;-SY336363 SY485260 and SY357147 SY446734.
    Personnes ayant droit
    • National Westminster Bank PLC
    Transactions
    • 12 juin 1999Enregistrement d'une acquisition (400)
    • 10 mai 2004Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Supplemental debenture
    Créé le 24 août 1998
    Livré le 25 août 1998
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee as security trustee for the secured parties (as defined in the composite guarantee and mortgage debenture), the payment and discharge of which are the subject of covenants, undertakings, guarnatees, and agreements contained in the composite guarantee and mortgage debenture and the supplemental debenture
    Brèves mentions
    F/H barton place 163 to 169 new road croxley green hertfordshire t/n-HD218886 and all that f/h land k/a stocks house north street leatherhead t/n-SY494073 together with the proceeds of sale of the same together with any property and land already charged to the security trustee by way of legal mortgage by the company.
    Personnes ayant droit
    • National Westminster Bank PLC
    Transactions
    • 25 août 1998Enregistrement d'une charge (395)
    • 10 mai 2004Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Legal charge
    Créé le 01 oct. 1993
    Livré le 06 oct. 1993
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company and/or county & suburban holdings limited to the chargee under the terms of the debenture dated 4TH august 1992 and this deed
    Brèves mentions
    F/H land on the west side of spencer road and no'S.108-118 (Even) walton road east molesey surrey and the proceeds of sale thereof all buildings trade and other fixtures on any such property belonging to csi. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • National Westminster Bank PLC
    Transactions
    • 06 oct. 1993Enregistrement d'une charge (395)
    • 14 déc. 1996Déclaration que tout ou partie de la propriété d'une charge flottante a été libérée (403b)
    • 10 mai 2004Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Fourth supplemental trust deed
    Créé le 15 sept. 1993
    Livré le 24 sept. 1993
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    £3,000,000 12.4% first mortgage debenture stock 2008 and the £18,000,000 11.25% first mortgage debenture stock 2018 of estates & general PLC and all other moneys intended to be secured by the above deed and the existing deeds (as defined)
    Brèves mentions
    See form 395. undertaking and all property and assets present and future including uncalled capital.
    Personnes ayant droit
    • Guardian Royal Exchange Assurance PLC
    Transactions
    • 24 sept. 1993Enregistrement d'une charge (395)
    • 14 déc. 1996Déclaration que tout ou partie de la propriété d'une charge flottante a été libérée (403b)
    • 10 mai 2004Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Deed of assurance
    Créé le 10 août 1993
    Livré le 25 août 1993
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    Principal and interest on the £3,000,000 12.4% first mortgage debenture stock 2008 and the £18,000,000 11.25% first mortgage debenture stock 2018 of estates and general PLC and all other monies intended to be secured by the above deed and the existing deeds (as defined) to which it is supplemental
    Brèves mentions
    L/H property k/a 101/118 walton road east molesey surrey. Together with fixed and moveable plant machinery fixtures implements and utensils.
    Personnes ayant droit
    • Guardian Royal Exchange Assurance PLC
    Transactions
    • 25 août 1993Enregistrement d'une charge (395)
    • 14 déc. 1996Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Legal charge
    Créé le 12 août 1992
    Livré le 24 août 1992
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Leasehold property known as land on the west side of spencer road and numbers 108-118 (even numbers) walton road,east molesey,surrey title number SY374236 and SY382600.
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transactions
    • 24 août 1992Enregistrement d'une charge (395)
    • 21 août 1993Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Legal charge
    Créé le 12 août 1992
    Livré le 24 août 1992
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Freehold property known as barton place, 163-169 new road, croxley green, hertfordshire title number HD218886.
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transactions
    • 24 août 1992Enregistrement d'une charge (395)
    • 06 févr. 1997Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Composite guarantee and mortgage debenture
    Créé le 04 août 1992
    Livré le 19 août 1992
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All moneys due or to become due from the company to the chargee as security trustee for itself and the secured parties (all as defined therein) and to the secured parties on any account whatsoever under the terms of this deed
    Brèves mentions
    Please see doc M16 for details. A specific equitable charge over all freehold and leasehold properties and/or the proceeds of sale thereof fixed and floating charges over undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts and the benefits of any licences.
    Personnes ayant droit
    • National Westminster Bank PLC as Security Trustee for Itself and the Banks
    Transactions
    • 19 août 1992Enregistrement d'une charge (395)
    • 10 mai 2004Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Equitable mortgage
    Créé le 02 juil. 1992
    Livré le 06 juil. 1992
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All moneys due or to become due from estates & general PLC on any account whatsoever
    Brèves mentions
    L/H property k/a 108/118 (even nos) walton road east moseley elbridge surrey title no SY382600.
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transactions
    • 06 juil. 1992Enregistrement d'une charge (395)
    • 21 août 1993Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Equitable mortgage
    Créé le 02 juil. 1992
    Livré le 06 juil. 1992
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All moneys due or to become due from estates & general PLC to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    F/H property k/a barton place 163/169 new road croxley green three rivers hertfordshire title no HD218886.
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transactions
    • 06 juil. 1992Enregistrement d'une charge (395)
    • 10 juin 1995Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Equitable charge
    Créé le 17 janv. 1991
    Livré le 25 janv. 1991
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due ftom estate general PLC to the chargee on any accout whatsoever and from the company under the terms of the charge.
    Brèves mentions
    Penn court, station road, west moors, dorset.
    Personnes ayant droit
    • Midland Bank PLC
    Transactions
    • 25 janv. 1991Enregistrement d'une charge
    • 10 juin 1995Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Mortgage
    Créé le 31 déc. 1990
    Livré le 07 janv. 1991
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    By way of legal mortgage f/h property k/a beckley house lower road chorleywood herts t/no.HD190157 together with all bldgs. And fixtures thereon and assignment of goodwill. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Personnes ayant droit
    • Lloyds Bank PLC
    Transactions
    • 07 janv. 1991Enregistrement d'une charge (395)
    • 06 févr. 1997Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Mem of deposit
    Créé le 11 janv. 1990
    Livré le 22 janv. 1990
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from estates and general investments PLC to the chargee on any account whatsoever.
    Brèves mentions
    65/81 the street ashstead surrey title N3 sy 407346.
    Personnes ayant droit
    • National Westminster Bank PLC
    Transactions
    • 22 janv. 1990Enregistrement d'une charge
    • 10 juin 1995Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Equitable charge
    Créé le 17 sept. 1987
    Livré le 30 sept. 1987
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from estates and general investments PLC to the chargee on any account whatsoever.
    Brèves mentions
    F/H property barton place croxley green f/h 108/118 walton rd east molsey, f/h mample court 94 high st horsell f/h 64/70 high st, portishead.
    Personnes ayant droit
    • Bank of Scotland.
    Transactions
    • 30 sept. 1987Enregistrement d'une charge
    • 21 août 1993Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Third supplemental trust deed
    Créé le 28 avr. 1987
    Livré le 08 mai 1987
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    £7,500,000 11.25% first mortgage debenture stock 2018 of estates and general investments PLC & all other monies intended to be secured as defined in the principal trust deed dated 21/12/83 & deeds supplemental thereto
    Brèves mentions
    F/H property on N.W.side of the street, ashhead, surrey (t/n: sy 407345) f/h property k/a stocks house, 9 north street, leatherhead, surrey (t/n: sy 494073) etc together with all buildings erections, fixtures & fittings etc (see doc M147/8 may/ln for full details of the various properties).
    Personnes ayant droit
    • Guarian Royal Exchange Assurance PLC
    Transactions
    • 08 mai 1987Enregistrement d'une charge
    • 16 juil. 1998Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Deed of assurance
    Créé le 27 avr. 1987
    Livré le 08 mai 1987
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    For securing the outstanding £3,000,000 12.4 per cent first mortgage debenture stock 2008 & £10,500,000 11.25 per cent first mortgage stock 2018 of estates and general investments PLC & all other moneys intended to be secured by the deed & deeds defined to which it si supplemental
    Brèves mentions
    First legal mortgage of f/h property 17/23 high street, ruslip, l/b of hillingdon (title no. Mx 455773) together with all bldgs, erections, fixtures & fittings etc. (see doc M141/8 may/ln).
    Personnes ayant droit
    • Guardian Royal Exchange Assurance PLC
    Transactions
    • 08 mai 1987Enregistrement d'une charge
    • 10 juin 1995Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Supplemental charge
    Créé le 06 oct. 1986
    Livré le 07 oct. 1986
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from estates and general investments PLC or any associated company or guarantee to the chargee on any account whatsoever.
    Brèves mentions
    F/H property, k/a biddles printing works martyr road guildford surrey. And the proceeds of sale thereof. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Personnes ayant droit
    • United Dominions Trust Limited
    Transactions
    • 07 oct. 1986Enregistrement d'une charge
    • 10 mai 2004Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Second supplemental trust deed
    Créé le 14 mai 1986
    Livré le 15 mai 1986
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    £5,500,000 11.25% first mortgage debnture stock 2018 of estates and general investments P.L.C. and all other moneys intended to be secured by the said trust deed, the principal deed dated 21.12.83 and deeds supplemental thereto.
    Brèves mentions
    Various f/h properties in surrey, london and hertfordshire with all buildings fixtures, fittings, fixed plant and machinery (see doc M60 for full details).
    Personnes ayant droit
    • Guardian Royal Exchange Assurance PLC.
    Transactions
    • 15 mai 1986Enregistrement d'une charge
    • 10 juin 1995Déclaration que tout ou partie de la propriété d'une charge flottante a été libérée (403b)
    • 10 juin 1995Déclaration que tout ou partie de la propriété d'une charge flottante a été libérée (403b)
    • 10 mai 2004Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Mortgage
    Créé le 31 déc. 1985
    Livré le 06 janv. 1986
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from estates general investments PLC. To the chargee on any account whatsoever.
    Brèves mentions
    F/H land k/a 94, high street horsell surrey title no sy 89337 f/h land k/a 17-23 high street ruislip L.B. of hillingdon mx 455773 f/h land k/a biddles printing worcs martyr road, guildford, surrey title no. Sy 387124.
    Personnes ayant droit
    • United Dominions Trust Limited
    Transactions
    • 06 janv. 1986Enregistrement d'une charge
    • 10 juin 1995Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Supplemental interest deed
    Créé le 10 sept. 1985
    Livré le 13 sept. 1985
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    Securing £5,000,000 11.25% first mortgage debenture stock 2018 of estates and general investments P.L.C. and all other monies secured by a trust deed dated 21ST december 1983 and deeds supplemental thereto.
    Brèves mentions
    F/Hold property on north west side of the street ashtead surrey. Sy 407345. f/hold property k/as stocks house, 9 north street leatherhead surrey sy 494073 f/hold property k/as 22A bridge street, leatherhead surrey. Sy 318160 k/hold property k/as 6,8, and 10 west rd tottenham hadingay london ngl 357592. together in each case with all buildings and erections and fixtures and fittings and fixed plant and machinery for the time being thereon.
    Personnes ayant droit
    • Guardian Royal Exchange Assurance PLC.
    Transactions
    • 13 sept. 1985Enregistrement d'une charge
    • 10 juin 1995Déclaration que tout ou partie de la propriété d'une charge flottante a été libérée (403b)
    • 06 févr. 1997Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Legal charge
    Créé le 17 sept. 1984
    Livré le 19 sept. 1984
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    F/H property being a former warehouse and showroom at lower road, chorleywood hertfordshire.
    Personnes ayant droit
    • Lloyds Bank PLC
    Transactions
    • 19 sept. 1984Enregistrement d'une charge
    • 10 juin 1995Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Legal mortgage
    Créé le 13 juin 1983
    Livré le 28 juin 1983
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Property at west road, tottenham l/b of horingay title no ngl 357592 and/or the proceeds of sale thereof. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Personnes ayant droit
    • National Westminster Bank PLC
    Transactions
    • 28 juin 1983Enregistrement d'une charge
    Legal mortgage
    Créé le 23 mai 1983
    Livré le 25 mai 1983
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    9 north street, leatherhead surrey, title no sy 494073 and/or the proceeds of the sale thereof. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Personnes ayant droit
    • National Westminster Bank PLC
    Transactions
    • 25 mai 1983Enregistrement d'une charge
    Charge
    Créé le 06 janv. 1982
    Livré le 07 janv. 1982
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee
    Brèves mentions
    F/H maple court 94 high street, horsell.
    Personnes ayant droit
    • Town & Country Building Society
    Transactions
    • 07 janv. 1982Enregistrement d'une charge
    • 23 juin 1998Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)

    Source de données

    • Companies House du Royaume-Uni
      Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers.
    • Licence: CC0