PARK HUMAN RESOURCES LIMITED

PARK HUMAN RESOURCES LIMITED

  • Vue d'ensemble
  • Résumé
  • Objet social
  • Adresse
  • Dénominations sociales précédentes
  • Comptes
  • Bilan annuel
  • Dépôts
  • Dirigeants
  • Charges
  • Source de données
  • Vue d'ensemble

    Nom de la sociétéPARK HUMAN RESOURCES LIMITED
    Statut de la sociétéDissoute
    Forme juridiqueSociété à responsabilité limitée
    Numéro de société 00788113
    JuridictionAngleterre/Pays de Galles
    Date de création
    Date de cessation d'activité

    Résumé

    A des PSCs super sécurisésNon
    A des chargesOui
    A un historique d'insolvabilitéNon
    Le siège social est contestéNon

    Quel est l'objet de PARK HUMAN RESOURCES LIMITED ?

    • Société inactive (99999) / Activités des organisations et organismes extraterritoriaux

    Où se situe PARK HUMAN RESOURCES LIMITED ?

    Adresse du siège social
    Suite 2.01 17,Hanover Square
    W1S 1BN London
    England
    Adresse du siège social non livrableNon

    Quels étaient les noms précédents de PARK HUMAN RESOURCES LIMITED ?

    Dénominations sociales précédentes
    Nom de la sociétéDeJusqu'au
    PA ADVERTISING LIMITED04 juil. 198304 juil. 1983

    Quels sont les derniers comptes de PARK HUMAN RESOURCES LIMITED ?

    Derniers comptes
    Derniers comptes arrêtés au31 déc. 2014

    Quel est le statut du dernier bilan annuel pour PARK HUMAN RESOURCES LIMITED ?

    Bilan annuel
    Dernier bilan annuel

    Quels sont les derniers dépôts pour PARK HUMAN RESOURCES LIMITED ?

    Dépôts
    DateDescriptionDocumentType

    Bulletin officiel final dissous par radiation volontaire

    1 pagesGAZ2(A)

    Changement d'adresse du siège social de 11th Floor Marble Arch Tower 55,Bryanston Street London W1H 7AA à Suite 2.01 17,Hanover Square London W1S 1BN le 01 févr. 2016

    1 pagesAD01
    X4ZSSGPN

    Premier avis au Bulletin officiel pour la radiation volontaire

    1 pagesGAZ1(A)

    Demande de radiation de la société du registre du commerce

    3 pagesDS01
    A4Y7X27C

    Comptes pour une société dormante établis au 31 déc. 2014

    1 pagesAA
    S4M1NSQY

    Déclaration annuelle jusqu'au 01 juil. 2015 avec liste complète des actionnaires

    4 pagesAR01
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    capital13 juil. 2015

    État du capital au 13 juil. 2015

    • Capital: GBP 10,000
    SH01
    X4BJ9NX5

    Comptes pour une société dormante établis au 31 déc. 2013

    1 pagesAA
    A3GLTHD4

    Déclaration annuelle jusqu'au 01 juil. 2014 avec liste complète des actionnaires

    4 pagesAR01
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    capital14 juil. 2014

    État du capital au 14 juil. 2014

    • Capital: GBP 10,000
    SH01
    X3C3UPQY

    Comptes pour une société dormante établis au 31 déc. 2012

    1 pagesAA
    A2HKH4Y3

    Nomination de Mr David Ross Hooper en tant que secrétaire

    2 pagesAP03
    X2GAC8K2

    Cessation de la nomination de Julian Maslen en tant que directeur

    1 pagesTM01
    X2GAC7SI

    Cessation de la nomination de Julian Maslen en tant que secrétaire

    1 pagesTM02
    X2GAC7JT

    Déclaration annuelle jusqu'au 01 juil. 2013 avec liste complète des actionnaires

    5 pagesAR01
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    capital22 août 2013

    État du capital après une attribution d'actions au 22 août 2013

    SH01
    X2FA9SDE

    Changement d'adresse du siège social de * Saffron House 6-10 Kirby Street London EC1N 8EQ* le 26 juil. 2013

    1 pagesAD01
    X2DF2YDD

    Comptes pour une société dormante établis au 31 déc. 2011

    1 pagesAA
    A1HHT0QY

    Déclaration annuelle jusqu'au 01 juil. 2012 avec liste complète des actionnaires

    5 pagesAR01
    X1FQWN08

    Modification des coordonnées de l'administrateur Mr Simon John Howard le 06 mars 2012

    2 pagesCH01
    X14KNFLM

    Comptes pour une société dormante établis au 31 déc. 2010

    1 pagesAA
    ABJU9XEI

    Déclaration annuelle jusqu'au 01 juil. 2011 avec liste complète des actionnaires

    5 pagesAR01
    XOCQ9XB4

    Cessation de la nomination de Michael Warren en tant que secrétaire

    1 pagesTM02
    XYEZOMM4

    Nomination de Mr Julian David Maslen en tant que secrétaire

    2 pagesAP03
    XYEYBMMQ

    Cessation de la nomination de Michael Warren en tant que directeur

    1 pagesTM01
    XYEVSMM4

    Nomination de Mr Julian David Maslen en tant qu'administrateur

    2 pagesAP01
    XYEQ8MMF

    Déclaration annuelle jusqu'au 01 juil. 2010 avec liste complète des actionnaires

    5 pagesAR01
    XTT2TLIH

    Changement d'adresse du siège social de * Saffron House 6-10 Kirby Street London EC1N 8QE* le 09 juil. 2010

    1 pagesAD01
    XTT2SLIG

    Qui sont les dirigeants de PARK HUMAN RESOURCES LIMITED ?

    Dirigeants
    NomNommé leDate de démissionRôleAdresseIdentification de la sociétéPays de résidenceNationalitéDate de naissanceProfessionNuméro
    HOOPER, David Ross
    Gossmore Lane
    SL7 1QF Marlow
    Riverain
    Buckinghamshire
    England
    Secrétaire
    Gossmore Lane
    SL7 1QF Marlow
    Riverain
    Buckinghamshire
    England
    181084190001
    HOWARD, Simon John
    Boat Joseph Conrad
    106 Cheyne Walk
    SW10 0DG London
    House
    United Kingdom
    Administrateur
    Boat Joseph Conrad
    106 Cheyne Walk
    SW10 0DG London
    House
    United Kingdom
    United KingdomBritishCompany Director73313240006
    COOPER, Gillian Tina
    9 Tranmere Road
    SW18 3QH London
    Secrétaire
    9 Tranmere Road
    SW18 3QH London
    BritishChartered Accountant63764130001
    HARRISON, David John Anthony
    39 Park Hall Road
    West Dulwich
    SE21 8EX London
    Secrétaire
    39 Park Hall Road
    West Dulwich
    SE21 8EX London
    BritishCompany Director49068220001
    MASLEN, Julian David
    Heyes Lane
    SK9 7LH Alderley Edge
    Laine End 133
    Cheshire
    England
    Secrétaire
    Heyes Lane
    SK9 7LH Alderley Edge
    Laine End 133
    Cheshire
    England
    153472870001
    WADE, Peter Andrew
    9 Hitchin Road
    Stotfold
    SG5 4HP Hitchin
    Hertfordshire
    Secrétaire
    9 Hitchin Road
    Stotfold
    SG5 4HP Hitchin
    Hertfordshire
    British15337220001
    WARREN, Michael Anthony
    Farm
    Stanton
    WR12 7NE Broadway
    Manor
    Worcestershire
    United Kingdom
    Secrétaire
    Farm
    Stanton
    WR12 7NE Broadway
    Manor
    Worcestershire
    United Kingdom
    BritishDirector116895560003
    WARREN, Michael Anthony
    Manor Farm
    WR12 7NE Stanton
    Gloucestershire
    Secrétaire
    Manor Farm
    WR12 7NE Stanton
    Gloucestershire
    BritishFinance Director116895560005
    COLLEDGE, Rose
    42 Elgin Mansions
    Elgin Avenue
    W9 1JQ London
    Administrateur
    42 Elgin Mansions
    Elgin Avenue
    W9 1JQ London
    BritishDirector55317980002
    COOPER, Gillian Tina
    9 Tranmere Road
    SW18 3QH London
    Administrateur
    9 Tranmere Road
    SW18 3QH London
    BritishChartered Accountant63764130001
    COULTER, David John
    4 Stuarts Meadow
    Graffham
    GU28 0QE Petworth
    West Sussex
    Administrateur
    4 Stuarts Meadow
    Graffham
    GU28 0QE Petworth
    West Sussex
    BritishChartered Accountant52091570002
    CRAMP, Elisabeth Lyndsay
    4 Claremont End
    KT10 9LZ Esher
    Surrey
    Administrateur
    4 Claremont End
    KT10 9LZ Esher
    Surrey
    EnglandBritishOccupational Psychologist97695420001
    DOLBY, Andrew
    14 Isherwood Drive
    Marple
    SK6 6JD Stockport
    Cheshire
    Administrateur
    14 Isherwood Drive
    Marple
    SK6 6JD Stockport
    Cheshire
    BritishDirector64401200001
    DOUGLAS, Michael Stephen
    95 Brondesbury Road
    NW6 6RY London
    Administrateur
    95 Brondesbury Road
    NW6 6RY London
    BritishManagement Consultant35255090001
    ELLARD, Judith
    4 Iverna Court
    W8 6TY London
    Administrateur
    4 Iverna Court
    W8 6TY London
    BritishAdvertising Account Director67646540001
    HALFORD, Stephen Carl
    22 Ellesmere Road Ellesmere Park
    Monton
    M30 9FD Manchester
    Administrateur
    22 Ellesmere Road Ellesmere Park
    Monton
    M30 9FD Manchester
    EnglandBritishCompany Director117091930001
    HARRISON, David John Anthony
    39 Park Hall Road
    West Dulwich
    SE21 8EX London
    Administrateur
    39 Park Hall Road
    West Dulwich
    SE21 8EX London
    EnglandBritishFinance Director49068220001
    HORNSBY, Guy Michael
    Farthings 262 Station Road
    Knowle
    B93 0ES Solihull
    West Midlands
    Administrateur
    Farthings 262 Station Road
    Knowle
    B93 0ES Solihull
    West Midlands
    BritishManaging Director63993310001
    HOWARD, Simon John
    107 Bridge House
    Saint George Wharf
    SW8 2LQ London
    Administrateur
    107 Bridge House
    Saint George Wharf
    SW8 2LQ London
    United KingdomBritishRecruitment Consultant73313240006
    LANCASTER, Emma Voirrey
    Flat 5
    63 Brighton Road
    KT6 5LR Surbiton
    Surrey
    Administrateur
    Flat 5
    63 Brighton Road
    KT6 5LR Surbiton
    Surrey
    BritishChartered Accountant79034410002
    MASLEN, Julian David
    Heyes Lane
    SK9 7LH Alderley Edge
    Laine End 133
    Cheshire
    England
    Administrateur
    Heyes Lane
    SK9 7LH Alderley Edge
    Laine End 133
    Cheshire
    England
    EnglandBritishAccountant153394390001
    MORRIS, David Ian
    Laurel Bank
    Hernes Nest
    DY12 2ET Bewdley
    Worcestershire
    Administrateur
    Laurel Bank
    Hernes Nest
    DY12 2ET Bewdley
    Worcestershire
    BritishAdvertising Account Director67647020001
    MOYNIHAN, Jon
    59 Dovehouse Street
    SW8 6JY London
    Administrateur
    59 Dovehouse Street
    SW8 6JY London
    BritishGroup Chief Executive27594840001
    PRICE, David Robert
    1 Titchfield Close
    RH15 0RX Burgess Hill
    West Sussex
    Administrateur
    1 Titchfield Close
    RH15 0RX Burgess Hill
    West Sussex
    BritishChartered Accountant76272880001
    RUSSELL, Simon
    Manor Villa
    Portsmouth Road, Milford
    GU8 5DU Godalming
    Surrey
    Administrateur
    Manor Villa
    Portsmouth Road, Milford
    GU8 5DU Godalming
    Surrey
    BritishCreative Director55318060002
    RYLANDER, Gunnar
    Hjortstigen 19
    182 75 Stocksund
    Sweden
    Administrateur
    Hjortstigen 19
    182 75 Stocksund
    Sweden
    SwedishManagement Consultant26685870001
    THOMAS, John Michael
    29 Warwick Square
    SW1V 2AD London
    Administrateur
    29 Warwick Square
    SW1V 2AD London
    BritishManagment Consultant72510920001
    WALKER, John Leon Naylor
    57 Crescent Lane
    SW4 9PT London
    Administrateur
    57 Crescent Lane
    SW4 9PT London
    BritishManagement Consultant16701250001
    WARREN, Michael Anthony
    Farm
    Stanton
    WR12 7NE Broadway
    Manor
    Worcestershire
    United Kingdom
    Administrateur
    Farm
    Stanton
    WR12 7NE Broadway
    Manor
    Worcestershire
    United Kingdom
    EnglandBritishDirector116895560005
    WARREN, Michael Anthony
    Manor Farm
    WR12 7NE Stanton
    Gloucestershire
    Administrateur
    Manor Farm
    WR12 7NE Stanton
    Gloucestershire
    EnglandBritishFinance Director116895560005
    WOODLAND, Hilary Jane
    1 Alexandra Mews
    Fortis Green
    N2 9HA London
    Administrateur
    1 Alexandra Mews
    Fortis Green
    N2 9HA London
    BritishDirector97462470001

    PARK HUMAN RESOURCES LIMITED a-t-elle des charges ?

    Charges
    ClassificationDatesStatutDétails
    Fixed and floating charge
    Créé le 05 févr. 2003
    Livré le 19 févr. 2003
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • The Royal Bank of Scotland Commercial Services Limited
    Transactions
    • 19 févr. 2003Enregistrement d'une charge (395)
    • 02 déc. 2005Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Supplemental deed (to a composite guarantee and debenture dated 19TH august 1997)
    Créé le 26 août 1997
    Livré le 11 sept. 1997
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    The obligations of the new subsidiaries and the other companies being the existing companies (all as defined in the deed) to the chargee
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Midland Bank PLC
    Transactions
    • 11 sept. 1997Enregistrement d'une charge (395)
    • 05 mars 2003Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Fixed charge
    Créé le 25 juin 1996
    Livré le 05 juil. 1996
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    All items as listed with their policies of insurance,warranties,guarantees,etc. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Royscot Trust PLC
    Transactions
    • 05 juil. 1996Enregistrement d'une charge (395)
    • 28 févr. 2002Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Fixed charge
    Créé le 03 janv. 1996
    Livré le 05 janv. 1996
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee
    Brèves mentions
    The property and the proceeds and products thereof and the benefit of all policies of insurance,warranties,guarantees and other contracts now in force or during the currency of this security entered into in respect of the property. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Royscot Trust PLC
    Transactions
    • 05 janv. 1996Enregistrement d'une charge (395)
    • 28 févr. 2002Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Debenture
    Créé le 04 mai 1995
    Livré le 12 mai 1995
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transactions
    • 12 mai 1995Enregistrement d'une charge (395)
    • 28 févr. 2002Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Mortgage debenture
    Créé le 03 mai 1994
    Livré le 09 mai 1994
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    A specific charge over its goodwill and the benefit of any licences and all patents patent applicatins inventions trade-marks trade names registered designs copyrights know-how and any other intellectual property rights. A specific equitable charge over all freehold and leasehold properties and/or the proceeds of sale thereof fixed and floating charges over undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts and the benefits of any licences.
    Personnes ayant droit
    • National Westminster Bank PLC
    Transactions
    • 09 mai 1994Enregistrement d'une charge (395)
    • 11 avr. 1995Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Debenture
    Créé le 16 mai 1991
    Livré le 30 mai 1991
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personnes ayant droit
    • The Royal Bank of Sctland PLC
    Transactions
    • 30 mai 1991Enregistrement d'une charge
    • 16 mars 1995Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Debenture
    Créé le 20 oct. 1987
    Livré le 28 oct. 1987
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personnes ayant droit
    • Barclays Bank PLC
    Transactions
    • 28 oct. 1987Enregistrement d'une charge
    Debenture
    Créé le 20 oct. 1987
    Livré le 28 oct. 1987
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personnes ayant droit
    • National Westminster Bank PLC
    Transactions
    • 28 oct. 1987Enregistrement d'une charge

    Source de données

    • Companies House du Royaume-Uni
      Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers.
    • Licence: CC0