TOUCHWOOD SPORTS,LIMITED
Vue d'ensemble
Nom de la société | TOUCHWOOD SPORTS,LIMITED |
---|---|
Statut de la société | Dissoute |
Forme juridique | Société à responsabilité limitée |
Numéro de société | 00792497 |
Juridiction | Angleterre/Pays de Galles |
Date de création | |
Date de cessation d'activité |
Résumé
A des PSCs super sécurisés | Non |
---|---|
A des charges | Oui |
A un historique d'insolvabilité | Non |
Le siège social est contesté | Non |
Où se situe TOUCHWOOD SPORTS,LIMITED ?
Adresse du siège social | Edinburgh House Hollinsbrook Way Pilsworth BL9 8RR Bury Lancashire United Kingdom |
---|---|
Adresse du siège social non livrable | Non |
Quels sont les derniers comptes de TOUCHWOOD SPORTS,LIMITED ?
Derniers comptes | |
---|---|
Derniers comptes arrêtés au | 01 févr. 2020 |
Quels sont les derniers dépôts pour TOUCHWOOD SPORTS,LIMITED ?
Date | Description | Document | Type | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bulletin officiel final dissous par radiation volontaire | 1 pages | GAZ2(A) | ||||||||||
Premier avis au Bulletin officiel pour la radiation volontaire | 1 pages | GAZ1(A) | ||||||||||
Demande de radiation de la société du registre du commerce | 1 pages | DS01 | ||||||||||
Comptes pour une société dormante établis au 01 févr. 2020 | 8 pages | AA | ||||||||||
Déclaration de confirmation établie le 08 août 2020 avec mises à jour | 4 pages | CS01 | ||||||||||
Notification de Go Outdoors Retail Limited en tant que personne disposant d'un contrôle significatif le 23 juin 2020 | 2 pages | PSC02 | ||||||||||
Cessation de Gol Realisations Limited en tant que personne disposant d'un contrôle significatif le 23 juin 2020 | 1 pages | PSC07 | ||||||||||
Modification des détails d'une personne disposant d'un contrôle significatif | 2 pages | PSC05 | ||||||||||
Modification des détails de Go Outdoors Limited en tant que personne disposant d'un contrôle significatif le 25 juin 2020 | 2 pages | PSC05 | ||||||||||
Modification des détails de Go Outdoors Limited en tant que personne disposant d'un contrôle significatif le 16 janv. 2020 | 2 pages | PSC05 | ||||||||||
Nomination de Mrs Siobhan Mawdsley en tant que secrétaire le 06 janv. 2020 | 2 pages | AP03 | ||||||||||
Cessation de la nomination de Louise Ayling en tant que secrétaire le 18 oct. 2019 | 1 pages | TM02 | ||||||||||
Changement d'adresse du siège social de Cuthbert House Arley Street Sheffield S2 4QP à Edinburgh House Hollinsbrook Way Pilsworth Bury Lancashire BL9 8RR le 16 janv. 2020 | 1 pages | AD01 | ||||||||||
Comptes pour une société dormante établis au 02 févr. 2019 | 8 pages | AA | ||||||||||
Déclaration de confirmation établie le 08 août 2019 avec mises à jour | 4 pages | CS01 | ||||||||||
Deuxième dépôt pour la nomination de Lee Paul Bagnall en tant qu'administrateur | 6 pages | RP04AP01 | ||||||||||
Nomination de Mr Lee Paul Bagnall en tant qu'administrateur le 26 nov. 2016 | 3 pages | AP01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Nomination de Oakwood Corporate Secretary Limited en tant que secrétaire le 21 mai 2018 | 2 pages | AP04 | ||||||||||
Nomination de Mr Neil James Greenhalgh en tant qu'administrateur le 01 nov. 2018 | 2 pages | AP01 | ||||||||||
Cessation de la nomination de Brian Michael Small en tant que directeur le 31 oct. 2018 | 1 pages | TM01 | ||||||||||
Comptes pour une société dormante établis au 03 févr. 2018 | 8 pages | AA | ||||||||||
Déclaration de confirmation établie le 08 août 2018 sans mise à jour | 3 pages | CS01 | ||||||||||
Modification des coordonnées de l'administrateur Mr Brian Michael Small le 09 août 2018 | 2 pages | CH01 | ||||||||||
Modification des coordonnées de l'administrateur Mr Peter Alan Cowgill le 09 août 2018 | 2 pages | CH01 | ||||||||||
Résolutions Resolutions | 39 pages | RESOLUTIONS | ||||||||||
|
Qui sont les dirigeants de TOUCHWOOD SPORTS,LIMITED ?
Nom | Nommé le | Date de démission | Rôle | Adresse | Identification de la société | Pays de résidence | Nationalité | Date de naissance | Profession | Numéro | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MAWDSLEY, Siobhan | Secrétaire | Hollinsbrook Way Pilsworth BL9 8RR Bury Edinburgh House Lancashire United Kingdom | 266337130001 | |||||||||||
OAKWOOD CORPORATE SECRETARY LIMITED | Secrétaire | 1 Ashley Road WA14 2DT Altrincham 3rd Floor Cheshire United Kingdom |
| 146358090001 | ||||||||||
BAGNALL, Lee Paul | Administrateur | Hollinsbrook Way Pilsworth BL9 8RR Bury Edinburgh House Lancashire United Kingdom | United Kingdom | British | Managing Director | 254379490001 | ||||||||
COWGILL, Peter Alan | Administrateur | Hollinsbrook Way Pilsworth BL9 8RR Bury Edinburgh House Lancashire United Kingdom | England | British | Director | 84147460004 | ||||||||
GREENHALGH, Neil James | Administrateur | Hollinsbrook Way Pilsworth BL9 8RR Bury Edinburgh House Lancashire United Kingdom | United Kingdom | British | Director | 165421500001 | ||||||||
AYLING, Louise | Secrétaire | Hollinsbrook Way Pilsworth BL9 8RR Bury Edinburgh House Lancashire United Kingdom | 234992590001 | |||||||||||
CLARE, Peter John | Secrétaire | 24 Wootton Road OX14 1JD Abingdon Oxfordshire | British | 15367850001 | ||||||||||
MAYNARD, George Fitzgerald | Secrétaire | Arley Street S2 4QP Sheffield Cuthbert House United Kingdom | 185096900001 | |||||||||||
WOODS, Roger Lewis | Secrétaire | Arley Street S2 4QP Sheffield Cuthbert House United Kingdom | British | Accountant | 108148850001 | |||||||||
CAPLAN, Paul | Administrateur | Arley Street S2 4QP Sheffield Cuthbert House United Kingdom | United States | British | Retailer | 57732180003 | ||||||||
CLARE, Christina Mary | Administrateur | 71 Bath Street OX14 1EN Abingdon Oxfordshire | British | Housewife | 15367900002 | |||||||||
CLARE, George William | Administrateur | 71 Bath Street OX14 1EN Abingdon Oxfordshire | British | Engineer | 15367860002 | |||||||||
CLARE, Kevin William | Administrateur | 30 Abbott Road OX14 2DU Abingdon Oxfordshire | British | Retailer | 15367870002 | |||||||||
CLARE, Peter John | Administrateur | 24 Wootton Road OX14 1JD Abingdon Oxfordshire | British | Retailer | 15367850001 | |||||||||
CLARE, Susan Mary | Administrateur | 24 Wootton Road OX14 1JD Abingdon Oxfordshire | British | Office Manager | 15367880001 | |||||||||
GRAHAM, John Llewelyn | Administrateur | Arley Street S2 4QP Sheffield Cuthbert House United Kingdom | United Kingdom | British | Retailer | 58278300008 | ||||||||
MATTHEWS, Christian John | Administrateur | Arley Street S2 4QP Sheffield Cuthbert House | England | British | Director | 213313350001 | ||||||||
PRICE, David | Administrateur | 100 Kennington Road Kennington OX1 5PE Oxford Oxon | British | Company Director | 46329020001 | |||||||||
SAMWAYS, Michael John | Administrateur | Chakala Wantage Road Rowstock OX11 0JU Didcot Oxfordshire | British | Company Director | 46328990001 | |||||||||
SMALL, Brian Michael | Administrateur | Hollinsbrook Way Pilsworth BL9 8RR Bury Edinburgh House Lancashire United Kingdom | United Kingdom | British | Director | 45198750002 | ||||||||
SUTTON, Julie Christina | Administrateur | 206 The Avenue Kennington OX1 5RN Oxford | British | Company Director | 83740330001 | |||||||||
SUTTON, Robert Jim | Administrateur | 206 The Avenue Kennington OX1 5RN Oxford | British | General Manager | 15367890001 |
Qui sont les personnes ayant un contrôle significatif sur TOUCHWOOD SPORTS,LIMITED ?
Nom | Notifié le | Adresse | Cessé | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Go Outdoors Retail Limited | 23 juin 2020 | Hollinsbrook Way Pilsworth BL9 8RR Bury Edinburgh House England | Non | ||||||||||
| |||||||||||||
Nature du contrôle
| |||||||||||||
Gol Realisations Limited | 06 avr. 2016 | Hollinsbrook Way Pilsworth BL9 8RR Bury Edinburgh House Lancashire United Kingdom | Oui | ||||||||||
| |||||||||||||
Nature du contrôle
|
TOUCHWOOD SPORTS,LIMITED a-t-elle des charges ?
Classification | Dates | Statut | Détails | |
---|---|---|---|---|
Debenture | Créé le 06 janv. 2006 Livré le 12 janv. 2006 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brèves mentions Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
Legal charge | Créé le 06 janv. 2006 Livré le 12 janv. 2006 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brèves mentions F/H and l/h land lying to the north west of abingdon road oxford t/n ON4090. By way of fixed charge the benefit of all covenants and rights concerning the property and plant machinery fixtures fittings furniture equipment implements and utensils the goodwill of any business carried on at the property and the proceeds of any insurance affecting the property or assets. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
Legal charge | Créé le 19 juin 1987 Livré le 03 juil. 1987 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brèves mentions 434 abingdon road, oxford, oxfordshire. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
Legal mortgage | Créé le 20 juil. 1979 Livré le 21 janv. 1980 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brèves mentions 430, abingdon road, oxford, - freehold house. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
Debenture | Créé le 11 févr. 1977 Livré le 01 mars 1977 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brèves mentions Specific equitable charge over all f/h & l/h properties over all stocks, shares & other securities, over all book & other debts, an assignment of goodwill floating charge over all the undertaking and all other the property assets present & future. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
Legal charge | Créé le 13 avr. 1976 Livré le 21 avr. 1976 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brèves mentions 107, st. Aldates street, oxford with all fixtures. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
Legal mortgage | Créé le 13 avr. 1976 Livré le 21 avr. 1976 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brèves mentions 107 st aldates, oxford. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
|
Source de données
- Companies House du Royaume-Uni
Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers. - Licence: CC0