P.M.CRAFTS LIMITED

  • Vue d'ensemble
  • Résumé
  • Objet social
  • Adresse
  • Comptes
  • Bilan annuel
  • Dépôts
  • Dirigeants
  • Charges
  • Source de données
  • Vue d'ensemble

    Nom de la sociétéP.M.CRAFTS LIMITED
    Statut de la sociétéDissoute
    Forme juridiqueSociété à responsabilité limitée
    Numéro de société 00801067
    JuridictionAngleterre/Pays de Galles
    Date de création
    Date de cessation d'activité

    Résumé

    A des PSCs super sécurisésNon
    A des chargesOui
    A un historique d'insolvabilitéNon
    Le siège social est contestéNon

    Quel est l'objet de P.M.CRAFTS LIMITED ?

    • Société inactive (99999) / Activités des organisations et organismes extraterritoriaux

    Où se situe P.M.CRAFTS LIMITED ?

    Adresse du siège social
    c/o MSQ PARTNERS LTD
    6 York Street
    W1U 6PL London
    Adresse du siège social non livrableNon

    Quels sont les derniers comptes de P.M.CRAFTS LIMITED ?

    Derniers comptes
    Derniers comptes arrêtés au28 févr. 2013

    Quel est le statut du dernier bilan annuel pour P.M.CRAFTS LIMITED ?

    Bilan annuel
    Dernier bilan annuel

    Quels sont les derniers dépôts pour P.M.CRAFTS LIMITED ?

    Dépôts
    DateDescriptionDocumentType

    Bulletin officiel final dissous par radiation volontaire

    1 pagesGAZ2(A)

    Déclaration annuelle jusqu'au 06 mars 2014 avec liste complète des actionnaires

    5 pagesAR01
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    capital02 avr. 2014

    État du capital au 02 avr. 2014

    • Capital: GBP 570,000
    SH01

    Premier avis au Bulletin officiel pour la radiation volontaire

    1 pagesGAZ1(A)

    Demande de radiation de la société du registre du commerce

    3 pagesDS01

    Comptes pour une société dormante établis au 28 févr. 2013

    6 pagesAA

    Nomination de Mr Daniel Yardley en tant qu'administrateur

    2 pagesAP01

    Nomination de Mr Peter David Reid en tant qu'administrateur

    2 pagesAP01

    Cessation de la nomination de Dean Wright en tant que directeur

    1 pagesTM01

    Déclaration annuelle jusqu'au 06 mars 2013 avec liste complète des actionnaires

    4 pagesAR01

    Changement d'adresse du siège social de * C/O Media Square Plc 6 York Street London W1U 6PL United Kingdom* le 12 mars 2013

    1 pagesAD01

    Comptes pour une société dormante établis au 29 févr. 2012

    6 pagesAA

    Déclaration annuelle jusqu'au 06 mars 2012 avec liste complète des actionnaires

    4 pagesAR01

    legacy

    3 pagesMG02

    Nomination de Ashish Shah en tant que secrétaire

    1 pagesAP03

    Cessation de la nomination de Colin Brigden en tant que secrétaire

    1 pagesTM02

    Comptes pour une société dormante établis au 28 févr. 2011

    6 pagesAA

    Nomination de Mr Dean Anthony Wright en tant qu'administrateur

    2 pagesAP01

    Cessation de la nomination de Bruce Winfield en tant que directeur

    1 pagesTM01

    Cessation de la nomination de Bruce Winfield en tant que secrétaire

    1 pagesTM02

    Déclaration annuelle jusqu'au 06 mars 2011 avec liste complète des actionnaires

    5 pagesAR01

    Comptes pour une société dormante établis au 28 févr. 2010

    6 pagesAA

    legacy

    3 pagesMG02

    Déclaration annuelle jusqu'au 06 mars 2010 avec liste complète des actionnaires

    4 pagesAR01

    Changement d'adresse du siège social de * C/O Media Square Plc, Clarence Mill, Clarence Road Bollington Cheshire SK10 5JZ* le 01 déc. 2009

    1 pagesAD01

    Nomination de Mr Colin John Brigden en tant que secrétaire

    1 pagesAP03

    Qui sont les dirigeants de P.M.CRAFTS LIMITED ?

    Dirigeants
    NomNommé leDate de démissionRôleAdresseIdentification de la sociétéPays de résidenceNationalitéDate de naissanceProfessionNuméro
    SHAH, Ashish
    c/o Msq Partners Ltd
    York Street
    W1U 6PL London
    6
    United Kingdom
    Secrétaire
    c/o Msq Partners Ltd
    York Street
    W1U 6PL London
    6
    United Kingdom
    164776960001
    REID, Peter David
    c/o Msq Partners Ltd
    York Street
    W1U 6PL London
    6
    United Kingdom
    Administrateur
    c/o Msq Partners Ltd
    York Street
    W1U 6PL London
    6
    United Kingdom
    EnglandBritishGroup Ceo147274580002
    YARDLEY, Daniel John
    c/o Msq Partners Ltd
    York Street
    W1U 6PL London
    6
    United Kingdom
    Administrateur
    c/o Msq Partners Ltd
    York Street
    W1U 6PL London
    6
    United Kingdom
    EnglandBritishChief Financial Officer180507300001
    ALEXANDER, Charles Stuart
    24 Waveney Close
    Kennet Street
    E1W 2JL London
    Secrétaire
    24 Waveney Close
    Kennet Street
    E1W 2JL London
    BritishAccountant66329190001
    BRIGDEN, Colin John
    c/o Media Square Plc
    York Street
    W1U 6PL London
    6
    United Kingdom
    Secrétaire
    c/o Media Square Plc
    York Street
    W1U 6PL London
    6
    United Kingdom
    147343670001
    CLARKE, Martin John
    105 Congleton Road
    SK11 7XD Macclesfield
    Cheshire
    Secrétaire
    105 Congleton Road
    SK11 7XD Macclesfield
    Cheshire
    British53461320002
    KEEN, David Alan
    60 Garnetts
    Takeley
    CM22 6RN Bishops Stortford
    Hertfordshire
    Secrétaire
    60 Garnetts
    Takeley
    CM22 6RN Bishops Stortford
    Hertfordshire
    British16642410001
    PENN, John Robert
    Wish Cottage Avey Lane
    High Beech
    IG10 4AB Loughton
    Essex
    Secrétaire
    Wish Cottage Avey Lane
    High Beech
    IG10 4AB Loughton
    Essex
    BritishCompany Director7147450001
    WINFIELD, Bruce Malcolm
    22 Hillhouse Close
    RH10 4YY Turners Hill
    West Sussex
    Secrétaire
    22 Hillhouse Close
    RH10 4YY Turners Hill
    West Sussex
    British147948820001
    ALEXANDER, Charles Stuart
    24 Waveney Close
    Kennet Street
    E1W 2JL London
    Administrateur
    24 Waveney Close
    Kennet Street
    E1W 2JL London
    BritishAccountant66329190001
    BURNS, Graeme Ian, Mr.
    29 Moody Street
    CW12 4AN Congleton
    Cheshire
    Administrateur
    29 Moody Street
    CW12 4AN Congleton
    Cheshire
    United KingdomBritishAccountant75720570001
    ESSEX, Robert Thomas Tickler
    21 Rylett Road
    W12 9SS London
    Administrateur
    21 Rylett Road
    W12 9SS London
    EnglandBritishDirector7666390002
    KEEN, David Alan
    60 Garnetts
    Takeley
    CM22 6RN Bishops Stortford
    Hertfordshire
    Administrateur
    60 Garnetts
    Takeley
    CM22 6RN Bishops Stortford
    Hertfordshire
    BritishAccountant16642410001
    LEEKE, Anthony John
    41 Westend
    Haddenham
    Ely
    Cambridgeshire
    Administrateur
    41 Westend
    Haddenham
    Ely
    Cambridgeshire
    BritishProduction Director7147480002
    MIDDLETON, Arthur Jeremy Barritt
    Corbar Hall
    Corbar Road
    SK17 6TF Buxton
    Administrateur
    Corbar Hall
    Corbar Road
    SK17 6TF Buxton
    EnglandBritishCompany Director72455560001
    MULVEY, Patrick Brendan
    Amberley
    Newmarket Road Hare Street Village
    SG9 0EU Buntingford
    Hertfordshire
    Administrateur
    Amberley
    Newmarket Road Hare Street Village
    SG9 0EU Buntingford
    Hertfordshire
    United KingdomBritish66697290001
    PENN, John Robert
    Wish Cottage Avey Lane
    High Beech
    IG10 4AB Loughton
    Essex
    Administrateur
    Wish Cottage Avey Lane
    High Beech
    IG10 4AB Loughton
    Essex
    BritishAdvertising Executive7147450001
    PENN, Mary Elizabeth
    Wish Cottage Avey Lane
    High Beech
    IG10 4AB Loughton
    Essex
    Administrateur
    Wish Cottage Avey Lane
    High Beech
    IG10 4AB Loughton
    Essex
    BritishSecretary7147460001
    WINFIELD, Bruce Malcolm
    22 Hillhouse Close
    RH10 4YY Turners Hill
    West Sussex
    Administrateur
    22 Hillhouse Close
    RH10 4YY Turners Hill
    West Sussex
    United KingdomBritishAccountant147948820001
    WRIGHT, Dean Anthony
    c/o Msq Partners Ltd
    York Street
    W1U 6PL London
    6
    United Kingdom
    Administrateur
    c/o Msq Partners Ltd
    York Street
    W1U 6PL London
    6
    United Kingdom
    EnglandBritishDirector159138180001

    P.M.CRAFTS LIMITED a-t-elle des charges ?

    Charges
    ClassificationDatesStatutDétails
    Debenture
    Créé le 04 nov. 2005
    Livré le 17 nov. 2005
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the obligors to the finance parties under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland (The Security Trustee)
    Transactions
    • 17 nov. 2005Enregistrement d'une charge (395)
    • 22 déc. 2011Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (MG02)
    Debenture
    Créé le 15 oct. 2004
    Livré le 22 oct. 2004
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personnes ayant droit
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transactions
    • 22 oct. 2004Enregistrement d'une charge (395)
    • 02 juil. 2010Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (MG02)
    Guarantee & debenture
    Créé le 21 août 2001
    Livré le 30 août 2001
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    (Including trade fixtures). Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personnes ayant droit
    • Barclays Bank PLC
    Transactions
    • 30 août 2001Enregistrement d'une charge (395)
    • 17 janv. 2006Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Guarantee & debenture
    Créé le 08 juin 1999
    Livré le 15 juin 1999
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personnes ayant droit
    • Barclays Bank PLC
    Transactions
    • 15 juin 1999Enregistrement d'une charge (395)
    • 17 janv. 2006Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Legal charge
    Créé le 04 janv. 1996
    Livré le 15 janv. 1996
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    5 (unit 8) regal lane,soham,ely,cambridgeshire.
    Personnes ayant droit
    • Barclays Bank PLC
    Transactions
    • 15 janv. 1996Enregistrement d'une charge (395)
    • 18 févr. 1999Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Mortgage
    Créé le 27 mai 1987
    Livré le 02 juin 1987
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    Securing £316,000 and all other moneys due or to become due from lopping display holdings limited to eagle star insurance company limited
    Brèves mentions
    All and any estate of interest whatsoever that the company has at the date hereof or may at any future time have in unit 10 studlands park avenue, newmarket, suffolk, being the whole of the land remaining in and contained in a conveyance.
    Personnes ayant droit
    • Eagle Star Insurance Company Limited.
    Transactions
    • 02 juin 1987Enregistrement d'une charge
    • 01 sept. 2006Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Further guarantee & debenture
    Créé le 25 avr. 1983
    Livré le 04 mai 1983
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    All that property undertaking and assets charged by the principal deed and further deed.
    Personnes ayant droit
    • Barclays Bank PLC
    Transactions
    • 04 mai 1983Enregistrement d'une charge
    • 17 janv. 2006Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Guarantee and debenture
    Créé le 09 juin 1981
    Livré le 15 juin 1981
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever.
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital, buildings fixtures, fixed plant & machinery (see doc M43).
    Personnes ayant droit
    • Barclays Bank PLC
    Transactions
    • 15 juin 1981Enregistrement d'une charge
    • 17 janv. 2006Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Legal charge
    Créé le 25 mars 1980
    Livré le 09 avr. 1980
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    F/Hold land at studlands park industrial estate, newmarket, west suffolk.
    Personnes ayant droit
    • Barclays Bank PLC
    Transactions
    • 09 avr. 1980Enregistrement d'une charge
    • 17 janv. 2006Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Debenture
    Créé le 22 mars 1972
    Livré le 28 mars 1972
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due etc
    Brèves mentions
    Undertaking and all property and goodwill & assets present and future including uncalled capital. Fixed & floating charges, for details please see doc 23.
    Personnes ayant droit
    • Barclays Bank PLC
    Transactions
    • 28 mars 1972Enregistrement d'une charge
    • 17 janv. 2006Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Legal charge
    Créé le 18 juil. 1968
    Livré le 24 juil. 1968
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due etc
    Brèves mentions
    Unit 1, station approach, waltham cross herts.
    Personnes ayant droit
    • Barclays Bank PLC
    Transactions
    • 24 juil. 1968Enregistrement d'une charge
    • 17 janv. 2006Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Legal charge
    Créé le 18 juil. 1968
    Livré le 24 juil. 1968
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due etc
    Brèves mentions
    Unit 7 station approach waltham cross herts.
    Personnes ayant droit
    • Barclays Bank PLC
    Transactions
    • 24 juil. 1968Enregistrement d'une charge
    • 17 janv. 2006Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)

    Source de données

    • Companies House du Royaume-Uni
      Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers.
    • Licence: CC0