P.M.CRAFTS LIMITED
Vue d'ensemble
Nom de la société | P.M.CRAFTS LIMITED |
---|---|
Statut de la société | Dissoute |
Forme juridique | Société à responsabilité limitée |
Numéro de société | 00801067 |
Juridiction | Angleterre/Pays de Galles |
Date de création | |
Date de cessation d'activité |
Résumé
A des PSCs super sécurisés | Non |
---|---|
A des charges | Oui |
A un historique d'insolvabilité | Non |
Le siège social est contesté | Non |
Où se situe P.M.CRAFTS LIMITED ?
Adresse du siège social | c/o MSQ PARTNERS LTD 6 York Street W1U 6PL London |
---|---|
Adresse du siège social non livrable | Non |
Quels sont les derniers comptes de P.M.CRAFTS LIMITED ?
Derniers comptes | |
---|---|
Derniers comptes arrêtés au | 28 févr. 2013 |
Quel est le statut du dernier bilan annuel pour P.M.CRAFTS LIMITED ?
Bilan annuel |
|
---|
Quels sont les derniers dépôts pour P.M.CRAFTS LIMITED ?
Date | Description | Document | Type | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bulletin officiel final dissous par radiation volontaire | 1 pages | GAZ2(A) | ||||||||||
Déclaration annuelle jusqu'au 06 mars 2014 avec liste complète des actionnaires | 5 pages | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Premier avis au Bulletin officiel pour la radiation volontaire | 1 pages | GAZ1(A) | ||||||||||
Demande de radiation de la société du registre du commerce | 3 pages | DS01 | ||||||||||
Comptes pour une société dormante établis au 28 févr. 2013 | 6 pages | AA | ||||||||||
Nomination de Mr Daniel Yardley en tant qu'administrateur | 2 pages | AP01 | ||||||||||
Nomination de Mr Peter David Reid en tant qu'administrateur | 2 pages | AP01 | ||||||||||
Cessation de la nomination de Dean Wright en tant que directeur | 1 pages | TM01 | ||||||||||
Déclaration annuelle jusqu'au 06 mars 2013 avec liste complète des actionnaires | 4 pages | AR01 | ||||||||||
Changement d'adresse du siège social de * C/O Media Square Plc 6 York Street London W1U 6PL United Kingdom* le 12 mars 2013 | 1 pages | AD01 | ||||||||||
Comptes pour une société dormante établis au 29 févr. 2012 | 6 pages | AA | ||||||||||
Déclaration annuelle jusqu'au 06 mars 2012 avec liste complète des actionnaires | 4 pages | AR01 | ||||||||||
legacy | 3 pages | MG02 | ||||||||||
Nomination de Ashish Shah en tant que secrétaire | 1 pages | AP03 | ||||||||||
Cessation de la nomination de Colin Brigden en tant que secrétaire | 1 pages | TM02 | ||||||||||
Comptes pour une société dormante établis au 28 févr. 2011 | 6 pages | AA | ||||||||||
Nomination de Mr Dean Anthony Wright en tant qu'administrateur | 2 pages | AP01 | ||||||||||
Cessation de la nomination de Bruce Winfield en tant que directeur | 1 pages | TM01 | ||||||||||
Cessation de la nomination de Bruce Winfield en tant que secrétaire | 1 pages | TM02 | ||||||||||
Déclaration annuelle jusqu'au 06 mars 2011 avec liste complète des actionnaires | 5 pages | AR01 | ||||||||||
Comptes pour une société dormante établis au 28 févr. 2010 | 6 pages | AA | ||||||||||
legacy | 3 pages | MG02 | ||||||||||
Déclaration annuelle jusqu'au 06 mars 2010 avec liste complète des actionnaires | 4 pages | AR01 | ||||||||||
Changement d'adresse du siège social de * C/O Media Square Plc, Clarence Mill, Clarence Road Bollington Cheshire SK10 5JZ* le 01 déc. 2009 | 1 pages | AD01 | ||||||||||
Nomination de Mr Colin John Brigden en tant que secrétaire | 1 pages | AP03 | ||||||||||
Qui sont les dirigeants de P.M.CRAFTS LIMITED ?
Nom | Nommé le | Date de démission | Rôle | Adresse | Identification de la société | Pays de résidence | Nationalité | Date de naissance | Profession | Numéro |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SHAH, Ashish | Secrétaire | c/o Msq Partners Ltd York Street W1U 6PL London 6 United Kingdom | 164776960001 | |||||||
REID, Peter David | Administrateur | c/o Msq Partners Ltd York Street W1U 6PL London 6 United Kingdom | England | British | Group Ceo | 147274580002 | ||||
YARDLEY, Daniel John | Administrateur | c/o Msq Partners Ltd York Street W1U 6PL London 6 United Kingdom | England | British | Chief Financial Officer | 180507300001 | ||||
ALEXANDER, Charles Stuart | Secrétaire | 24 Waveney Close Kennet Street E1W 2JL London | British | Accountant | 66329190001 | |||||
BRIGDEN, Colin John | Secrétaire | c/o Media Square Plc York Street W1U 6PL London 6 United Kingdom | 147343670001 | |||||||
CLARKE, Martin John | Secrétaire | 105 Congleton Road SK11 7XD Macclesfield Cheshire | British | 53461320002 | ||||||
KEEN, David Alan | Secrétaire | 60 Garnetts Takeley CM22 6RN Bishops Stortford Hertfordshire | British | 16642410001 | ||||||
PENN, John Robert | Secrétaire | Wish Cottage Avey Lane High Beech IG10 4AB Loughton Essex | British | Company Director | 7147450001 | |||||
WINFIELD, Bruce Malcolm | Secrétaire | 22 Hillhouse Close RH10 4YY Turners Hill West Sussex | British | 147948820001 | ||||||
ALEXANDER, Charles Stuart | Administrateur | 24 Waveney Close Kennet Street E1W 2JL London | British | Accountant | 66329190001 | |||||
BURNS, Graeme Ian, Mr. | Administrateur | 29 Moody Street CW12 4AN Congleton Cheshire | United Kingdom | British | Accountant | 75720570001 | ||||
ESSEX, Robert Thomas Tickler | Administrateur | 21 Rylett Road W12 9SS London | England | British | Director | 7666390002 | ||||
KEEN, David Alan | Administrateur | 60 Garnetts Takeley CM22 6RN Bishops Stortford Hertfordshire | British | Accountant | 16642410001 | |||||
LEEKE, Anthony John | Administrateur | 41 Westend Haddenham Ely Cambridgeshire | British | Production Director | 7147480002 | |||||
MIDDLETON, Arthur Jeremy Barritt | Administrateur | Corbar Hall Corbar Road SK17 6TF Buxton | England | British | Company Director | 72455560001 | ||||
MULVEY, Patrick Brendan | Administrateur | Amberley Newmarket Road Hare Street Village SG9 0EU Buntingford Hertfordshire | United Kingdom | British | 66697290001 | |||||
PENN, John Robert | Administrateur | Wish Cottage Avey Lane High Beech IG10 4AB Loughton Essex | British | Advertising Executive | 7147450001 | |||||
PENN, Mary Elizabeth | Administrateur | Wish Cottage Avey Lane High Beech IG10 4AB Loughton Essex | British | Secretary | 7147460001 | |||||
WINFIELD, Bruce Malcolm | Administrateur | 22 Hillhouse Close RH10 4YY Turners Hill West Sussex | United Kingdom | British | Accountant | 147948820001 | ||||
WRIGHT, Dean Anthony | Administrateur | c/o Msq Partners Ltd York Street W1U 6PL London 6 United Kingdom | England | British | Director | 159138180001 |
P.M.CRAFTS LIMITED a-t-elle des charges ?
Classification | Dates | Statut | Détails | |
---|---|---|---|---|
Debenture | Créé le 04 nov. 2005 Livré le 17 nov. 2005 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from the obligors to the finance parties under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Brèves mentions Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
Debenture | Créé le 15 oct. 2004 Livré le 22 oct. 2004 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brèves mentions Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
Guarantee & debenture | Créé le 21 août 2001 Livré le 30 août 2001 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever | |
Brèves mentions (Including trade fixtures). Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
Guarantee & debenture | Créé le 08 juin 1999 Livré le 15 juin 1999 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever | |
Brèves mentions Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
Legal charge | Créé le 04 janv. 1996 Livré le 15 janv. 1996 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brèves mentions 5 (unit 8) regal lane,soham,ely,cambridgeshire. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
Mortgage | Créé le 27 mai 1987 Livré le 02 juin 1987 | Totalement satisfaite | Montant garanti Securing £316,000 and all other moneys due or to become due from lopping display holdings limited to eagle star insurance company limited | |
Brèves mentions All and any estate of interest whatsoever that the company has at the date hereof or may at any future time have in unit 10 studlands park avenue, newmarket, suffolk, being the whole of the land remaining in and contained in a conveyance. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
Further guarantee & debenture | Créé le 25 avr. 1983 Livré le 04 mai 1983 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever | |
Brèves mentions All that property undertaking and assets charged by the principal deed and further deed. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
Guarantee and debenture | Créé le 09 juin 1981 Livré le 15 juin 1981 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever. | |
Brèves mentions Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital, buildings fixtures, fixed plant & machinery (see doc M43). | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
Legal charge | Créé le 25 mars 1980 Livré le 09 avr. 1980 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brèves mentions F/Hold land at studlands park industrial estate, newmarket, west suffolk. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
Debenture | Créé le 22 mars 1972 Livré le 28 mars 1972 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due etc | |
Brèves mentions Undertaking and all property and goodwill & assets present and future including uncalled capital. Fixed & floating charges, for details please see doc 23. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
Legal charge | Créé le 18 juil. 1968 Livré le 24 juil. 1968 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due etc | |
Brèves mentions Unit 1, station approach, waltham cross herts. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
Legal charge | Créé le 18 juil. 1968 Livré le 24 juil. 1968 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due etc | |
Brèves mentions Unit 7 station approach waltham cross herts. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
|
Source de données
- Companies House du Royaume-Uni
Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers. - Licence: CC0