COMFORT LODGE LIMITED

  • Vue d'ensemble
  • Résumé
  • Objet social
  • Adresse
  • Dénominations sociales précédentes
  • Comptes
  • Bilan annuel
  • Dépôts
  • Dirigeants
  • Insolvabilité
  • Source de données
  • Vue d'ensemble

    Nom de la sociétéCOMFORT LODGE LIMITED
    Statut de la sociétéDissoute
    Forme juridiqueSociété à responsabilité limitée
    Numéro de société 00804560
    JuridictionAngleterre/Pays de Galles
    Date de création
    Date de cessation d'activité

    Résumé

    A des PSCs super sécurisésNon
    A des chargesNon
    A un historique d'insolvabilitéOui
    Le siège social est contestéNon

    Quel est l'objet de COMFORT LODGE LIMITED ?

    • Activités des sièges sociaux (70100) / Activités spécialisées, scientifiques et techniques

    Où se situe COMFORT LODGE LIMITED ?

    Adresse du siège social
    1 More London Place
    SE1 2AF London
    United Kingdom
    Adresse du siège social non livrableNon

    Quels étaient les noms précédents de COMFORT LODGE LIMITED ?

    Dénominations sociales précédentes
    Nom de la sociétéDeJusqu'au
    HARWOOD MANOR LIMITED08 mai 196408 mai 1964

    Quels sont les derniers comptes de COMFORT LODGE LIMITED ?

    Derniers comptes
    Derniers comptes arrêtés au31 déc. 2013

    Quel est le statut du dernier bilan annuel pour COMFORT LODGE LIMITED ?

    Bilan annuel
    Dernier bilan annuel

    Quels sont les derniers dépôts pour COMFORT LODGE LIMITED ?

    Dépôts
    DateDescriptionDocumentType

    Gazette finale dissoute à la suite d'une liquidation

    1 pagesGAZ2

    Retour de la réunion finale dans une liquidation volontaire des membres

    7 pages4.71

    Les registres ont été transférés au lieu d'inspection enregistré Maple Court, Central Park Reeds Crescent Watford Hertfordshire WD24 4QQ

    2 pagesAD03

    L'adresse d'inspection du registre a été modifiée à Maple Court, Central Park Reeds Crescent Watford Hertfordshire WD24 4QQ

    2 pagesAD02

    Changement d'adresse du siège social de Maple Court Central Park, Reeds Crescent Watford Herts WD24 4QQ à 1 More London Place London SE1 2AF le 27 août 2015

    2 pagesAD01

    Nomination d'un liquidateur volontaire

    2 pages600

    Résolutions

    Resolutions
    1 pagesRESOLUTIONS
    Résolutions
    CatégorieDateDescriptionType
    liquidation

    Résolution spéciale pour la liquidation au 13 août 2015

    LRESSP

    Déclaration de solvabilité

    3 pages4.70

    legacy

    1 pagesSH20

    État du capital au 23 juin 2015

    • Capital: GBP 1
    4 pagesSH19

    legacy

    1 pagesCAP-SS

    Résolutions

    Resolutions
    2 pagesRESOLUTIONS
    Résolutions
    CatégorieDateDescriptionType
    capital

    Résolution de réduction du capital social émis

    RES06

    Déclaration annuelle jusqu'au 03 juin 2015 avec liste complète des actionnaires

    6 pagesAR01
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    capital09 juin 2015

    État du capital au 09 juin 2015

    • Capital: GBP 14,000,200
    SH01

    Changement de nom ou de désignation de la catégorie d'actions

    2 pagesSH08

    Résolutions

    Resolutions
    4 pagesRESOLUTIONS
    Résolutions
    CatégorieDateDescriptionType
    capital

    Résolution de modification des droits ou de la dénomination des actions

    RES12
    capital

    Résolutions

    Re: co. Business 20/05/2015
    RES13

    Nomination de Mr James Owen Percival en tant qu'administrateur le 11 mars 2015

    2 pagesAP01

    Cessation de la nomination de Brian Wilson en tant que directeur le 11 mars 2015

    1 pagesTM01

    Nomination de Mr Brian Wilson en tant qu'administrateur le 13 févr. 2015

    2 pagesAP01

    Cessation de la nomination de Oded Lifschitz en tant que directeur le 13 févr. 2015

    1 pagesTM01

    Modification des coordonnées de l'administrateur Oded Lifschitz le 24 juin 2014

    2 pagesCH01

    Cessation de la nomination de Mark Jonathan Way en tant que directeur le 29 août 2014

    1 pagesTM01

    Comptes pour une société dormante établis au 31 déc. 2013

    10 pagesAA

    Cessation de la nomination de Elizabeth Jane Rabin en tant que directeur le 13 juin 2014

    1 pagesTM01

    Nomination de Mr. Stuart Beasley en tant qu'administrateur

    2 pagesAP01

    Déclaration annuelle jusqu'au 03 juin 2014 avec liste complète des actionnaires

    7 pagesAR01
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    capital20 juin 2014

    État du capital au 20 juin 2014

    • Capital: GBP 14,000,200
    SH01

    Qui sont les dirigeants de COMFORT LODGE LIMITED ?

    Dirigeants
    NomNommé leDate de démissionRôleAdresseIdentification de la sociétéPays de résidenceNationalitéDate de naissanceProfessionNuméro
    HLT SECRETARY LIMITED
    Maple Court
    Central Park, Reeds Crescent
    WD24 4QQ Watford
    Hertfordshire
    Secrétaire
    Maple Court
    Central Park, Reeds Crescent
    WD24 4QQ Watford
    Hertfordshire
    125128960001
    BEASLEY, Stuart
    Central Park
    Reeds Crescent
    WD24 4QQ Watford
    Maple Court
    Hertfordshire
    England
    Administrateur
    Central Park
    Reeds Crescent
    WD24 4QQ Watford
    Maple Court
    Hertfordshire
    England
    United KingdomBritishFinancial Controller188237620001
    PERCIVAL, James Owen
    Central Park
    Reeds Crescent
    WD24 4QQ Watford
    Maple Court
    Hertfordshire
    England
    Administrateur
    Central Park
    Reeds Crescent
    WD24 4QQ Watford
    Maple Court
    Hertfordshire
    England
    United KingdomBritishAccountant161274380001
    HUGHES, Barbara
    Flat 3
    11 Hazelmere Road
    NW6 6PY London
    Secrétaire
    Flat 3
    11 Hazelmere Road
    NW6 6PY London
    British45702460001
    WILSON, Brian
    Tudor Cottage
    70 High Street, Eaton Bray
    LU6 2DP Dunstable
    Secrétaire
    Tudor Cottage
    70 High Street, Eaton Bray
    LU6 2DP Dunstable
    British125151140001
    LADBROKE CORPORATE SECRETARIES LIMITED
    Maple Court Central Park
    Reeds Crescent
    WD24 4QQ Watford
    Hertfordshire
    Secrétaire
    Maple Court Central Park
    Reeds Crescent
    WD24 4QQ Watford
    Hertfordshire
    60530770001
    ANDREW, David
    Briarclough Cross Oak Road
    HP4 3NA Berkhamsted
    Hertfordshire
    Administrateur
    Briarclough Cross Oak Road
    HP4 3NA Berkhamsted
    Hertfordshire
    BritishCompany Director41761510002
    BAMSEY, John Anthony
    Cranley Road
    Burwood Park
    KT12 5BL Hersham
    Treetops 26
    Surrey
    Administrateur
    Cranley Road
    Burwood Park
    KT12 5BL Hersham
    Treetops 26
    Surrey
    EnglandBritishCompany Director130102260001
    BOULD, Christopher John
    The West Wing
    Pensax Court Pensax
    WR6 6XJ Worcester
    Worcestershire
    Administrateur
    The West Wing
    Pensax Court Pensax
    WR6 6XJ Worcester
    Worcestershire
    BritishSales Director110275470001
    BRADLEY, Adrian Paul
    The Spinney
    Misbourne Avenue
    SL9 0PF Chalfont St Peter
    Buckinghamshire
    Administrateur
    The Spinney
    Misbourne Avenue
    SL9 0PF Chalfont St Peter
    Buckinghamshire
    United KingdomBritishCompany Director90379240002
    DOBBS, John Anthony
    11a North Park Avenue
    LS8 1DN Leeds
    West Yorkshire
    Administrateur
    11a North Park Avenue
    LS8 1DN Leeds
    West Yorkshire
    BritishOperations Director120544260001
    FARROW, James Roger Charles
    7 Downham Place
    South Shore
    FY4 1PW Blackpool
    Lancashire
    Administrateur
    7 Downham Place
    South Shore
    FY4 1PW Blackpool
    Lancashire
    BritishSales & Marketing Director9585240001
    GOSLING, Peter Charles
    95 Worcester Road
    SM2 6QL Cheam
    Surrey
    Administrateur
    95 Worcester Road
    SM2 6QL Cheam
    Surrey
    EnglandEnglishCompany Director142633640001
    HARRIS, Anthony Richard
    43 Alma Square
    NW8 9PY London
    Administrateur
    43 Alma Square
    NW8 9PY London
    BritishHotelier64357620006
    HARVEY, Paul Victor
    Flat 2, The Cotton Mill
    35 King Street
    LE1 6RN Leicester
    Leicestershire
    Administrateur
    Flat 2, The Cotton Mill
    35 King Street
    LE1 6RN Leicester
    Leicestershire
    BritishAccountant116809270001
    HEARN, Grant David
    Bishops Platt
    Norlands Lane
    TW20 8SS Thorpe
    Surrey
    Administrateur
    Bishops Platt
    Norlands Lane
    TW20 8SS Thorpe
    Surrey
    United KingdomBritishManaging Director88628480001
    HIRST, Michael Barry
    16 Prowse Avenue
    Bushey
    WD2 1JR Watford
    Hertfordshire
    Administrateur
    16 Prowse Avenue
    Bushey
    WD2 1JR Watford
    Hertfordshire
    EnglandBritishCompany Director40994810001
    HUGHES-RIXHAM, Ian
    1 Grange Road
    HP23 5JP Tring
    Hertfordshire
    Administrateur
    1 Grange Road
    HP23 5JP Tring
    Hertfordshire
    BritishOperations Director143730250001
    HUGHES-RIXHAM, Ian
    1 Grange Road
    HP23 5JP Tring
    Hertfordshire
    Administrateur
    1 Grange Road
    HP23 5JP Tring
    Hertfordshire
    BritishOperations Director143730250001
    JONES, Annie Marie
    2 Lodge Close
    SL7 1RB Marlow
    Buckinghamshire
    Administrateur
    2 Lodge Close
    SL7 1RB Marlow
    Buckinghamshire
    United KingdomBritishHuman Resources Director162019090001
    LICHMAN, Laurence
    209 Merry Hill Road
    WD23 1AP Bushey
    Hertfordshire
    Administrateur
    209 Merry Hill Road
    WD23 1AP Bushey
    Hertfordshire
    BritishChartered Accountant143730380001
    LIFSCHITZ, Oded
    NW8 9RF London
    Flat 52, The Yoo Building
    England
    England
    Administrateur
    NW8 9RF London
    Flat 52, The Yoo Building
    England
    England
    United KingdomAustralian / IsraeliBusiness Executive172992020002
    LYLE, Gordon William
    Aragorn House
    Stylecroft Road
    HP8 4HZ Chalfont St. Giles
    Buckinghamshire
    Administrateur
    Aragorn House
    Stylecroft Road
    HP8 4HZ Chalfont St. Giles
    Buckinghamshire
    EnglandBritishCompany Director143730330001
    MAIDEN, George Barry
    Fourwinds Long Walk
    HP8 4AW Chalfont St Giles
    Buckinghamshire
    Administrateur
    Fourwinds Long Walk
    HP8 4AW Chalfont St Giles
    Buckinghamshire
    BritishChartered Accountant8832120001
    METCALFE, Michael Stuart
    Harwil 37 Howards Thicket
    SL9 7NT Gerrards Cross
    Buckinghamshire
    Administrateur
    Harwil 37 Howards Thicket
    SL9 7NT Gerrards Cross
    Buckinghamshire
    EnglandBritishOperations Director40294180002
    NEUMANN, Wolfgang
    Flat 4, 34 Holland Park
    W11 3TA London
    Administrateur
    Flat 4, 34 Holland Park
    W11 3TA London
    AustriaCompany Director87699600002
    PHILIP, John Crosbie
    Central Park
    Reeds Crescent
    WD24 4QQ Watford
    Maple Court
    Hertfordshire
    England
    Administrateur
    Central Park
    Reeds Crescent
    WD24 4QQ Watford
    Maple Court
    Hertfordshire
    England
    EnglandBritishVp Operations Central & North102495550001
    POTTER, Anthony Grahame
    Villa Sogno Fulmer Road
    SL9 7EG Gerrards Cross
    Buckinghamshire
    Administrateur
    Villa Sogno Fulmer Road
    SL9 7EG Gerrards Cross
    Buckinghamshire
    BritishCompany Director62316310001
    RABIN, Elizabeth Jane
    Central Park
    Reeds Crescent
    WD24 4QQ Watford
    Maple Court
    Hertfordshire
    England
    Administrateur
    Central Park
    Reeds Crescent
    WD24 4QQ Watford
    Maple Court
    Hertfordshire
    England
    EnglandBritishChartered Accountant125139540001
    ROGERS, John
    Central Park
    Reeds Crescent
    WD24 4QQ Watford
    Maple Court
    Hertfordshire
    England
    Administrateur
    Central Park
    Reeds Crescent
    WD24 4QQ Watford
    Maple Court
    Hertfordshire
    England
    EnglandBritishNone162807030001
    SHILL, Rosmarie
    The Old School
    High Street
    B95 5BN Henley In Arden
    Warwickshire
    Administrateur
    The Old School
    High Street
    B95 5BN Henley In Arden
    Warwickshire
    BritishCompany Director90162290001
    TALJAARD, Desmond Louis Mildmay
    59 Crescent West
    EN4 0EQ Hadley Wood
    Hertfordshire
    Administrateur
    59 Crescent West
    EN4 0EQ Hadley Wood
    Hertfordshire
    United KingdomBritishChartered Accountant215884620001
    TAYLOR, Hugh Matthew
    5 Amberden Avenue
    N3 3BJ London
    Administrateur
    5 Amberden Avenue
    N3 3BJ London
    United KingdomBritishOperations Vp For Southern Reg127621330001
    WAY, Mark Jonathan
    Central Park
    Reeds Crescent
    WD24 4QQ Watford
    Maple Court
    Hertfordshire
    England
    Administrateur
    Central Park
    Reeds Crescent
    WD24 4QQ Watford
    Maple Court
    Hertfordshire
    England
    United KingdomBritishChartered Accountant191239860001
    WILSON, Brian
    Central Park
    Reeds Crescent
    WD24 4QQ Watford
    Maple Court
    Hertfordshire
    England
    Administrateur
    Central Park
    Reeds Crescent
    WD24 4QQ Watford
    Maple Court
    Hertfordshire
    England
    United KingdomBritishCompany Secretary125151140001

    COMFORT LODGE LIMITED a-t-elle des procédures d'insolvabilité ?

    Numéro de dossierDatesTypePraticiensAutre
    1
    DateType
    12 juil. 2016Dissolved on
    13 août 2015Commencement of winding up
    Members voluntary liquidation
    NomRôleAdresseNommé leCessé le
    Samantha Keen
    1 More London Place
    SE1 2AF London
    practitioner
    1 More London Place
    SE1 2AF London
    Angela Swarbrick
    Ernst & Young Llp 1 More London Place
    SE1 2AF London
    practitioner
    Ernst & Young Llp 1 More London Place
    SE1 2AF London

    Source de données

    • Companies House du Royaume-Uni
      Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers.
    • Licence: CC0