MULGATE INVESTMENTS LIMITED

  • Vue d'ensemble
  • Résumé
  • Objet social
  • Adresse
  • Comptes
  • Dépôts
  • Dirigeants
  • Charges
  • Source de données
  • Vue d'ensemble

    Nom de la sociétéMULGATE INVESTMENTS LIMITED
    Statut de la sociétéDissoute
    Forme juridiqueSociété à responsabilité limitée
    Numéro de société 00809506
    JuridictionAngleterre/Pays de Galles
    Date de création
    Date de cessation d'activité

    Résumé

    A des PSCs super sécurisésNon
    A des chargesOui
    A un historique d'insolvabilitéNon
    Le siège social est contestéNon

    Quel est l'objet de MULGATE INVESTMENTS LIMITED ?

    • Développement de projets de construction (41100) / Construction
    • Achat et vente de biens immobiliers propres (68100) / Activités immobilières

    Où se situe MULGATE INVESTMENTS LIMITED ?

    Adresse du siège social
    5 Wigmore Street
    London
    W1U 1PB
    Adresse du siège social non livrableNon

    Quels sont les derniers comptes de MULGATE INVESTMENTS LIMITED ?

    Derniers comptes
    Derniers comptes arrêtés au31 mars 2012

    Quels sont les derniers dépôts pour MULGATE INVESTMENTS LIMITED ?

    Dépôts
    DateDescriptionDocumentType

    Bulletin officiel final dissous par radiation volontaire

    1 pagesGAZ2(A)

    Premier avis au Bulletin officiel pour la radiation volontaire

    1 pagesGAZ1(A)

    Demande de radiation de la société du registre du commerce

    2 pagesDS01

    Déclaration annuelle jusqu'au 24 août 2013 avec liste complète des actionnaires

    6 pagesAR01
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    capital02 sept. 2013

    État du capital au 02 sept. 2013

    • Capital: GBP 5,000,000
    SH01

    Comptes annuels établis au 31 mars 2012

    13 pagesAA

    Déclaration annuelle jusqu'au 24 août 2012 avec liste complète des actionnaires

    6 pagesAR01

    Comptes annuels établis au 31 mars 2011

    16 pagesAA

    La procédure de radiation d'office a été abandonnée

    1 pagesDISS40

    Déclaration annuelle jusqu'au 24 août 2011

    6 pagesAR01

    Comptes annuels établis au 31 mars 2010

    16 pagesAA

    Déclaration annuelle jusqu'au 24 août 2010

    6 pagesAR01

    Comptes annuels établis au 31 mars 2009

    15 pagesAA

    Premier avis au Bulletin officiel pour la radiation d'office

    1 pagesGAZ1

    Modification des coordonnées de l'administrateur Christopher George White le 01 mai 2010

    3 pagesCH01

    Modification des coordonnées de l'administrateur Mr Maurice Moses Benady le 01 mai 2010

    3 pagesCH01

    Comptes annuels établis au 31 mars 2008

    17 pagesAA

    legacy

    4 pages363a

    legacy

    1 pages288b

    legacy

    2 pages288a

    legacy

    4 pages288a

    legacy

    4 pages288a

    Résolutions

    Resolutions
    1 pagesRESOLUTIONS
    Résolutions
    CatégorieDateDescriptionType
    capital

    Résolutions

    Auth dirs re sect 175(5)a of ca 2006 10/11/2008
    RES13

    Résolutions

    Resolutions
    1 pagesRESOLUTIONS
    Résolutions
    CatégorieDateDescriptionType
    capital

    Résolutions

    Auth dirs re sect 175(5)a of ca 2006 10/11/2008
    RES13

    Résolutions

    Resolutions
    1 pagesRESOLUTIONS
    Résolutions
    CatégorieDateDescriptionType
    capital

    Résolution d'autorisation d'achat d'un certain nombre d'actions

    RES09

    Résolutions

    Resolutions
    4 pagesRESOLUTIONS
    Résolutions
    CatégorieDateDescriptionType
    capital

    Résolutions

    Auth dirs re sect 175(5)a of ca 2006 10/11/2008
    RES13
    incorporation

    Résolution de modification des statuts

    RES01

    Qui sont les dirigeants de MULGATE INVESTMENTS LIMITED ?

    Dirigeants
    NomNommé leDate de démissionRôleAdresseIdentification de la sociétéPays de résidenceNationalitéDate de naissanceProfessionNuméro
    REIT (CORPORATE SERVICES) LIMITED
    5 Wigmore Street
    W1U 1PB London
    Secrétaire
    5 Wigmore Street
    W1U 1PB London
    79571870001
    BENADY, Maurice Moses
    Line Wall Road
    Gibraltar
    57/63
    Gibraltar
    Administrateur
    Line Wall Road
    Gibraltar
    57/63
    Gibraltar
    GibraltarBritish69435160001
    WHITE, Christopher George
    Line Wall Road
    Gibraltar
    57/63
    Gibraltar
    Administrateur
    Line Wall Road
    Gibraltar
    57/63
    Gibraltar
    GibraltarBritish80132540006
    TRAFALGAR OFFICERS LIMITED
    Wigmore Street
    W1U 1PB London
    3rd Floor 5
    Administrateur
    Wigmore Street
    W1U 1PB London
    3rd Floor 5
    135415010001
    CURTIS, Ernest Leonard
    Cedar Lodge
    Greenfield Lane Hawksworth Guiseley
    LS20 8HF Leeds
    West Yorkshire
    Secrétaire
    Cedar Lodge
    Greenfield Lane Hawksworth Guiseley
    LS20 8HF Leeds
    West Yorkshire
    British19382660001
    GIBSON, William Mcaulay
    Ivy Bank
    1 Easby Drive
    LS29 9BE Ilkley
    West Yorkshire
    Secrétaire
    Ivy Bank
    1 Easby Drive
    LS29 9BE Ilkley
    West Yorkshire
    British5387660001
    GILBERT, Nicholas Jay
    Woodville
    14 Carlton Park Avenue
    WF8 3HQ Pontefract
    West Yorkshire
    Secrétaire
    Woodville
    14 Carlton Park Avenue
    WF8 3HQ Pontefract
    West Yorkshire
    British81344240001
    JOBBINS, Stuart
    16 Riverside Avenue
    LS21 2RT Otley
    West Yorkshire
    Secrétaire
    16 Riverside Avenue
    LS21 2RT Otley
    West Yorkshire
    British108146440001
    MILLINGTON, Paul Terence
    2a Gilleyfield Avenue
    Dore
    S17 3NS Sheffield
    Secrétaire
    2a Gilleyfield Avenue
    Dore
    S17 3NS Sheffield
    British58693930003
    BELL, John Drummond
    Gates Garth
    49 Rutland Drive
    HG1 2NX Harrogate
    North Yorkshire
    Administrateur
    Gates Garth
    49 Rutland Drive
    HG1 2NX Harrogate
    North Yorkshire
    United KingdomBritish63940900001
    BELL, John Drummond
    Gates Garth
    49 Rutland Drive
    HG1 2NX Harrogate
    North Yorkshire
    Administrateur
    Gates Garth
    49 Rutland Drive
    HG1 2NX Harrogate
    North Yorkshire
    United KingdomBritish63940900001
    BEST, George Laidler
    Kiddall Hall Farm
    York Road Barwick In Elmet
    LS14 3AE Leeds
    West Yorkshire
    Administrateur
    Kiddall Hall Farm
    York Road Barwick In Elmet
    LS14 3AE Leeds
    West Yorkshire
    British2748600001
    CULL, David Geoffrey Maurice
    8 Centennial Court
    High Street
    WD3 1AW Rickmansworth
    Hertfordshire
    Administrateur
    8 Centennial Court
    High Street
    WD3 1AW Rickmansworth
    Hertfordshire
    British84076630001
    CURTIS, Ernest Leonard
    Cedar Lodge
    Greenfield Lane Hawksworth Guiseley
    LS20 8HF Leeds
    West Yorkshire
    Administrateur
    Cedar Lodge
    Greenfield Lane Hawksworth Guiseley
    LS20 8HF Leeds
    West Yorkshire
    British19382660001
    EVANS, Andreas Frederick
    Leathley Grange
    LS21 2LA Leathley
    North Yorkshire
    Administrateur
    Leathley Grange
    LS21 2LA Leathley
    North Yorkshire
    United KingdomBritish9485290003
    EVANS, Dominic Redvers
    Pine Lodge
    9 Sandmoor Avenue
    LS17 7DW Leeds
    West Yorkshire
    Administrateur
    Pine Lodge
    9 Sandmoor Avenue
    LS17 7DW Leeds
    West Yorkshire
    British7095590001
    EVANS, Frederick Redvers
    16 Sandmoor Drive
    LS17 7DG Leeds
    West Yorkshire
    Administrateur
    16 Sandmoor Drive
    LS17 7DG Leeds
    West Yorkshire
    British4409160001
    EVANS, Roderick Michael
    Oakhill House
    Roundhay Park Lane
    LS17 8AR Leeds
    Administrateur
    Oakhill House
    Roundhay Park Lane
    LS17 8AR Leeds
    British40175270002
    GIBSON, William Mcaulay
    Ivy Bank
    1 Easby Drive
    LS29 9BE Ilkley
    West Yorkshire
    Administrateur
    Ivy Bank
    1 Easby Drive
    LS29 9BE Ilkley
    West Yorkshire
    British5387660001
    HELLIWELL, David Alistair
    8 Farndale Close
    Spofforth Hill
    LS22 4XE Wetherby
    West Yorkshire
    Administrateur
    8 Farndale Close
    Spofforth Hill
    LS22 4XE Wetherby
    West Yorkshire
    EnglandBritish15578740001
    HORSBROUGH, Pauline Elizabeth
    30 The Orchard
    Wrenthorpe
    WF2 0LL Wakefield
    West Yorkshire
    Administrateur
    30 The Orchard
    Wrenthorpe
    WF2 0LL Wakefield
    West Yorkshire
    United KingdomBritish4961270001
    MCKENDRICK, Charles
    St Anns Main Street
    LS22 5EB Kirk Deighton
    North Yorkshire
    Administrateur
    St Anns Main Street
    LS22 5EB Kirk Deighton
    North Yorkshire
    United KingdomBritish173983190001
    MILLINGTON, Paul Terence
    2a Gilleyfield Avenue
    Dore
    S17 3NS Sheffield
    Administrateur
    2a Gilleyfield Avenue
    Dore
    S17 3NS Sheffield
    United KingdomBritish58693930003
    SYERS, Alan Matthew
    135 Temple Lane
    Copmanthorpe
    YO23 3TE York
    North Yorkshire
    Administrateur
    135 Temple Lane
    Copmanthorpe
    YO23 3TE York
    North Yorkshire
    EnglandBritish65588650002
    TURNER, Philip Arthur
    Red Roofs 2 Mulberry Garth
    Thorp Arch
    LS23 7AF Wetherby
    West Yorkshire
    Administrateur
    Red Roofs 2 Mulberry Garth
    Thorp Arch
    LS23 7AF Wetherby
    West Yorkshire
    British66424440001
    REIT(CORPORATE DIRECTORS) LIMITED
    5 Wigmore Street
    W1U 1PB London
    Administrateur
    5 Wigmore Street
    W1U 1PB London
    74030120002

    MULGATE INVESTMENTS LIMITED a-t-elle des charges ?

    Charges
    ClassificationDatesStatutDétails
    Security agreement
    Créé le 19 sept. 2007
    Livré le 26 sept. 2007
    En cours
    Montant garanti
    All monies due or to become due from each obligor to any finance party on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Eurohypo Ag,London Branch
    Transactions
    • 26 sept. 2007Enregistrement d'une charge (395)
    Sixth supplemental trust deed
    Créé le 14 juin 2005
    Livré le 01 juil. 2005
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    £100,000,000 and all other monies due or to become due under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    Property k/a sinfin lane industrial estate, sinfin, derbyshire t/no's DY361077 and DY22024 together with all buildings and erections and fixtures (including trade fixtures) and fittings and fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • The Law Debenture Trust Corporation P.L.C
    Transactions
    • 01 juil. 2005Enregistrement d'une charge (395)
    • 27 avr. 2007Déclaration que tout ou partie de la propriété d'une charge flottante a été libérée (403b)
    • 29 sept. 2007Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Supplemental legal mortgage to composite guarantee and debenture dated 27 may 1999
    Créé le 28 mars 2003
    Livré le 09 avr. 2003
    En cours
    Montant garanti
    All monies,obligations and liabilities due or to become due from the obligors or any of them to any of the beneficiaries under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    F/Hold land on north west side of sinfin lane,derby; DY22024 with all buildings and fixtures thereon.
    Personnes ayant droit
    • National Westminster Bank PLC as Security Agent for Itself and the Beneficiaries
    Transactions
    • 09 avr. 2003Enregistrement d'une charge (395)
    Supplemental legal mortgage to composite guarantee and debenture dated 27 may 1999
    Créé le 28 janv. 2002
    Livré le 06 févr. 2002
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    The freehold land known as dollis hill research station t/no. MX122172 and the freehold land known as land and buildings on the west side of stoneferry road, kingston upon hull t/no. HS125192. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • National Westminster Bank PLC as Security Agent and Trustee for Itself and the Beneficiaries
    Transactions
    • 06 févr. 2002Enregistrement d'une charge (395)
    • 29 sept. 2007Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Deed of release and substitution
    Créé le 06 août 1999
    Livré le 11 août 1999
    En cours
    Montant garanti
    The principal of and interest on the £100,000,000 11% first mortgage debenture stock 2025 of evans of leeds limited (formerly evan of leeds PLC) and all other monies intended to be secured by a trust deed dated 20 september 1985 and deeds supplemental thereto (as defined)
    Brèves mentions
    Dollis hill estate brook road dollis hill london t/n-MX122172 together with all buildings and erections or fixtures (including trade fixtures) and fittings and fixed plant and machinery for the time being thereon,. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • The Law Debenture Trust Corporation P.L.C.
    Transactions
    • 11 août 1999Enregistrement d'une charge (395)
    • 27 avr. 2007Déclaration que tout ou partie de la propriété d'une charge flottante a été libérée (403b)
    • 10 août 2007Déclaration que tout ou partie de la propriété d'une charge flottante a été libérée (403b)
    Deed of accession (supplemental to a composite guarantee and mortgage debenture dated 27 may 1999)
    Créé le 03 août 1999
    Livré le 16 août 1999
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies obligations and liabilities due owing or incurred by the obligors (as defined) or any of them to any of the beneficiaries (as defined) including all monies obligations and liabilities due owing or incurred by the obligors or any of them to any of the beneficiaries under or in connection with the finance documents (as defined) (or any of them) and/or on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • National Westminster Bank PLC
    Transactions
    • 16 août 1999Enregistrement d'une charge (395)
    • 27 août 1999Déclaration que tout ou partie de la propriété d'une charge flottante a été libérée (403b)
    • 04 déc. 1999Déclaration que tout ou partie de la propriété d'une charge flottante a été libérée (403b)
    • 21 juin 2000Déclaration que tout ou partie de la propriété d'une charge flottante a été libérée (403b)
    • 29 sept. 2007Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Legal mortgage
    Créé le 06 janv. 1999
    Livré le 08 janv. 1999
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company and/or evans of leeds PLC to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Dollis hill research station l/b brent-MX122172. Assigns the goodwill of all businesses from time to time carried on at the property with the benefit of all authorisations permits registration certificates or licences of any kind also by way of fixed charge the equipment and goods (if any) and all other fixtures fittings plant and machinery and by way of floating charge on other moveable plant machinery furniture equipment goods and other effects which from time to time on the property.
    Personnes ayant droit
    • Yorkshire Bank PLC
    Transactions
    • 08 janv. 1999Enregistrement d'une charge (395)
    • 23 juil. 1999Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Deed of release & substitution
    Créé le 18 sept. 1997
    Livré le 22 sept. 1997
    En cours
    Montant garanti
    The principal of and interest on the £100,000,000 11% first mortgage debenture stock 2025 of evans of leeds PLC and all other monies intended to be secured by a trust deed dated 20 september 1985 and deeds supplemental thereto
    Brèves mentions
    Land at 9 grape lane york t/n NYK191013 together with all buildings erections fixtures (including trade fixtures) and fittings and fixed plant and machinery thereon.
    Personnes ayant droit
    • The Law Debenture Trust Corporation P.L.C.
    Transactions
    • 22 sept. 1997Enregistrement d'une charge (395)
    • 21 juin 2000Déclaration que tout ou partie de la propriété d'une charge flottante a été libérée (403b)
    • 27 avr. 2007Déclaration que tout ou partie de la propriété d'une charge flottante a été libérée (403b)
    Deed of release and substitution
    Créé le 20 sept. 1996
    Livré le 24 sept. 1996
    En cours
    Montant garanti
    The principal amount of the original stock and the new stock together with interest arising under a trust deed dated 20TH september 1985,a deed of release and substitution dated 7TH april 1988,a first supplemental trust deed dated 1ST february 1989,a deed of release dated 29TH march 1989,a second supplemental trust deed dated 4TH december 1992,a third supplemental trust deed dated 4TH november 1993,a deed of release and substitution dated 29TH september 1994,a deed of confirmation dated 17TH november 1994,a deed of release dated 12TH july 1995,a deed of release and substitution dated 26TH september 1995 and a deed of release dated 21ST june 1996 together constituting and securing £100,000,000 11 per cent first mortgage debenture stock 2025.
    Brèves mentions
    F/H land and buildings k/a 34 to 42 even and 42A and 42B washway road and oaklands house oaklands drive sale t/n GM478629.
    Personnes ayant droit
    • The Law Debenture Trust Corporation PLC
    Transactions
    • 24 sept. 1996Enregistrement d'une charge (395)
    • 27 avr. 2007Déclaration que tout ou partie de la propriété d'une charge flottante a été libérée (403b)
    Memorandum of deposit
    Créé le 08 sept. 1995
    Livré le 25 sept. 1995
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee as security trustee under the loan agreement (as defined) and the memorandum of deposit
    Brèves mentions
    Land and buildings k/a 9 grape lane york t/n NYK30372 with all fixtures fittings plant and machinery.
    Personnes ayant droit
    • Midland Bank PLC
    Transactions
    • 25 sept. 1995Enregistrement d'une charge (395)
    • 28 juil. 1998Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Memorandum of deposit
    Créé le 08 sept. 1995
    Livré le 25 sept. 1995
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee as security trustee under the loan agreement (as defined) and this memorandum of deposit
    Brèves mentions
    Land and buildings k/a 7 colliergate york t/n NYK56126 with title absolute with all fixtures and fittings.
    Personnes ayant droit
    • Midland Bank PLC
    Transactions
    • 25 sept. 1995Enregistrement d'une charge (395)
    • 28 juil. 1998Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Third supplemental trust deed
    Créé le 04 nov. 1993
    Livré le 19 nov. 1993
    En cours
    Montant garanti
    £100,000,000 (being the aggregate principal amount of the original stock and the new stock) 11% first mortgage debenture stock 2025 and all other monies due under the terms of the principal trust deed and deeds supplemental thereto
    Brèves mentions
    Various properties as specified in form 395. see the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • The Law Debenture Trust Corporation
    Transactions
    • 19 nov. 1993Enregistrement d'une charge (395)
    • 10 août 2007Déclaration que tout ou partie de la propriété d'une charge flottante a été libérée (403b)
    Memorandum of deposit
    Créé le 22 janv. 1993
    Livré le 03 févr. 1993
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the loan agreement of even date
    Brèves mentions
    Land and buildings k/a 7 colliergate york t/n nyk 56126 and land and buildings k/a 9 grape lane york t/n nyk 30372.
    Personnes ayant droit
    • Midland Bank PLC as Security Trustee for Itself the Banks the Agents and Arranger
    Transactions
    • 03 févr. 1993Enregistrement d'une charge (395)
    • 07 juil. 1995Déclaration que tout ou partie de la propriété d'une charge flottante a été libérée (403b)
    • 07 juil. 1995Déclaration que tout ou partie de la propriété d'une charge flottante a été libérée (403b)
    • 27 juil. 1999Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Second supplemental trust deed
    Créé le 04 déc. 1992
    Livré le 08 déc. 1992
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    £87,000,000 11% first mortgage debenture stock 2025 and all other monies due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee under the terms of the charge
    Brèves mentions
    Various properties as specified in form 395 ref M655C.
    Personnes ayant droit
    • The Law Debenture Trust PLC
    Transactions
    • 08 déc. 1992Enregistrement d'une charge (395)
    • 28 juil. 1998Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    • 28 juil. 1998Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    • 28 juil. 1998Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    • 27 juil. 1999Déclaration que tout ou partie de la propriété d'une charge flottante a été libérée (403b)
    • 17 août 1999Déclaration que tout ou partie de la propriété d'une charge flottante a été libérée (403b)
    • 17 août 1999Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Memorandum of equitable charge
    Créé le 07 janv. 1992
    Livré le 09 janv. 1992
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All moneys due or to become due from the company to the chargee under the terms of the loan agreement dated 7TH december 1988 and this charge
    Brèves mentions
    Land and buildings on north west side of sinfin lane, derby comprising the whole of the property registered at h m land registry under t/n dy 30545. land lying to the north of wordsworth avenue derby comprising the whole of the property registered at H.M. land registry under t/ndy 215291.
    Personnes ayant droit
    • Midland Bank Plcas Security Trustee for the Banks
    Transactions
    • 09 janv. 1992Enregistrement d'une charge (395)
    • 15 janv. 1993Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Memerandum of equitable & charge
    Créé le 04 mars 1991
    Livré le 09 mars 1991
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee as security trustee for the banks (as defined therein) under the loan ageement and under the terms of the charge.
    Brèves mentions
    F/H land & buildings on the east side of walney road barrow in furness, cumbria title no:- cu 6053.
    Personnes ayant droit
    • Midland Bank PLC
    Transactions
    • 09 mars 1991Enregistrement d'une charge
    • 15 janv. 1993Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Memerandum of equitable charge
    Créé le 27 oct. 1989
    Livré le 08 nov. 1989
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee as security trustee for the banks (as defined) under the terms of a loan agreement dated 7/12/88
    Brèves mentions
    F/H land situate to the north east of low lane horsforth title no wyk 269133 including all fixtures fitings (other than trade fixtures & fittings plant & machinery (see from 395 for full details).
    Personnes ayant droit
    • Midland Bank PLC
    Transactions
    • 08 nov. 1989Enregistrement d'une charge
    • 15 janv. 1993Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Memarandum of equitable charge
    Créé le 27 oct. 1989
    Livré le 30 oct. 1989
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee as security trustee for the banks (as defined therein) under a loan agreement dated 7/12/88 and amended by a first supplemented agreement dated 23/1/89 under the terms of the charge
    Brèves mentions
    F/H land situate to the south of feltham rd, ashford, surrey title no:- sy 479887 (including all fixtures fittings other than trade fixtures fittings & including the benifit of all agreements (see from 395 for full details).
    Personnes ayant droit
    • Midland Bank PLC
    Transactions
    • 30 oct. 1989Enregistrement d'une charge
    • 13 déc. 1991Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Memorandum of equitable charge
    Créé le 17 févr. 1989
    Livré le 20 févr. 1989
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of a loan agreement dated 7/12/88 and the charge
    Brèves mentions
    All the property listed on the schedule including fixtures fittings plant and machinery (see from 395 for full details).
    Personnes ayant droit
    • Midland Bank Plcas Security Trustee for the Banks
    Transactions
    • 20 févr. 1989Enregistrement d'une charge
    • 14 nov. 1991Déclaration que tout ou partie de la propriété d'une charge flottante a été libérée (403b)
    • 15 janv. 1993Déclaration que tout ou partie de la propriété d'une charge flottante a été libérée (403b)
    • 21 août 2002Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Memerandum & equitable charge
    Créé le 07 déc. 1988
    Livré le 13 déc. 1988
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of a loan agreement dated 7/12/88 and the charge
    Brèves mentions
    All the property listed on the schedule including fixtures fittings plant and machinary (see from 395 for full details).
    Personnes ayant droit
    • Midland Bank Plcas Security Trustee for the Banks
    Transactions
    • 13 déc. 1988Enregistrement d'une charge
    • 11 mai 1992Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Deed of release and substitution
    Créé le 07 avr. 1988
    Livré le 08 avr. 1988
    En cours
    Montant garanti
    Original stock created by a trust deed dated 20 september 1985
    Brèves mentions
    Roman house, sittingbourne, kent title no 4568386.
    Personnes ayant droit
    • The Law Debenture Trust Corporation PLC
    Transactions
    • 08 avr. 1988Enregistrement d'une charge
    • 27 juil. 1999Déclaration que tout ou partie de la propriété d'une charge flottante a été libérée (403b)
    • 27 avr. 2007Déclaration que tout ou partie de la propriété d'une charge flottante a été libérée (403b)
    Trust deed
    Créé le 20 sept. 1985
    Livré le 08 oct. 1985
    En cours
    Montant garanti
    Sterling pounds 12,000,000 11% first mortgate debenture stock 2025 of evans of leeds PLC and other moneys payable pursuant to the trust deed or intended to be secured thereby
    Brèves mentions
    Premises adjoining brook road, dollis hill, willesdon NW2 l/b of brent title no mx 122172 premises at feltham road, ashford, surrey title no. Sy 479887 premises at low lane, horsforth, leeds. Title no. Wyk 269133 (see doc M41 for full details) together with all buildings and erections and fixtures (including trade fixtures) and fittings, fixed plant and machinery thereon.
    Personnes ayant droit
    • The Law Debenture Trust Corporation PLC
    Transactions
    • 08 oct. 1985Enregistrement d'une charge
    • 02 oct. 1995Déclaration que tout ou partie de la propriété d'une charge flottante a été libérée (403b)
    • 27 juil. 1999Déclaration que tout ou partie de la propriété d'une charge flottante a été libérée (403b)
    • 27 juil. 1999Déclaration que tout ou partie de la propriété d'une charge flottante a été libérée (403b)
    • 27 juil. 1999Déclaration que tout ou partie de la propriété d'une charge flottante a été libérée (403b)
    • 30 janv. 2002Déclaration que tout ou partie de la propriété d'une charge flottante a été libérée (403b)
    • 27 avr. 2007Déclaration que tout ou partie de la propriété d'une charge flottante a été libérée (403b)
    • 10 août 2007Déclaration que tout ou partie de la propriété d'une charge flottante a été libérée (403b)
    Legal charge
    Créé le 13 avr. 1973
    Livré le 17 avr. 1973
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from evans of leeds LTD on any account whatsoever.
    Brèves mentions
    64 and 66 vicar lane no 6 and 8 sydney st no 5 & 7 hanwood st leeds.
    Personnes ayant droit
    • Yorkshire Bank LTD
    Transactions
    • 17 avr. 1973Enregistrement d'une charge
    • 18 oct. 1992Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Legal charge
    Créé le 13 avr. 1973
    Livré le 17 janv. 1973
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from evans of leeds LTD to yorkshire bank LTD. On any account whatsoever.
    Brèves mentions
    Land containing 97 sq. Yards or thereabouts in vicar lane leeds no 60 and 62 vicar lane leeds.
    Personnes ayant droit
    • Yorkshire Bank LTD
    Transactions
    • 17 janv. 1973Enregistrement d'une charge
    • 18 oct. 1992Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)

    Source de données

    • Companies House du Royaume-Uni
      Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers.
    • Licence: CC0