FURLONG HOTELS LIMITED

  • Vue d'ensemble
  • Résumé
  • Objet social
  • Adresse
  • Dénominations sociales précédentes
  • Comptes
  • Bilan annuel
  • Dépôts
  • Dirigeants
  • Charges
  • Insolvabilité
  • Source de données
  • Vue d'ensemble

    Nom de la sociétéFURLONG HOTELS LIMITED
    Statut de la sociétéDissoute
    Forme juridiqueSociété à responsabilité limitée
    Numéro de société 00809652
    JuridictionAngleterre/Pays de Galles
    Date de création
    Date de cessation d'activité

    Résumé

    A des PSCs super sécurisésNon
    A des chargesOui
    A un historique d'insolvabilitéOui
    Le siège social est contestéNon

    Quel est l'objet de FURLONG HOTELS LIMITED ?

    • Hôtels et hébergement similaire (55100) / Hébergement et restauration

    Où se situe FURLONG HOTELS LIMITED ?

    Adresse du siège social
    c/o DUFF & PHELPS LTD.
    The Shard
    32 London Bridge Street
    SE1 9SG London
    England
    Adresse du siège social non livrableNon

    Quels étaient les noms précédents de FURLONG HOTELS LIMITED ?

    Dénominations sociales précédentes
    Nom de la sociétéDeJusqu'au
    HOMEWOOD PARK HOTEL LIMITED09 juil. 199009 juil. 1990
    MANOR HOUSE HOTEL (MORETON) LIMITED(THE)18 juin 196418 juin 1964

    Quels sont les derniers comptes de FURLONG HOTELS LIMITED ?

    Derniers comptes
    Derniers comptes arrêtés au31 déc. 2012

    Quel est le statut du dernier bilan annuel pour FURLONG HOTELS LIMITED ?

    Bilan annuel
    Dernier bilan annuel

    Quels sont les derniers dépôts pour FURLONG HOTELS LIMITED ?

    Dépôts
    DateDescriptionDocumentType

    Gazette finale dissoute à la suite d'une liquidation

    1 pagesGAZ2

    Avis de transition de l'administration à la dissolution le 10 sept. 2015

    79 pages2.35B

    Rapport d'avancement de l'administrateur jusqu'à 08 juin 2015

    72 pages2.24B

    Rapport d'avancement de l'administrateur jusqu'à 08 déc. 2014

    66 pages2.24B

    Avis de nomination d'un administrateur de remplacement/supplémentaire

    1 pages2.40B

    Avis de vacance de poste par l'administrateur

    19 pages2.39B

    Avis de vacance de poste par l'administrateur

    19 pages2.39B

    Avis d'approbation réputée des propositions

    1 pagesF2.18

    Déclaration de la proposition de l'administrateur

    220 pages2.17B

    Déclaration des affaires avec le formulaire 2.14B

    6 pages2.16B

    Changement d'adresse du siège social de C/O C/O Duff & Phelps Ltd. Level 14, the Shard 32 London Bridge Street London SE1 9SG England à C/O Duff & Phelps Ltd. the Shard 32 London Bridge Street London SE1 9SG le 26 sept. 2014

    1 pagesAD01

    Nomination d'un administrateur

    1 pages2.12B

    Changement d'adresse du siège social de New Kings Court Tollgate Chandler's Ford Eastleigh Hampshire SO53 3LG United Kingdom à C/O Duff & Phelps Ltd. the Shard 32 London Bridge Street London SE1 9SG le 15 sept. 2014

    1 pagesAD01

    Changement d'adresse du siège social de New Kings Court Tollgate Chandler's Ford Eastleigh Hampshire SO15 3LG à New Kings Court Tollgate Chandler's Ford Eastleigh Hampshire SO53 3LG le 04 sept. 2014

    1 pagesAD01

    Cessation de la nomination de Michael Edward Jourdain en tant que directeur le 01 août 2014

    1 pagesTM01

    Cessation de la nomination de Peter Procopis en tant que directeur le 01 août 2014

    1 pagesTM01

    Nomination de Mr Declan Mckelvey en tant qu'administrateur le 01 août 2014

    2 pagesAP01

    Changement d'adresse du siège social de * Bond Street House 14 Clifford Street London W1S 4JU* le 18 juin 2014

    2 pagesAD01

    Déclaration annuelle jusqu'au 30 nov. 2013 avec liste complète des actionnaires

    5 pagesAR01
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    capital02 janv. 2014

    État du capital au 02 janv. 2014

    • Capital: GBP 200
    SH01

    Cessation de la nomination de David Kaye en tant que secrétaire

    1 pagesTM02

    Cessation de la nomination de David Kaye en tant que directeur

    1 pagesTM01

    Comptes annuels établis au 31 déc. 2012

    20 pagesAA

    Déclaration annuelle jusqu'au 30 nov. 2012 avec liste complète des actionnaires

    6 pagesAR01

    Comptes annuels établis au 31 déc. 2011

    18 pagesAA

    Déclaration annuelle jusqu'au 30 nov. 2011 avec liste complète des actionnaires

    6 pagesAR01

    Qui sont les dirigeants de FURLONG HOTELS LIMITED ?

    Dirigeants
    NomNommé leDate de démissionRôleAdresseIdentification de la sociétéPays de résidenceNationalitéDate de naissanceProfessionNuméro
    MCKELVEY, Declan
    Melrose Court
    Lincoln Road
    SK9 2HD Wilmslow
    1
    Cheshire
    England
    Administrateur
    Melrose Court
    Lincoln Road
    SK9 2HD Wilmslow
    1
    Cheshire
    England
    EnglandIrish172282530001
    FENTUM, Linda May
    Rudge Hill House
    Rudge
    BA11 2QG Frome
    Somerset
    Secrétaire
    Rudge Hill House
    Rudge
    BA11 2QG Frome
    Somerset
    British20359230007
    KAYE, David Robert
    14 Clifford Street
    W1S 4JU London
    Bond Street House
    Secrétaire
    14 Clifford Street
    W1S 4JU London
    Bond Street House
    British136564620002
    LANGRIDGE, Megan Joy
    42 Everest Drive
    Hoo St Werburgh
    ME3 9AW Rochester
    Kent
    Secrétaire
    42 Everest Drive
    Hoo St Werburgh
    ME3 9AW Rochester
    Kent
    British86459820005
    GRAVITAS COMPANY SECRETARIAL SERVICES LIMITED
    110 Cannon Street
    EC4N 6AR London
    Secrétaire
    110 Cannon Street
    EC4N 6AR London
    48725320001
    CAMPBELL, Colin John
    25 Wycombe End
    HP9 1LZ Beaconsfield
    Buckinghamshire
    Administrateur
    25 Wycombe End
    HP9 1LZ Beaconsfield
    Buckinghamshire
    British99161140001
    FENTUM, Haydn Herbert James
    The Priory
    Church Street Offenham
    WR11 8RW Evesham
    Worcestershire
    Administrateur
    The Priory
    Church Street Offenham
    WR11 8RW Evesham
    Worcestershire
    EnglandBritish98036330001
    FENTUM, Linda May
    Rudge Hill House
    Rudge
    BA11 2QG Frome
    Somerset
    Administrateur
    Rudge Hill House
    Rudge
    BA11 2QG Frome
    Somerset
    British20359230007
    FENTUM, Michael Herbert
    Rudge Hill House
    Rudge
    BA11 2QG Frome
    Somerset
    Administrateur
    Rudge Hill House
    Rudge
    BA11 2QG Frome
    Somerset
    British45168680006
    GUEUNING, Frank Edward
    Homewood Park Hotel
    Hinton Charterhouse
    BA3 6BB Bath
    Avon
    Administrateur
    Homewood Park Hotel
    Hinton Charterhouse
    BA3 6BB Bath
    Avon
    Belgian20359250002
    HAWKSWORTH, James William
    Blakeys Crossing
    DN14 7GE Howden
    29
    East Yorkshire
    Administrateur
    Blakeys Crossing
    DN14 7GE Howden
    29
    East Yorkshire
    EnglandBritish202241030001
    JOURDAIN, Michael Edward
    The Sticks
    Hatchgate Lane
    RH17 5DU Cuckfield
    Sussex
    Administrateur
    The Sticks
    Hatchgate Lane
    RH17 5DU Cuckfield
    Sussex
    EnglandBritish58412670001
    KAYE, David Robert
    14 Clifford Street
    W1S 4JU London
    Bond Street House
    England
    Administrateur
    14 Clifford Street
    W1S 4JU London
    Bond Street House
    England
    United KingdomBritish110817160002
    MARCOVECCHIO, Massimo Mario
    27 Manor Wood Road
    CR8 4LG Purley
    Surrey
    Administrateur
    27 Manor Wood Road
    CR8 4LG Purley
    Surrey
    United KingdomBritish75936930001
    PAISNER, Jonathan Samuel
    Bond Street House
    14 Clifford Street
    W1S 4JU London
    Administrateur
    Bond Street House
    14 Clifford Street
    W1S 4JU London
    United KingdomBritish78399950005
    PROCOPIS, Peter
    7a Lauderdale Road
    W9 1LT London
    Administrateur
    7a Lauderdale Road
    W9 1LT London
    United KingdomAustralian66047970002
    ROGERS, Paul
    Ash Barton
    20 The Ridgeway
    WD7 8PR Radlett
    Hertfordshire
    Administrateur
    Ash Barton
    20 The Ridgeway
    WD7 8PR Radlett
    Hertfordshire
    United KingdomBritish41216370001
    SHEPPARD, Robin Michael Philpot
    Combe Leaze
    Horsecombe Grove Combe Down
    BA2 5QP Bath
    Avon
    Administrateur
    Combe Leaze
    Horsecombe Grove Combe Down
    BA2 5QP Bath
    Avon
    EnglandBritish34787520001
    WICKS, Sara Nancy May
    The Elms
    Zion Hill, Oakhill
    BA3 5AN Bath
    Avon
    Administrateur
    The Elms
    Zion Hill, Oakhill
    BA3 5AN Bath
    Avon
    British20359260003

    FURLONG HOTELS LIMITED a-t-elle des charges ?

    Charges
    ClassificationDatesStatutDétails
    Guarantee & debenture
    Créé le 09 déc. 2005
    Livré le 22 déc. 2005
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from any charging company to the trustee and/or noteholders (or any of them) on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    F/H the lygon arms hotel broadway worcestershire t/n WR33641, f/h billesley manor hotel billesley alcester stratford upon avon t/n WK383792, f/h combe grove hotel shaft road monkton combe t/n AV139095 for details of further properties charg. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Michael Fentum (The Trustee)
    Transactions
    • 22 déc. 2005Enregistrement d'une charge (395)
    • 20 févr. 2008Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Deed of debenture
    Créé le 09 déc. 2005
    Livré le 21 déc. 2005
    En cours
    Montant garanti
    All monies due or to become due from any obligor to the beneficiaries (or any of them) on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Anglo Irish Bank Corporation PLC as Security Agent for Itself and the Other Beneficiaries
    Transactions
    • 21 déc. 2005Enregistrement d'une charge (395)
    Legal charge
    Créé le 30 nov. 2004
    Livré le 02 déc. 2004
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    F/H the hollies 2 the vineyard stanton near broadway gloucestershire t/n GR240156.
    Personnes ayant droit
    • Barclays Bank PLC
    Transactions
    • 02 déc. 2004Enregistrement d'une charge (395)
    • 17 déc. 2005Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Legal charge
    Créé le 30 juin 2003
    Livré le 04 juil. 2003
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    F/H property k/a rudge hill house (and land adjoining) rudge frome somerset t/nos: WS4420 and ST152220.
    Personnes ayant droit
    • Barclays Bank PLC
    Transactions
    • 04 juil. 2003Enregistrement d'une charge (395)
    • 02 déc. 2005Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Debenture
    Créé le 21 nov. 2001
    Livré le 28 nov. 2001
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    .. fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Barclays Bank PLC
    Transactions
    • 28 nov. 2001Enregistrement d'une charge (395)
    • 17 déc. 2005Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Equitable charge over shares
    Créé le 21 nov. 2001
    Livré le 28 nov. 2001
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    By way of first fixed charge the shares and derivative assets. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Barclays Bank PLC
    Transactions
    • 28 nov. 2001Enregistrement d'une charge (395)
    • 17 déc. 2005Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Legal charge
    Créé le 04 oct. 1999
    Livré le 13 oct. 1999
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Billesley manor hotel stratford upon avon warwickshire t/n-WK375939.
    Personnes ayant droit
    • Barclays Bank PLC
    Transactions
    • 13 oct. 1999Enregistrement d'une charge (395)
    • 17 déc. 2005Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Debenture
    Créé le 04 oct. 1999
    Livré le 11 oct. 1999
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personnes ayant droit
    • Barclays Bank PLC
    Transactions
    • 11 oct. 1999Enregistrement d'une charge (395)
    • 17 déc. 2005Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Debenture
    Créé le 04 mars 1997
    Livré le 11 mars 1997
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Barclays Bank PLC
    Transactions
    • 11 mars 1997Enregistrement d'une charge (395)
    • 13 nov. 1998Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Legal charge
    Créé le 04 mars 1997
    Livré le 10 mars 1997
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Hunstrete house hotel, hunstrete, chelwood, bath, bath and north east somerset title number AV186180.
    Personnes ayant droit
    • Barclays Bank PLC
    Transactions
    • 10 mars 1997Enregistrement d'une charge (395)
    • 13 nov. 1998Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Legal charge
    Créé le 04 mars 1997
    Livré le 10 mars 1997
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Homewood park hotel, hinton, charterhouse, bath, bath and north east somerset title number AV198359.
    Personnes ayant droit
    • Barclays Bank PLC
    Transactions
    • 10 mars 1997Enregistrement d'une charge (395)
    • 24 nov. 2001Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Legal mortgage
    Créé le 11 avr. 1996
    Livré le 18 avr. 1996
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    F/H land situate at and k/a homewood park hotel hinton charterhouse bath county of avon and the proceeds of sale thereof with A. floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment and an assignment of the goodwill and connection of any business together with the full benefit of all licences.
    Personnes ayant droit
    • Coutts & Company
    Transactions
    • 18 avr. 1996Enregistrement d'une charge (395)
    • 06 juin 1998Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Legal mortgage
    Créé le 19 oct. 1993
    Livré le 22 oct. 1993
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Marfurlong farmhouse,ebrington gloucestershire t/n's GR150969 and gr 150967 also charges by way of floating security. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Personnes ayant droit
    • Coutts & Company
    Transactions
    • 22 oct. 1993Enregistrement d'une charge (395)
    • 06 juin 1998Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Legal mortgage
    Créé le 23 août 1991
    Livré le 07 sept. 1991
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    F/H property k/a 6 lister grove, westwood, bradford-on-avon, wilts.. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Personnes ayant droit
    • Coutts & Company.
    Transactions
    • 07 sept. 1991Enregistrement d'une charge
    • 06 juin 1998Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Legal charge
    Créé le 01 mai 1979
    Livré le 22 mai 1979
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    F/H premises on church street, moreton in marsh k/a manor house hotel, moreton-in-marsh, glos.
    Personnes ayant droit
    • Barclays Bank LTD
    Transactions
    • 22 mai 1979Enregistrement d'une charge
    • 24 nov. 2001Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)

    FURLONG HOTELS LIMITED a-t-elle des procédures d'insolvabilité ?

    Numéro de dossierDatesTypePraticiensAutre
    1
    DateType
    11 sept. 2014Administration started
    10 sept. 2015Administration ended
    In administration
    NomRôleAdresseNommé leCessé le
    Paul David Williams
    Duff & Phelps Ltd The Shard
    32 London Bridge Street
    SE1 9SG London
    practitioner
    Duff & Phelps Ltd The Shard
    32 London Bridge Street
    SE1 9SG London
    Paul John Clark
    The Shard 32 London Bridge Street
    SE1 9SG London
    practitioner
    The Shard 32 London Bridge Street
    SE1 9SG London
    David John Whitehouse
    32 London Bridge Street
    SE1 9SG London
    practitioner
    32 London Bridge Street
    SE1 9SG London
    Benjamin John Wiles
    The Shard 32 London Bridge Street
    SE1 9SG London
    practitioner
    The Shard 32 London Bridge Street
    SE1 9SG London

    Source de données

    • Companies House du Royaume-Uni
      Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers.
    • Licence: CC0