ATKINS PLANNING & MANAGEMENT CONSULTANTS LIMITED

ATKINS PLANNING & MANAGEMENT CONSULTANTS LIMITED

  • Vue d'ensemble
  • Résumé
  • Objet social
  • Adresse
  • Dénominations sociales précédentes
  • Comptes
  • Bilan annuel
  • Dépôts
  • Dirigeants
  • Charges
  • Source de données
  • Vue d'ensemble

    Nom de la sociétéATKINS PLANNING & MANAGEMENT CONSULTANTS LIMITED
    Statut de la sociétéDissoute
    Forme juridiqueSociété à responsabilité limitée
    Numéro de société 00819139
    JuridictionAngleterre/Pays de Galles
    Date de création
    Date de cessation d'activité

    Résumé

    A des PSCs super sécurisésNon
    A des chargesOui
    A un historique d'insolvabilitéNon
    Le siège social est contestéNon

    Quel est l'objet de ATKINS PLANNING & MANAGEMENT CONSULTANTS LIMITED ?

    • Autres activités de soutien aux entreprises n.c.a. (82990) / Activités administratives et de soutien

    Où se situe ATKINS PLANNING & MANAGEMENT CONSULTANTS LIMITED ?

    Adresse du siège social
    Woodcote Grove
    Ashley Road
    KT18 5BW Epsom
    Surrey
    Adresse du siège social non livrableNon

    Quels étaient les noms précédents de ATKINS PLANNING & MANAGEMENT CONSULTANTS LIMITED ?

    Dénominations sociales précédentes
    Nom de la sociétéDeJusqu'au
    WS ATKINS PLANNING AND MANAGEMENT CONSULTANTS LIMITED03 avr. 198903 avr. 1989
    WS ATKINS MANAGEMENT CONSULTANTS16 mars 198716 mars 1987
    ATKINS PLANNING10 sept. 196410 sept. 1964

    Quels sont les derniers comptes de ATKINS PLANNING & MANAGEMENT CONSULTANTS LIMITED ?

    Derniers comptes
    Derniers comptes arrêtés au31 mars 2013

    Quel est le statut du dernier bilan annuel pour ATKINS PLANNING & MANAGEMENT CONSULTANTS LIMITED ?

    Bilan annuel
    Dernier bilan annuel

    Quels sont les derniers dépôts pour ATKINS PLANNING & MANAGEMENT CONSULTANTS LIMITED ?

    Dépôts
    DateDescriptionDocumentType

    Bulletin officiel final dissous par radiation volontaire

    1 pagesGAZ2(A)

    Premier avis au Bulletin officiel pour la radiation volontaire

    1 pagesGAZ1(A)

    Demande de radiation de la société du registre du commerce

    3 pagesDS01

    Résolutions

    Resolutions
    1 pagesRESOLUTIONS
    Résolutions
    CatégorieDateDescriptionType
    capital

    Résolutions

    Re dividend 11/12/2014
    RES13

    legacy

    1 pagesSH20

    État du capital au 05 janv. 2015

    • Capital: GBP 1
    4 pagesSH19

    legacy

    1 pagesCAP-SS

    Résolutions

    Resolutions
    1 pagesRESOLUTIONS
    Résolutions
    CatégorieDateDescriptionType
    capital

    Résolution de réduction du capital social émis

    RES06

    Déclaration annuelle jusqu'au 20 sept. 2014 avec liste complète des actionnaires

    5 pagesAR01

    Cessation de la nomination de Alun Hughes Griffiths en tant que directeur le 30 juil. 2014

    1 pagesTM01

    Nomination de Mr Alan James Cullens en tant qu'administrateur le 01 juil. 2014

    2 pagesAP01

    Comptes établis au 31 mars 2013

    4 pagesAA

    Déclaration annuelle jusqu'au 20 sept. 2013 avec liste complète des actionnaires

    5 pagesAR01

    Comptes établis au 31 mars 2012

    4 pagesAA

    Déclaration annuelle jusqu'au 20 sept. 2012 avec liste complète des actionnaires

    5 pagesAR01

    Modification des coordonnées de l'administrateur Mr Heath Stewart Drewett le 08 août 2012

    2 pagesCH01

    Nomination de Mr Richard Webster en tant qu'administrateur le 01 janv. 2012

    2 pagesAP01

    Comptes établis au 31 mars 2011

    4 pagesAA

    Cessation de la nomination de Steven Johnson en tant que directeur le 30 nov. 2011

    1 pagesTM01

    Déclaration annuelle jusqu'au 20 sept. 2011 avec liste complète des actionnaires

    4 pagesAR01

    Nomination de Steven Johnson en tant qu'administrateur

    2 pagesAP01

    Cessation de la nomination de Ian Purser en tant que directeur

    1 pagesTM01

    Comptes établis au 31 mars 2010

    4 pagesAA

    Déclaration annuelle jusqu'au 20 sept. 2010 avec liste complète des actionnaires

    5 pagesAR01

    Déclaration des objets de la société

    2 pagesCC04

    Qui sont les dirigeants de ATKINS PLANNING & MANAGEMENT CONSULTANTS LIMITED ?

    Dirigeants
    NomNommé leDate de démissionRôleAdresseIdentification de la sociétéPays de résidenceNationalitéDate de naissanceProfessionNuméro
    BAKER, Helen Alice
    Woodcote Grove
    Ashley Road
    KT18 5BW Epsom
    Surrey
    Secrétaire
    Woodcote Grove
    Ashley Road
    KT18 5BW Epsom
    Surrey
    British108742050002
    WEBSTER, Richard
    Woodcote Grove
    Ashley Road
    KT18 5BW Epsom
    Surrey
    Secrétaire
    Woodcote Grove
    Ashley Road
    KT18 5BW Epsom
    Surrey
    British85595860003
    CULLENS, Alan James
    Woodcote Grove
    Ashley Road
    KT18 5BW Epsom
    Surrey
    Administrateur
    Woodcote Grove
    Ashley Road
    KT18 5BW Epsom
    Surrey
    United KingdomBritish189297280001
    DREWETT, Heath Stewart
    Woodcote Grove
    Ashley Road
    KT18 5BW Epsom
    Surrey
    Administrateur
    Woodcote Grove
    Ashley Road
    KT18 5BW Epsom
    Surrey
    United KingdomBritish167727030003
    WEBSTER, Richard
    Woodcote Grove
    Ashley Road
    KT18 5BW Epsom
    Surrey
    Administrateur
    Woodcote Grove
    Ashley Road
    KT18 5BW Epsom
    Surrey
    United KingdomBritish85595860003
    DAVID, Katie Charmian
    31 Sandy Lane
    TN13 3TP Sevenoaks
    Kent
    Secrétaire
    31 Sandy Lane
    TN13 3TP Sevenoaks
    Kent
    British73696680003
    DAVIS, Philip Stephen James
    Hartland
    Woodside Drive
    RG18 9QD Hermitage
    Berkshire
    Secrétaire
    Hartland
    Woodside Drive
    RG18 9QD Hermitage
    Berkshire
    British71932630003
    HAMES, Victoria Elizabeth
    Flat 5
    70 Elmbourne Road
    SW17 8JJ London
    Secrétaire
    Flat 5
    70 Elmbourne Road
    SW17 8JJ London
    British102613150001
    MASSIE, Amanda Jane Emilia
    Bradlow
    Sandy Lane
    GU3 1HF Guildford
    Surrey
    Secrétaire
    Bradlow
    Sandy Lane
    GU3 1HF Guildford
    Surrey
    British36957420004
    TOMALIN, Richard Howarth
    22 Fort Road
    GU1 3TE Guildford
    Surrey
    Secrétaire
    22 Fort Road
    GU1 3TE Guildford
    Surrey
    British13199870002
    BILLINGHAM, Stephen Robert, Doctor
    Gso Business Park
    G74 5PG East Kilbride
    British Energy
    Administrateur
    Gso Business Park
    G74 5PG East Kilbride
    British Energy
    British983300008
    BINNIE, Christopher Jon Anthony
    4 Reigate Hill Close
    RH2 9PG Reigate
    Surrey
    Administrateur
    4 Reigate Hill Close
    RH2 9PG Reigate
    Surrey
    British14298460001
    CLANCY, Brian Charles
    97 Winchester Street
    SW1V 4NX London
    Administrateur
    97 Winchester Street
    SW1V 4NX London
    British70735350001
    COLLINS, Roger Arthur Forster
    Three Oaks 166 Pembroke Close
    SM7 2BH Banstead
    Surrey
    Administrateur
    Three Oaks 166 Pembroke Close
    SM7 2BH Banstead
    Surrey
    EnglandBritish30542670001
    CORRIE, Robert Keith
    7 Hawkwood Dell
    Great Bookham
    KT23 4JR Leatherhead
    Surrey
    Administrateur
    7 Hawkwood Dell
    Great Bookham
    KT23 4JR Leatherhead
    Surrey
    EnglandBritish35957190001
    CUTHBERT, Richard Harry
    Saxons
    Meath Green Lane
    RH6 8JA Horley
    Surrey
    Administrateur
    Saxons
    Meath Green Lane
    RH6 8JA Horley
    Surrey
    United KingdomBritish43573230002
    FYFE, John, Professor
    Watermead
    Lakes Lane
    GU8 5LQ Witley
    Surrey
    Administrateur
    Watermead
    Lakes Lane
    GU8 5LQ Witley
    Surrey
    United KingdomBritish3128160001
    GRIFFITHS, Alun Hughes
    Woodcote Grove
    Ashley Road
    KT18 5BW Epsom
    Surrey
    Administrateur
    Woodcote Grove
    Ashley Road
    KT18 5BW Epsom
    Surrey
    EnglandBritish47764900002
    HEALY, William John
    36 Shaftesbury Road
    RH10 7HD Crawley
    West Sussex
    Administrateur
    36 Shaftesbury Road
    RH10 7HD Crawley
    West Sussex
    United KingdomBritish91089340001
    JAMES, David Stuart
    Merfield Straight Lane
    Rode
    BA3 6PG Bath
    Avon
    Administrateur
    Merfield Straight Lane
    Rode
    BA3 6PG Bath
    Avon
    United KingdomBritish19034030002
    JARVIS, Richard Douglas
    Woodhay
    White Lane
    GU4 8PU Guildford
    Surrey
    Administrateur
    Woodhay
    White Lane
    GU4 8PU Guildford
    Surrey
    EnglandBritish16756850002
    JEFFRIES, Michael Makepeace Eugene
    Glade Lodge
    The Glade
    KT20 6LL Kingswood
    Surrey
    Administrateur
    Glade Lodge
    The Glade
    KT20 6LL Kingswood
    Surrey
    British15114890006
    JOHNSON, Steven
    Woodcote Grove
    Ashley Road
    KT18 5BW Epsom
    Surrey
    Administrateur
    Woodcote Grove
    Ashley Road
    KT18 5BW Epsom
    Surrey
    United KingdomBritish161365240001
    MACLEOD, Robert James
    Guildford Road
    GU6 8LT Cranleigh
    Norther Farm
    Surrey
    Administrateur
    Guildford Road
    GU6 8LT Cranleigh
    Norther Farm
    Surrey
    United KingdomBritish90186680002
    MARKS, Charles Theodore
    24 Valley Road
    CR8 5BQ Kenley
    Surrey
    Administrateur
    24 Valley Road
    CR8 5BQ Kenley
    Surrey
    United KingdomBritish67281260001
    MCCLEAN, James Constantine Stuart
    Waterfield, Petworth Road
    Chiddingfold
    GU8 4UF Godalming
    Surrey
    Administrateur
    Waterfield, Petworth Road
    Chiddingfold
    GU8 4UF Godalming
    Surrey
    EnglandBritish121347960001
    MORGAN, David Graham
    Glendale Deepdene Park Road
    RH5 4AW Dorking
    Surrey
    Administrateur
    Glendale Deepdene Park Road
    RH5 4AW Dorking
    Surrey
    British18966920001
    PURSER, Ian Robert
    Woodcote Grove
    Ashley Road
    KT18 5BW Epsom
    Surrey
    Administrateur
    Woodcote Grove
    Ashley Road
    KT18 5BW Epsom
    Surrey
    United KingdomBritish61343830005
    SANDON, Andrew Charles
    5 Eastwick Park Avenue
    Bookham
    KT23 3LY Leatherhead
    Surrey
    Administrateur
    5 Eastwick Park Avenue
    Bookham
    KT23 3LY Leatherhead
    Surrey
    British30542680001
    SMITH, Stephen
    54 Spring Lane
    Fordham Heath
    CO3 9TG Colchester
    Essex
    Administrateur
    54 Spring Lane
    Fordham Heath
    CO3 9TG Colchester
    Essex
    British82293290001
    SOLE, Francis Alfred
    71 High Street
    West Wratting
    CB1 5LU Cambridge
    Cambridgeshire
    Administrateur
    71 High Street
    West Wratting
    CB1 5LU Cambridge
    Cambridgeshire
    British16756860001
    SOUTHERN, Andrew Clive, Dr
    Flat 1 35 Eccleston Square
    Pimlico
    SW1V 1PB London
    Administrateur
    Flat 1 35 Eccleston Square
    Pimlico
    SW1V 1PB London
    British47764970003
    THIRKETTLE, David
    Yew Trees Cottage Old Down Hill
    Tockington
    BS12 4PA Bristol
    Avon
    Administrateur
    Yew Trees Cottage Old Down Hill
    Tockington
    BS12 4PA Bristol
    Avon
    British18966930001

    ATKINS PLANNING & MANAGEMENT CONSULTANTS LIMITED a-t-elle des charges ?

    Charges
    ClassificationDatesStatutDétails
    Second fixed and floating debenture
    Créé le 27 févr. 2003
    Livré le 11 mars 2003
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to any finance party on any account whatsoever
    Brèves mentions
    The present real property, the future real property all other real property now belonging to it other than the excluded real property, book debts bank acounts investments with a floating charge over the. Undertaking and all property and assets. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • The Royal Bank of Scotland PLC in Its Capacity as Security Trustee for the Finance Parties
    Transactions
    • 11 mars 2003Enregistrement d'une charge (395)
    • 07 déc. 2004Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Fixed and floating security document
    Créé le 18 déc. 2002
    Livré le 27 déc. 2002
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All moneys,indebtedness,debts and liabilities due or to become due from the company to any finance party on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Excluding (I) 650 aztec west business park,bristol; (ii) block b 4-6 wellbrook court CB3 ona,cambridge; (iii) 3RD floor longcross court 47 newport rd,CF24 oad,cardiff; see form 395 for details. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • The Royal Bank of Scotland PLC,as Security Trustee for the Finance Parties
    Transactions
    • 27 déc. 2002Enregistrement d'une charge (395)
    • 07 déc. 2004Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Charge over book debts.
    Créé le 25 avr. 1985
    Livré le 02 mai 1983
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    All bookdebts and other debts present and future.
    Personnes ayant droit
    • Clydedale Bank Public Limited Company.
    Transactions
    • 02 mai 1983Enregistrement d'une charge
    • 06 mai 1994Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Floating charge
    Créé le 13 févr. 1978
    Livré le 22 févr. 1979
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Floating charge. Undertaking and all property and assets present and future including uncalled capital.
    Personnes ayant droit
    • Clydesdale Bank Limited
    Transactions
    • 22 févr. 1979Enregistrement d'une charge
    • 06 mai 1994Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)

    Source de données

    • Companies House du Royaume-Uni
      Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers.
    • Licence: CC0