QUADRIGA WORLDWIDE LIMITED

  • Vue d'ensemble
  • Résumé
  • Objet social
  • Adresse
  • Dénominations sociales précédentes
  • Comptes
  • Dépôts
  • Dirigeants
  • Personnes ayant un contrôle significatif
  • Charges
  • Insolvabilité
  • Source de données
  • Vue d'ensemble

    Nom de la sociétéQUADRIGA WORLDWIDE LIMITED
    Statut de la sociétéDissoute
    Forme juridiqueSociété à responsabilité limitée
    Numéro de société 00827164
    JuridictionAngleterre/Pays de Galles
    Date de création
    Date de cessation d'activité

    Résumé

    A des PSCs super sécurisésNon
    A des chargesOui
    A un historique d'insolvabilitéOui
    Le siège social est contestéNon

    Quel est l'objet de QUADRIGA WORLDWIDE LIMITED ?

    • Autre vente au détail non en magasin, sur les stands ou marchés (47990) / Commerce de gros et de détail ; réparation de véhicules automobiles et de motocycles
    • Autres activités de services informatiques (62090) / Information et communication
    • Activités des sièges sociaux (70100) / Activités spécialisées, scientifiques et techniques

    Où se situe QUADRIGA WORLDWIDE LIMITED ?

    Adresse du siège social
    Devonshire House
    60 Goswell Road
    EC1M 7AD London
    Adresse du siège social non livrableNon

    Quels étaient les noms précédents de QUADRIGA WORLDWIDE LIMITED ?

    Dénominations sociales précédentes
    Nom de la sociétéDeJusqu'au
    QUADRIGA UK LIMITED25 sept. 199825 sept. 1998
    THORN BUSINESS COMMUNICATIONS LIMITED01 oct. 199301 oct. 1993
    THORN EMI BUSINESS COMMUNICATIONS LIMITED26 mars 198626 mars 1986
    RED BANK RADIO LIMITED13 nov. 196413 nov. 1964

    Quels sont les derniers comptes de QUADRIGA WORLDWIDE LIMITED ?

    Derniers comptes
    Derniers comptes arrêtés au31 déc. 2016

    Quels sont les derniers dépôts pour QUADRIGA WORLDWIDE LIMITED ?

    Dépôts
    DateDescriptionDocumentType

    Gazette finale dissoute à la suite d'une liquidation

    1 pagesGAZ2

    Avis de transition de l'administration à la dissolution

    21 pagesAM23

    Rapport d'avancement de l'administrateur

    21 pagesAM10

    Rapport d'avancement de l'administrateur

    24 pagesAM10

    Avis de prolongation de la période de l'administration

    3 pagesAM19

    Avis d'approbation réputée des propositions

    3 pagesAM06

    Déclaration de la proposition de l'administrateur

    3 pagesAM03

    Satisfaction de la charge 008271640007 en totalité

    4 pagesMR04

    Déclaration des affaires avec le formulaire AM02SOA

    11 pagesAM02

    Changement d'adresse du siège social de Forum 1 Station Road Theale Berkshire RG7 4RA à Devonshire House 60 Goswell Road London EC1M 7AD le 07 mars 2019

    2 pagesAD01

    Nomination d'un administrateur

    3 pagesAM01

    Nomination de Quadriga Holdings Limited en tant qu'administrateur le 28 sept. 2018

    2 pagesAP02

    Cessation de la nomination de Paul Antony Wilson en tant que directeur le 28 sept. 2018

    1 pagesTM01

    Comptes annuels établis au 31 déc. 2016

    22 pagesAA

    Déclaration de confirmation établie le 10 mai 2018 sans mise à jour

    3 pagesCS01

    Cessation de la nomination de Christopher John Maityard en tant que directeur le 26 juin 2017

    1 pagesTM01

    Déclaration de confirmation établie le 10 mai 2017 avec mises à jour

    5 pagesCS01

    Cessation de la nomination de James Gerard Naro en tant que directeur le 07 mars 2017

    1 pagesTM01

    Comptes annuels établis au 31 déc. 2015

    26 pagesAA

    Nomination de Mr Christopher John Maityard en tant qu'administrateur le 13 mai 2016

    2 pagesAP01

    Déclaration annuelle jusqu'au 10 mai 2016 avec liste complète des actionnaires

    6 pagesAR01
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    capital28 juin 2016

    État du capital au 28 juin 2016

    • Capital: GBP 63,432,676
    SH01

    Comptes de filiale exemptée d'audit établis au 31 mars 2015

    21 pagesAA

    legacy

    35 pagesPARENT_ACC

    legacy

    3 pagesGUARANTEE2

    legacy

    1 pagesAGREEMENT2

    Qui sont les dirigeants de QUADRIGA WORLDWIDE LIMITED ?

    Dirigeants
    NomNommé leDate de démissionRôleAdresseIdentification de la sociétéPays de résidenceNationalitéDate de naissanceProfessionNuméro
    MOORER, Seale Alonzo
    Station Road
    RG7 4RA Theale
    Forum 1
    Berkshire
    England
    Administrateur
    Station Road
    RG7 4RA Theale
    Forum 1
    Berkshire
    England
    United StatesAmerican199604390001
    QUADRIGA HOLDINGS LIMITED
    Station Road
    Theale
    RG7 4RA Reading
    Forum 1
    England
    Administrateur
    Station Road
    Theale
    RG7 4RA Reading
    Forum 1
    England
    Type d'identificationSociété à responsabilité limitée du Royaume-Uni
    Numéro d'enregistrement04019893
    251374210001
    AULT, Isabel Mary Katherine
    87 Shaftesbury Road
    SP2 0DU Wilton
    Jasmine Cottage
    Wiltshire
    United Kingdom
    Secrétaire
    87 Shaftesbury Road
    SP2 0DU Wilton
    Jasmine Cottage
    Wiltshire
    United Kingdom
    128525910001
    DALLISON, Adrian John
    41 Common Hill
    BA14 6EE Steeple Ashton
    Wiltshire
    Secrétaire
    41 Common Hill
    BA14 6EE Steeple Ashton
    Wiltshire
    British52541710002
    JENKINS, Elisabeth Anne
    50a Cyril Mansions
    Prince Of Wales Drive
    SW11 4HW London
    Secrétaire
    50a Cyril Mansions
    Prince Of Wales Drive
    SW11 4HW London
    British72837960002
    KIRK, Isabelle Sarah
    Station Road
    RG7 4RA Theale
    Forum 1
    Berkshire
    United Kingdom
    Secrétaire
    Station Road
    RG7 4RA Theale
    Forum 1
    Berkshire
    United Kingdom
    199579650001
    MOHINDRA, Ravi Kumar
    12 Falcon House Gardens
    Woolton Hill
    RG20 9UQ Newbury
    Berkshire
    Secrétaire
    12 Falcon House Gardens
    Woolton Hill
    RG20 9UQ Newbury
    Berkshire
    British122688990001
    MORDECAI, Laura Rose
    Flat 15
    23 Chartfield Avenue
    SW15 6DX Putney
    London
    Secrétaire
    Flat 15
    23 Chartfield Avenue
    SW15 6DX Putney
    London
    British65797190002
    PARRIS, John
    5 Grange Gardens
    Farnham Common
    SL2 3HL Slough
    Berkshire
    Secrétaire
    5 Grange Gardens
    Farnham Common
    SL2 3HL Slough
    Berkshire
    British12398480001
    RITCHIE, Alistair John
    The Coach House
    68 York Road
    KT13 9DY Weybridge
    Surrey
    Secrétaire
    The Coach House
    68 York Road
    KT13 9DY Weybridge
    Surrey
    British6417760001
    WATSON, David Andrew
    58 Shepherds Lane
    Caversham Heights
    RG4 7JL Reading
    Secrétaire
    58 Shepherds Lane
    Caversham Heights
    RG4 7JL Reading
    British52990930003
    WILLIAMS, Gareth Rhys
    Brickhouse
    115 Bradenstoke
    SN15 4ES Chippenham
    Wiltshire
    Secrétaire
    Brickhouse
    115 Bradenstoke
    SN15 4ES Chippenham
    Wiltshire
    British64039240001
    DAVID VENUS & COMPANY LLP
    Hersham Road
    KT12 1RZ Walton-On-Thames
    42-50
    Surrey
    United Kingdom
    Secrétaire
    Hersham Road
    KT12 1RZ Walton-On-Thames
    42-50
    Surrey
    United Kingdom
    131429630001
    ANDERSON, Douglas Donald
    South Grange Manor
    Bagshot Road
    SL5 9SP Sunninghill
    Berkshire
    Administrateur
    South Grange Manor
    Bagshot Road
    SL5 9SP Sunninghill
    Berkshire
    American31392950001
    ANDRADI, Benedict Pius Marilaan
    16 Knole Way
    TN13 3RS Sevenoaks
    Kent
    Administrateur
    16 Knole Way
    TN13 3RS Sevenoaks
    Kent
    EnglandBritish82360580001
    AUSTIN, Terry Alan
    The Barn
    Handpost Farm Barkham
    RG41 4TN Wokingham
    Berkshire
    Administrateur
    The Barn
    Handpost Farm Barkham
    RG41 4TN Wokingham
    Berkshire
    British82652640001
    BARDEN-STYLIANOU, Stelios Stephen
    47 Carlyle Court
    Chelsea Harbour
    SW10 0UQ London
    Administrateur
    47 Carlyle Court
    Chelsea Harbour
    SW10 0UQ London
    EnglandBritish125782940001
    BETTS, Michael Keith
    8 Minstead Close
    RG12 6QE Bracknell
    Berkshire
    Administrateur
    8 Minstead Close
    RG12 6QE Bracknell
    Berkshire
    British50177800001
    BRIANT, Michael John
    Warrens
    Goldenfields Close
    GU30 7EZ Liphook
    Hampshire
    Administrateur
    Warrens
    Goldenfields Close
    GU30 7EZ Liphook
    Hampshire
    British37465900003
    BUDIE, Marcus Johanes Theodorus
    Portsmouth Road
    KT10 9AD Esher
    Thames House
    Surrey
    United Kingdom
    Administrateur
    Portsmouth Road
    KT10 9AD Esher
    Thames House
    Surrey
    United Kingdom
    United KingdomDutch105980560001
    CAMPBELL, Ronald Alexander Lamont
    Holly Tree House
    Shalbourne
    Marlborough
    Wiltshire
    Administrateur
    Holly Tree House
    Shalbourne
    Marlborough
    Wiltshire
    British7919580002
    CRABB, Ian Denis
    Portsmouth Road
    KT10 9AD Esher
    Thames House
    Surrey
    United Kingdom
    Administrateur
    Portsmouth Road
    KT10 9AD Esher
    Thames House
    Surrey
    United Kingdom
    United KingdomBritish70017710003
    DUNCAN, Fraser Scott
    25 Kippington Road
    TN13 2LJ Sevenoaks
    Kent
    Administrateur
    25 Kippington Road
    TN13 2LJ Sevenoaks
    Kent
    EnglandBritish57508670001
    FORBES, Alistair Robert Ballantyne
    Spring House
    Browns Lane Great Bedwyn
    SN8 3LR Marlborough
    Wiltshire
    Administrateur
    Spring House
    Browns Lane Great Bedwyn
    SN8 3LR Marlborough
    Wiltshire
    United KingdomBritish168893980001
    GALLAGHER, Patrick James
    Fulling Mill
    The Weir
    RG28 7RA Whitchurch
    Hampshire
    Administrateur
    Fulling Mill
    The Weir
    RG28 7RA Whitchurch
    Hampshire
    British77355310002
    GJERS, Arne
    Utmarksvaegen 20
    S 16137 Bromma
    Sweden
    Administrateur
    Utmarksvaegen 20
    S 16137 Bromma
    Sweden
    Swedish56668670001
    GOLDING, Richard James Arthur, Doctor
    29 Downshire Hill
    Hampstead
    NW3 1NT London
    Administrateur
    29 Downshire Hill
    Hampstead
    NW3 1NT London
    British80747680001
    GOZZETT, Kim
    Kelvedon Road
    Inworth
    CO5 9SX Colchester
    Hill Farm
    Essex
    Administrateur
    Kelvedon Road
    Inworth
    CO5 9SX Colchester
    Hill Farm
    Essex
    United KingdomBritish122205910001
    HANSEN, George Edward
    Pine Trees Wentworth Drive
    GU25 4NY Virginia Water
    Surrey
    Administrateur
    Pine Trees Wentworth Drive
    GU25 4NY Virginia Water
    Surrey
    American36446620004
    HOWES, Lewis Verlie
    Gisburn
    50 Woodham Waye
    GU21 5SJ Woking
    Surrey
    Administrateur
    Gisburn
    50 Woodham Waye
    GU21 5SJ Woking
    Surrey
    EnglandBritish62776210004
    HULL, Jonathan
    Portsmouth Road
    KT10 9AD Esher
    Thames House
    Surrey
    United Kingdom
    Administrateur
    Portsmouth Road
    KT10 9AD Esher
    Thames House
    Surrey
    United Kingdom
    EnglandBritish116761670001
    LEVY, Lionel Anthony
    29 Pangbourne Drive
    Stanmore
    HA7 4RA Middlesex
    Administrateur
    29 Pangbourne Drive
    Stanmore
    HA7 4RA Middlesex
    United KingdomBritish105270770001
    MAITYARD, Christopher John
    Station Rd
    RG7 4RA Theale
    Forum 1
    Berkshire
    England
    Administrateur
    Station Rd
    RG7 4RA Theale
    Forum 1
    Berkshire
    England
    EnglandBritish210342460001
    MARSH, Gary Neil
    Forum 1
    Station Road
    RG7 4RA Theale
    Berkshire
    Administrateur
    Forum 1
    Station Road
    RG7 4RA Theale
    Berkshire
    EnglandBritish122518590001
    MILLER, Louise Ann
    Pound Cottages
    High Street
    RG8 9JH Streatley
    6
    Berkshire
    United Kingdom
    Administrateur
    Pound Cottages
    High Street
    RG8 9JH Streatley
    6
    Berkshire
    United Kingdom
    British127375160002

    Qui sont les personnes ayant un contrôle significatif sur QUADRIGA WORLDWIDE LIMITED ?

    Personnes ayant un contrôle significatif
    NomNotifié leAdresseCessé
    Forum, Station Road
    Theale
    RG7 4RA Reading
    Forum 1
    England
    06 avr. 2016
    Forum, Station Road
    Theale
    RG7 4RA Reading
    Forum 1
    England
    Non
    Forme juridiqueLimited Company
    Pays d'enregistrementEngland
    Autorité légaleUk Company Law
    Lieu d'enregistrementCompanies House
    Numéro d'enregistrement04019893
    Nature du contrôle
    • La personne détient, directement ou indirectement, plus de 75 % des actions de la société.

    QUADRIGA WORLDWIDE LIMITED a-t-elle des charges ?

    Charges
    ClassificationDatesStatutDétails
    A registered charge
    Créé le 07 août 2015
    Livré le 18 août 2015
    En cours
    Contient une promesse négative: Oui
    Contient une charge flottante: Oui
    Contient une charge fixe: Oui
    Personnes ayant droit
    • Deutsche Bank Trust Company Americas
    Transactions
    • 18 août 2015Enregistrement d'une charge (MR01)
    A registered charge
    Créé le 09 juil. 2015
    Livré le 24 juil. 2015
    Totalement satisfaite
    Contient une promesse négative: Oui
    Contient une charge fixe: Oui
    Personnes ayant droit
    • Lloyds Bank PLC
    Transactions
    • 24 juil. 2015Enregistrement d'une charge (MR01)
    • 15 mai 2019Satisfaction d'une charge (MR04)
    A registered charge
    Créé le 05 déc. 2013
    Livré le 06 déc. 2013
    Totalement satisfaite
    Brève description
    Notification of addition to or amendment of charge.
    La charge flottante couvre tout: Oui
    Contient une charge flottante: Oui
    Contient une charge fixe: Oui
    Personnes ayant droit
    • Lloyds Bank PLC (Previously Known as Lloyds Tsb Bank PLC)
    Transactions
    • 06 déc. 2013Enregistrement d'une charge (MR01)
    • 16 juil. 2015Satisfaction d'une charge (MR04)
    Rent deposit agreement
    Créé le 18 mai 2012
    Livré le 23 mai 2012
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    The sums deposited from time to time.
    Personnes ayant droit
    • John Howard Short and Jillian Helen Theresa Short
    Transactions
    • 23 mai 2012Enregistrement d'une charge (MG01)
    • 10 sept. 2015Satisfaction d'une charge (MR04)
    An omnibus guarantee and set-off agreement
    Créé le 11 févr. 2010
    Livré le 12 févr. 2010
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the companies named therein to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Any sums or sums standing to the credit of any one or more of any present of future accounts of the company with the bank whether such accounts be denominated in sterling or in a currency or currencies other than sterling.
    Personnes ayant droit
    • Lloyds Tsb Bank PLC
    Transactions
    • 12 févr. 2010Enregistrement d'une charge (MG01)
    • 16 juil. 2015Satisfaction d'une charge (MR04)
    Fixed and floating security between, inter alia, the chargor and the security agent (as defined)(the "security document")
    Créé le 03 déc. 2001
    Livré le 19 déc. 2001
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All present and future moneys, debts and liabilities due, owing or incurred by the chargor to any finance party under or in connection with any finance document (all terms as defined)
    Brèves mentions
    Twelfth floor, 389 chiswick high road, london, W4 4AL. First floor north, forum one, station road, theale, berkshire. Baird house, sprint industrial estate, chertsey road, byfleet, surrey, KT14 7LA. Unit 540, metroplex business park, broadway, salford, manchester, M5 2UW.. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • National Westminster Bank PLC as Security Agent for and on Behalf of Thefinance Parties (The "Security Agent")
    Transactions
    • 19 déc. 2001Enregistrement d'une charge (395)
    • 01 déc. 2009Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (MG02)
    Fixed and floating security document between the chargors (as defined) and the security agent
    Créé le 03 déc. 2001
    Livré le 19 déc. 2001
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All moneys,debts and liabilities due or to become due from the company (the "chargor") to any finance party (as defined) under or in connection with any finance document (as defined)
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • National Westminster Bank PLC,London,as Security Agent for the Finance Parties
    Transactions
    • 19 déc. 2001Enregistrement d'une charge (395)
    • 01 déc. 2009Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (MG02)
    Floating charge
    Créé le 10 déc. 1998
    Livré le 14 déc. 1998
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All obligations and liabilities on any account whatsoever due or to become due from the company to any senior finance party under the senior finance documents, any mezzanine finance party under the mezzanine finance documents and any hedging creditor under the hedging document
    Brèves mentions
    Undertaking and all property and assets. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Cibc Wood Grundy PLC(As Agent and Trustee for the Senior Finance Parties, the Mezzanine Finance Parties and the Hedging Creditors
    Transactions
    • 14 déc. 1998Enregistrement d'une charge (395)
    • 07 avr. 2000Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)

    QUADRIGA WORLDWIDE LIMITED a-t-elle des procédures d'insolvabilité ?

    Numéro de dossierDatesTypePraticiensAutre
    1
    DateType
    15 févr. 2019Administration started
    17 févr. 2021Administration ended
    In administration
    NomRôleAdresseNommé leCessé le
    Ian Robert
    Kingston Smith & Partners Llp
    Devonshire House
    EC1M 7AD 60 Goswell Road
    London
    practitioner
    Kingston Smith & Partners Llp
    Devonshire House
    EC1M 7AD 60 Goswell Road
    London
    Christopher Purkiss
    Devonshire House
    60 Goswell Road
    EC1M 7AD London
    practitioner
    Devonshire House
    60 Goswell Road
    EC1M 7AD London

    Source de données

    • Companies House du Royaume-Uni
      Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers.
    • Licence: CC0