SLFC ASSURANCE (UK) LIMITED

  • Vue d'ensemble
  • Résumé
  • Objet social
  • Adresse
  • Dénominations sociales précédentes
  • Comptes
  • Dépôts
  • Dirigeants
  • Charges
  • Insolvabilité
  • Source de données
  • Vue d'ensemble

    Nom de la sociétéSLFC ASSURANCE (UK) LIMITED
    Statut de la sociétéDissoute
    Forme juridiqueSociété à responsabilité limitée
    Numéro de société 00830572
    JuridictionAngleterre/Pays de Galles
    Date de création
    Date de cessation d'activité

    Résumé

    A des PSCs super sécurisésNon
    A des chargesOui
    A un historique d'insolvabilitéOui
    Le siège social est contestéNon

    Quel est l'objet de SLFC ASSURANCE (UK) LIMITED ?

    • Autres activités auxiliaires à l'assurance et au financement de la retraite (66290) / Activités financières et d'assurance

    Où se situe SLFC ASSURANCE (UK) LIMITED ?

    Adresse du siège social
    4th Floor Cumberland House
    15-17 Cumberland Place
    SO15 2BG Southampton
    Adresse du siège social non livrableNon

    Quels étaient les noms précédents de SLFC ASSURANCE (UK) LIMITED ?

    Dénominations sociales précédentes
    Nom de la sociétéDeJusqu'au
    LINCOLN ASSURANCE LIMITED01 janv. 199701 janv. 1997
    LAURENTIAN LIFE PLC23 janv. 198923 janv. 1989
    IMPERIAL TRIDENT LIFE LIMITED01 juil. 198701 juil. 1987
    TRIDENT LIFE ASSURANCE COMPANY LIMITED03 juil. 198603 juil. 1986
    IMPERIAL TRIDENT LIFE LIMITED01 juin 198601 juin 1986
    TRIDENT LIFE ASSURANCE COMPANY LIMITED09 déc. 196409 déc. 1964

    Quels sont les derniers comptes de SLFC ASSURANCE (UK) LIMITED ?

    Derniers comptes
    Derniers comptes arrêtés au31 déc. 2014

    Quels sont les derniers dépôts pour SLFC ASSURANCE (UK) LIMITED ?

    Dépôts
    DateDescriptionDocumentType

    Gazette finale dissoute à la suite d'une liquidation

    1 pagesGAZ2

    Retour de la réunion finale dans une liquidation volontaire des membres

    18 pagesLIQ13

    Déclaration des reçus et paiements des liquidateurs jusqu'à 01 août 2017

    14 pagesLIQ03

    Changement d'adresse du siège social de Imperial House 18-21 Kings Park Road Southampton Hampshire SO15 2AT à 4th Floor Cumberland House 15-17 Cumberland Place Southampton SO15 2BG le 05 déc. 2016

    2 pagesAD01

    Changement d'adresse du siège social de Matrix House Basing View Basingstoke Hampshire RG21 4DZ à Imperial House 18-21 Kings Park Road Southampton Hampshire SO15 2AT le 16 août 2016

    2 pagesAD01

    Résolutions

    Resolutions
    1 pagesRESOLUTIONS
    Résolutions
    CatégorieDateDescriptionType
    capital

    Résolutions

    Dirs authorise final dividend of 17.89 02/08/2016
    RES13

    Résolutions

    Resolutions
    1 pagesRESOLUTIONS
    Résolutions
    CatégorieDateDescriptionType
    capital

    Résolutions

    Declare final dividend of £410000002.50 02/08/2016
    RES13

    Déclaration de solvabilité

    3 pages4.70

    Nomination d'un liquidateur volontaire

    1 pages600

    Résolutions

    Resolutions
    1 pagesRESOLUTIONS
    Résolutions
    CatégorieDateDescriptionType
    liquidation

    Résolution spéciale pour la liquidation au 02 août 2016

    LRESSP

    État du capital au 01 août 2016

    • Capital: GBP 0.40
    6 pagesSH19

    legacy

    1 pagesSH20

    legacy

    1 pagesCAP-SS

    Résolutions

    Resolutions
    1 pagesRESOLUTIONS
    Résolutions
    CatégorieDateDescriptionType
    capital

    Résolution de réduction du capital social émis

    RES06

    Satisfaction de la charge 29 en totalité

    5 pagesMR04

    Satisfaction de la charge 27 en totalité

    4 pagesMR04

    Satisfaction de la charge 28 en totalité

    4 pagesMR04

    Déclaration annuelle jusqu'au 10 avr. 2016 avec liste complète des actionnaires

    5 pagesAR01
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    capital05 mai 2016

    État du capital au 05 mai 2016

    • Capital: GBP 302,180,000
    SH01

    Nomination de Mr Neville Dean Kent en tant qu'administrateur le 03 mai 2016

    2 pagesAP01

    Cessation de la nomination de Donald Alexander Stewart en tant que directeur le 03 mai 2016

    1 pagesTM01

    Cessation de la nomination de Stephen Mark Coombes en tant que directeur le 29 févr. 2016

    1 pagesTM01

    Comptes annuels établis au 31 déc. 2014

    23 pagesAA

    Déclaration annuelle jusqu'au 10 avr. 2015 avec liste complète des actionnaires

    6 pagesAR01
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    capital13 mai 2015

    État du capital au 13 mai 2015

    • Capital: GBP 302,180,000
    SH01

    Comptes annuels établis au 31 déc. 2013

    24 pagesAA

    Déclaration annuelle jusqu'au 10 avr. 2014 avec liste complète des actionnaires

    6 pagesAR01
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    capital02 mai 2014

    État du capital au 02 mai 2014

    • Capital: GBP 302,180,000
    SH01

    Qui sont les dirigeants de SLFC ASSURANCE (UK) LIMITED ?

    Dirigeants
    NomNommé leDate de démissionRôleAdresseIdentification de la sociétéPays de résidenceNationalitéDate de naissanceProfessionNuméro
    HOBBS, Margaret Fleur
    Limmeridge
    Colwall Green
    WR13 6DX Malvern
    Worcestershire
    Secrétaire
    Limmeridge
    Colwall Green
    WR13 6DX Malvern
    Worcestershire
    BritishSolicitor74951990001
    GARNER, Katherine Angela
    15-17 Cumberland Place
    SO15 2BG Southampton
    4th Floor Cumberland House
    Administrateur
    15-17 Cumberland Place
    SO15 2BG Southampton
    4th Floor Cumberland House
    United KingdomBritishChief Finance Officer149006830001
    KENT, Neville Dean
    15-17 Cumberland Place
    SO15 2BG Southampton
    4th Floor Cumberland House
    Administrateur
    15-17 Cumberland Place
    SO15 2BG Southampton
    4th Floor Cumberland House
    United KingdomBritishDirector44753820002
    DAWBARN, Mark Lupton
    Brambletye High Street
    OX7 6AW Ascott Under Wychwood
    Chipping Norton
    Secrétaire
    Brambletye High Street
    OX7 6AW Ascott Under Wychwood
    Chipping Norton
    BritishSolicitor3920290005
    GARNELL, Mary Elizabeth Jane
    Cyprus House
    High Street Chalford
    GL6 8DR Stroud
    Gloucestershire
    Secrétaire
    Cyprus House
    High Street Chalford
    GL6 8DR Stroud
    Gloucestershire
    British6101450001
    HOBBS, Margaret Fleur
    Limmeridge
    Colwall Green
    WR13 6DX Malvern
    Worcestershire
    Secrétaire
    Limmeridge
    Colwall Green
    WR13 6DX Malvern
    Worcestershire
    British74951990001
    WILSON, Malcolm George William
    Kings Ride House
    HP18 9RP Brill
    Buckinghamshire
    Secrétaire
    Kings Ride House
    HP18 9RP Brill
    Buckinghamshire
    BritishSolicitor72397640001
    ALDER, Bernard Henry
    Inglewood
    Elkstone
    GL53 9PB Cheltenham
    Gloucestershire
    Administrateur
    Inglewood
    Elkstone
    GL53 9PB Cheltenham
    Gloucestershire
    BritishOperations Director57055620002
    ANSTEE, Eric Edward
    Basing View
    RG21 4DZ Basingstoke
    Matrix House
    Hampshire
    United Kingdom
    Administrateur
    Basing View
    RG21 4DZ Basingstoke
    Matrix House
    Hampshire
    United Kingdom
    United KingdomBritishCeo76479900001
    ASKARI, Hasan
    Basing View
    RG21 4DZ Basingstoke
    Matrix House
    Hampshire
    United Kingdom
    Administrateur
    Basing View
    RG21 4DZ Basingstoke
    Matrix House
    Hampshire
    United Kingdom
    United KingdomBritishCompany Director41444890001
    BERRYMAN, Malcolm Leonard
    Kiln Lane
    Otterbourne
    SO21 2EN Winchester
    Otterbourne Manor
    Hampshire
    United Kingdom
    Administrateur
    Kiln Lane
    Otterbourne
    SO21 2EN Winchester
    Otterbourne Manor
    Hampshire
    United Kingdom
    United KingdomBritishConsultant114331270002
    BOSCIA, Jon Andrew
    Basing View
    RG21 4DZ Basingstoke
    Matrix House
    Hampshire
    United Kingdom
    Administrateur
    Basing View
    RG21 4DZ Basingstoke
    Matrix House
    Hampshire
    United Kingdom
    UsaAmericanCompany President153770970001
    BOSCIA, Jon Andrew
    Basing View
    RG21 4DZ Basingstoke
    Matrix House
    Hampshire
    United Kingdom
    Administrateur
    Basing View
    RG21 4DZ Basingstoke
    Matrix House
    Hampshire
    United Kingdom
    UsaAmericanCompany President153770970001
    BROWN, Bernard George
    Long Hop House
    52 New Road
    KT10 9NU Esher
    Surrey
    Administrateur
    Long Hop House
    52 New Road
    KT10 9NU Esher
    Surrey
    BritishManaging Director8598360002
    COOMBES, Stephen Mark
    Basing View
    RG21 4DZ Basingstoke
    Matrix House
    Hampshire
    United Kingdom
    Administrateur
    Basing View
    RG21 4DZ Basingstoke
    Matrix House
    Hampshire
    United Kingdom
    EnglandBritishChief Financial Officer101470950001
    DAVIDSON, Anthony Beverley
    Basing View
    RG21 4DZ Basingstoke
    Matrix House
    Hampshire
    United Kingdom
    Administrateur
    Basing View
    RG21 4DZ Basingstoke
    Matrix House
    Hampshire
    United Kingdom
    United KingdomBritishNon Executive Director61933730002
    DAVIES, David Wyndham
    Basing View
    RG21 4DZ Basingstoke
    Matrix House
    Hampshire
    United Kingdom
    Administrateur
    Basing View
    RG21 4DZ Basingstoke
    Matrix House
    Hampshire
    United Kingdom
    EnglandBritishNon-Executive Director10487980001
    DAWBARN, Mark Lupton
    Brambletye High Street
    OX7 6AW Ascott Under Wychwood
    Chipping Norton
    Administrateur
    Brambletye High Street
    OX7 6AW Ascott Under Wychwood
    Chipping Norton
    BritishSolicitor3920290005
    FRANKLIN, Christina
    Front Street
    Nympsfield
    GL10 3TY Stroud
    Four Wells Cottage
    Gloucestershire
    Uk
    Administrateur
    Front Street
    Nympsfield
    GL10 3TY Stroud
    Four Wells Cottage
    Gloucestershire
    Uk
    United KingdomBritishOperations Director85575860002
    FULLER, Janet Christine
    Basing View
    RG21 4DZ Basingstoke
    Matrix House
    Hampshire
    United Kingdom
    Administrateur
    Basing View
    RG21 4DZ Basingstoke
    Matrix House
    Hampshire
    United Kingdom
    United KingdomBritish CanadianInsurance Executive146458800001
    GARNER, Katherine Angela
    Basing View
    RG21 4DZ Basingstoke
    Matrix House
    Hampshire
    United Kingdom
    Administrateur
    Basing View
    RG21 4DZ Basingstoke
    Matrix House
    Hampshire
    United Kingdom
    United KingdomBritishChief Financial Officer149006830001
    GREEN, Michael Anthony
    23 Wolsey Road
    KT10 8NT Esher
    Surrey
    Administrateur
    23 Wolsey Road
    KT10 8NT Esher
    Surrey
    BritishPersonnel Director51805960002
    HOLSTEIN, Phillip
    8 Wells Rise
    NW8 7LH London
    Administrateur
    8 Wells Rise
    NW8 7LH London
    AmericanInsurance Executive69671760001
    KENT, Neville Dean
    Great Washbourne House
    Great Washbourne
    GL20 7AR Tewkesbury
    Gloucester
    Administrateur
    Great Washbourne House
    Great Washbourne
    GL20 7AR Tewkesbury
    Gloucester
    United KingdomBritishActuary44753820002
    MARSH, Richard William, Lord Marsh Of Mannington
    25 Moreton Terrace
    SW1V 2NS London
    Administrateur
    25 Moreton Terrace
    SW1V 2NS London
    BritishDirector Of Companies12558860001
    MCMATH, Michael Edward
    1 Hibberts Way
    SL9 8UD Gerrards Cross
    Buckinghamshire
    Administrateur
    1 Hibberts Way
    SL9 8UD Gerrards Cross
    Buckinghamshire
    BritishExecutive Director-Sales40388880001
    MOSS, Jonathan Stephen
    Basing View
    RG21 4DZ Basingstoke
    Matrix House
    Hampshire
    United Kingdom
    Administrateur
    Basing View
    RG21 4DZ Basingstoke
    Matrix House
    Hampshire
    United Kingdom
    United KingdomBritishManagement Consultant/Company Director144991950001
    NICK, Jeffrey Joseph
    6 Frognal Close
    Hampstead
    NW3 6YB London
    Administrateur
    6 Frognal Close
    Hampstead
    NW3 6YB London
    AmericanChief Ex Finan Svs Group58634090002
    PARKINSON, Stephen David
    Chestnut Coppice
    Furzefield Chase, Dormans Park
    RH19 2LU East Grinstead
    West Sussex
    Administrateur
    Chestnut Coppice
    Furzefield Chase, Dormans Park
    RH19 2LU East Grinstead
    West Sussex
    EnglandBritishMarketing Director89576180001
    REED, Gregory Edward
    Appleshaw
    Cheltenham Road, Pitchcombe
    GL6 6LZ Stroud
    Gloucestershire
    Administrateur
    Appleshaw
    Cheltenham Road, Pitchcombe
    GL6 6LZ Stroud
    Gloucestershire
    AmericanInvestment Director54583630004
    ROGERS, Derek John
    Woodlands High Street
    Wanborough
    SN4 0AE Swindon
    Wiltshire
    Administrateur
    Woodlands High Street
    Wanborough
    SN4 0AE Swindon
    Wiltshire
    BritishSales Director51815620001
    ROWE, Benjamin Nathan
    214 Hendon Way
    NW4 3NE London
    Administrateur
    214 Hendon Way
    NW4 3NE London
    United KingdomBritishActuary5648270001
    SHAHEEN, Gabriel L
    Hollywood Vicarage Lane
    SL9 8AS Gerrards Cross
    Buckinghamshire
    Administrateur
    Hollywood Vicarage Lane
    SL9 8AS Gerrards Cross
    Buckinghamshire
    AmericanAmerican50946320003
    SHARKEY, Robert John
    Basing View
    RG21 4DZ Basingstoke
    Matrix House
    Hampshire
    United Kingdom
    Administrateur
    Basing View
    RG21 4DZ Basingstoke
    Matrix House
    Hampshire
    United Kingdom
    United KingdomCanadianActuary134441240001
    SHERRIFF, John Baird
    6 Bracken Avenue
    SW12 8BH London
    Administrateur
    6 Bracken Avenue
    SW12 8BH London
    BritishInvestment Director6203290001

    SLFC ASSURANCE (UK) LIMITED a-t-elle des charges ?

    Charges
    ClassificationDatesStatutDétails
    Charge deed
    Créé le 20 juin 2002
    Livré le 08 juil. 2002
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    F/Hold property known as 43 old queen st,london; t/no 65657; f/hold property known as 10-14 bank st,carlisle,cumbria; t/no cu 171028 with all buildings trade and other fixtures,fixed plant and machinery thereon. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Personnes ayant droit
    • Bradford & Bingley PLC
    Transactions
    • 08 juil. 2002Enregistrement d'une charge (395)
    • 21 juil. 2016Satisfaction d'une charge (MR04)
    Rent deposit deed
    Créé le 09 mars 2000
    Livré le 22 mars 2000
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee under a lease dated 23/01/89 and the deed
    Brèves mentions
    By way of charge £13,860 and the amount standing to the credit of the deposit account.
    Personnes ayant droit
    • S.C.M. Property and Investment Company Limited
    Transactions
    • 22 mars 2000Enregistrement d'une charge (395)
    • 21 juil. 2016Satisfaction d'une charge (MR04)
    Mortgage
    Créé le 27 oct. 1993
    Livré le 28 oct. 1993
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    149 belgrave road leicester t/n LT172956ASSIGNS the goodwill of the business (if any). Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Lloyds Bank PLC
    Transactions
    • 28 oct. 1993Enregistrement d'une charge (395)
    • 21 juil. 2016Satisfaction d'une charge (MR04)
    Mortgage
    Créé le 09 juil. 1993
    Livré le 14 juil. 1993
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    L/H property k/a 36A chapel lane formby together with all buildings and fixtures thereon assings goodwill of the business (if any). Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Personnes ayant droit
    • Lloyds Bank PLC
    Transactions
    • 14 juil. 1993Enregistrement d'une charge (395)
    • 15 nov. 1997Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Legal mortgage
    Créé le 01 avr. 1992
    Livré le 15 avr. 1992
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    F/H property k/a 3 wood street, earl shilton, leicester title no. LT180811 together with all buildings and fixturesthereon assigns the goodwill of the business (if any). Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Personnes ayant droit
    • Lloyds Bank PLC
    Transactions
    • 15 avr. 1992Enregistrement d'une charge (395)
    • 28 févr. 1995Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Mortgage
    Créé le 30 déc. 1991
    Livré le 10 janv. 1992
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    F/H property k/a unit 5, 2 station road, earl shilton, leicestershire title no. LT222433 together with all buildings and fixtures thereon assigns the goodwill (if any). Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Personnes ayant droit
    • Lloyds Bank PLC
    Transactions
    • 10 janv. 1992Enregistrement d'une charge (395)
    • 27 mai 1993Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Mortgage
    Créé le 30 déc. 1991
    Livré le 10 janv. 1992
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    F/H property k/a unit 4, 1 station road, earl shilton, leicestershire title no. LT239939 together with all buildings and fixtures thereon assigns the goodwill (if any). Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Personnes ayant droit
    • Lloyds Bank PLC
    Transactions
    • 10 janv. 1992Enregistrement d'une charge (395)
    • 27 mai 1993Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Mortgage
    Créé le 18 févr. 1991
    Livré le 21 févr. 1991
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    1 st johns square glastonbury somerset title no st 66850 by way of assignment the goodwill of the business. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Personnes ayant droit
    • Lloyds Bank PLC
    Transactions
    • 21 févr. 1991Enregistrement d'une charge
    • 28 févr. 1995Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Mortgage
    Créé le 11 févr. 1991
    Livré le 15 févr. 1991
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    L/H unit 14 the talina centre bagleys lane fulham london SW6 assignment the goodwill of the business. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Personnes ayant droit
    • Lloyds Bank PLC
    Transactions
    • 15 févr. 1991Enregistrement d'une charge
    • 28 févr. 1995Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Legal mortgage
    Créé le 04 janv. 1991
    Livré le 08 janv. 1991
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    7/8 the brittox devizes wiltshire together with all buildings & fixtures thereonassigns the goodwill of the business (if any). Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Personnes ayant droit
    • Lloyds Bank PLC
    Transactions
    • 08 janv. 1991Enregistrement d'une charge
    • 29 janv. 1992Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Mortgage
    Créé le 22 avr. 1988
    Livré le 28 avr. 1988
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    F/H 15,15A, & 16 silver street, eastern house bradford on avon wiltshire together with all buildings and fixtures thereon assigns the goodwill of the business (if any). Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Personnes ayant droit
    • Lloyds Bank PLC
    Transactions
    • 28 avr. 1988Enregistrement d'une charge
    Mortgage
    Créé le 11 nov. 1987
    Livré le 30 nov. 1987
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Units 21 & 22 (formerly units 5B & 5C) westfield road, kineton road estate southam, stratford on avon, warwickshire assigns the goodwill of the business (if any). Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Personnes ayant droit
    • Lloyds Bank PLC
    Transactions
    • 30 nov. 1987Enregistrement d'une charge
    Legal mortgage
    Créé le 05 juil. 1985
    Livré le 12 juil. 1985
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Land & buildings at bristol road south llongbridge birmingham west midlands title no wm 233089 and or the proceeds of sale. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Personnes ayant droit
    • National Westminster Bank PLC
    Transactions
    • 12 juil. 1985Enregistrement d'une charge
    Legal charge
    Créé le 15 mai 1985
    Livré le 29 mai 1985
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    F/H land or buildings halton station road, sutton weaver chester.
    Personnes ayant droit
    • Midland Bank PLC
    Transactions
    • 29 mai 1985Enregistrement d'une charge
    Legal charge pursuant to on order of court dated 4/7/85
    Créé le 20 févr. 1985
    Livré le 09 juil. 1985
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    F/H 77 parkway london NW1 title nos 421616, ln 53012, ln 53974, 413310, 413291.
    Personnes ayant droit
    • Lloyds Bank PLC
    Transactions
    • 09 juil. 1985Enregistrement d'une charge
    Legal charge
    Créé le 17 déc. 1984
    Acquis le 18 mars 1985
    Livré le 15 avr. 1985
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    £10,606.40
    Brèves mentions
    All that property situate at and known as 50 nottingham road, stapleford nottingham title no nt 51870.
    Personnes ayant droit
    • Abbey National Building Society
    Transactions
    • 15 avr. 1985Enregistrement d'une charge
    Legal charge
    Créé le 26 oct. 1984
    Livré le 26 oct. 1984
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    F/H 69 high street bagshot surrey title no sy 453934.
    Personnes ayant droit
    • Lloyds Bank PLC
    Transactions
    • 26 oct. 1984Enregistrement d'une charge
    Legal charge
    Créé le 01 sept. 1984
    Livré le 01 sept. 1984
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    10 station road, earl shilton leicester title no lt 74505.
    Personnes ayant droit
    • Yorkshire Bank PLC
    Transactions
    • 01 sept. 1984Enregistrement d'une charge
    Legal charge
    Créé le 01 sept. 1984
    Livré le 01 sept. 1984
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    The cross enderby leicester including all fixtures & fittings (other than trade fixtures a fittings) plant and machinery.
    Personnes ayant droit
    • Yorkshire Bank PLC
    Transactions
    • 01 sept. 1984Enregistrement d'une charge
    Charge
    Créé le 19 mars 1984
    Livré le 20 mars 1984
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from john beynon david william hill and stephen martin welsh to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    42 market place dewsbury kirkless west yorkshire title no wk 130185.
    Personnes ayant droit
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transactions
    • 20 mars 1984Enregistrement d'une charge
    Legal mortgage
    Créé le 05 juil. 1983
    Acquis le 30 oct. 1984
    Livré le 01 mars 1985
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    £80,000
    Brèves mentions
    48/48A high street marlow bucks.
    Personnes ayant droit
    • National Westminster Bank PLC
    Transactions
    • 01 mars 1985Enregistrement d'une charge
    Legal mortgage
    Créé le 17 mai 1983
    Livré le 19 mai 1983
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from davivd william hill, john beynon and/or midland bank trust company not exceeding ukp 75,000
    Brèves mentions
    42 market pl dewsbury w yorks tn wyk 130186.
    Personnes ayant droit
    • National Westminster Bank PLC
    Transactions
    • 19 mai 1983Enregistrement d'une charge
    Mortgage
    Créé le 18 janv. 1983
    Livré le 25 janv. 1983
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    £122,971.38 due or to become due from midland bank trust company limited to the chargees
    Brèves mentions
    77 parkway london NW1 title nos 421616 ln 53012 ln 53974 413310 431291.
    Personnes ayant droit
    • J.H. Heywood
    • W.F. Mullins
    • A.C.F. Morris
    Transactions
    • 25 janv. 1983Enregistrement d'une charge
    Mortgage
    Créé le 12 oct. 1982
    Livré le 15 oct. 1982
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from midland bank trust company limited to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    F/H 77 parkway london NW1 title nos 421616, ln 53012 ln 53974, 413310 & 413291.
    Personnes ayant droit
    • Lloyds Bank PLC
    Transactions
    • 15 oct. 1982Enregistrement d'une charge
    A registered charge
    Créé le 10 août 1982
    Acquis le 09 avr. 1984
    Livré le 07 févr. 1985
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    £22750.28
    Brèves mentions
    20 nelson street bradford title no wyk 114486.
    Personnes ayant droit
    • National Westminster Bank PLC
    Transactions
    • 07 févr. 1985Enregistrement d'une charge

    SLFC ASSURANCE (UK) LIMITED a-t-elle des procédures d'insolvabilité ?

    Numéro de dossierDatesTypePraticiensAutre
    1
    DateType
    02 août 2016Commencement of winding up
    07 mars 2018Dissolved on
    Members voluntary liquidation
    NomRôleAdresseNommé leCessé le
    Gregory Andrew Palfrey
    Imperial House 18-21 Kings Park Road
    SO15 2AT Southampton
    Hampshire
    practitioner
    Imperial House 18-21 Kings Park Road
    SO15 2AT Southampton
    Hampshire
    Stephen John Adshead
    Smith & Williamson Llp Imperial House
    18-21 Kings Park Road
    SO15 2AT Southampton
    practitioner
    Smith & Williamson Llp Imperial House
    18-21 Kings Park Road
    SO15 2AT Southampton

    Source de données

    • Companies House du Royaume-Uni
      Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers.
    • Licence: CC0