STARVILLAS LIMITED

  • Vue d'ensemble
  • Résumé
  • Objet social
  • Adresse
  • Comptes
  • Dépôts
  • Dirigeants
  • Charges
  • Source de données
  • Vue d'ensemble

    Nom de la sociétéSTARVILLAS LIMITED
    Statut de la sociétéDissoute
    Forme juridiqueSociété à responsabilité limitée
    Numéro de société 00833683
    JuridictionAngleterre/Pays de Galles
    Date de création
    Date de cessation d'activité

    Résumé

    A des PSCs super sécurisésNon
    A des chargesOui
    A un historique d'insolvabilitéNon
    Le siège social est contestéNon

    Quel est l'objet de STARVILLAS LIMITED ?

    • Société non marchande non marchande (74990) / Activités spécialisées, scientifiques et techniques

    Où se situe STARVILLAS LIMITED ?

    Adresse du siège social
    Chelford House Rudheath Way
    Rudheath
    CW9 7LN Northwich
    Cheshire
    England
    Adresse du siège social non livrableNon

    Quels sont les derniers comptes de STARVILLAS LIMITED ?

    Derniers comptes
    Derniers comptes arrêtés au30 sept. 2015

    Quels sont les derniers dépôts pour STARVILLAS LIMITED ?

    Dépôts
    DateDescriptionDocumentType

    Bulletin officiel final dissous par radiation volontaire

    1 pagesGAZ2(A)

    Premier avis au Bulletin officiel pour la radiation volontaire

    1 pagesGAZ1(A)

    Demande de radiation de la société du registre du commerce

    3 pagesDS01

    Comptes pour une société dormante établis au 30 sept. 2015

    1 pagesAA

    Déclaration annuelle jusqu'au 22 avr. 2016 avec liste complète des actionnaires

    4 pagesAR01
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    capital27 avr. 2016

    État du capital au 27 avr. 2016

    • Capital: GBP 1
    SH01

    Modification des coordonnées de l'administrateur Mr Darren Paul Marsh le 18 avr. 2016

    2 pagesCH01

    Changement d'adresse du siège social de Hartford Manor Greenbank Lane Northwich Cheshire CW8 1HW à Chelford House Rudheath Way Rudheath Northwich Cheshire CW9 7LN le 22 avr. 2016

    1 pagesAD01

    legacy

    1 pagesSH20

    État du capital au 22 mars 2016

    • Capital: GBP 1
    4 pagesSH19

    legacy

    1 pagesCAP-SS

    Résolutions

    Resolutions
    1 pagesRESOLUTIONS
    Résolutions
    CatégorieDateDescriptionType
    capital

    Résolutions

    Cancel share prem a/c 29/02/2016
    RES13

    Comptes pour une société dormante établis au 30 sept. 2014

    1 pagesAA

    Déclaration annuelle jusqu'au 22 avr. 2015 avec liste complète des actionnaires

    4 pagesAR01
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    capital13 mai 2015

    État du capital au 13 mai 2015

    • Capital: GBP 1
    SH01

    Cessation de la nomination de Alexandra Dilys Williamson en tant que secrétaire le 10 sept. 2014

    1 pagesTM02

    Nomination de Stijn Hendrik Marc Depraetere en tant qu'administrateur le 24 oct. 2014

    2 pagesAP01

    Nomination de Mr Alain Calme en tant qu'administrateur le 10 sept. 2014

    2 pagesAP01

    Nomination de Mr Darren Paul Marsh en tant qu'administrateur le 10 sept. 2014

    2 pagesAP01

    Cessation de la nomination de Navneet Bali en tant que directeur le 10 sept. 2014

    1 pagesTM01

    Cessation de la nomination de Timothy William May en tant que directeur le 10 sept. 2014

    1 pagesTM01

    Période comptable précédente raccourcie du 31 mars 2015 au 30 sept. 2014

    3 pagesAA01

    Comptes annuels établis au 31 mars 2014

    11 pagesAA

    Déclaration annuelle jusqu'au 22 avr. 2014 avec liste complète des actionnaires

    5 pagesAR01
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    capital28 avr. 2014

    État du capital au 28 avr. 2014

    • Capital: GBP 1
    SH01

    Comptes annuels établis au 31 mars 2013

    11 pagesAA

    Déclaration annuelle jusqu'au 22 avr. 2013 avec liste complète des actionnaires

    5 pagesAR01

    Comptes annuels établis au 31 mars 2012

    11 pagesAA

    Qui sont les dirigeants de STARVILLAS LIMITED ?

    Dirigeants
    NomNommé leDate de démissionRôleAdresseIdentification de la sociétéPays de résidenceNationalitéDate de naissanceProfessionNuméro
    CALME, Alain Yvon
    Rudheath Way
    Rudheath
    CW9 7LN Northwich
    Chelford House
    Cheshire
    England
    Administrateur
    Rudheath Way
    Rudheath
    CW9 7LN Northwich
    Chelford House
    Cheshire
    England
    FranceFrench192020080001
    DEPRAETERE, Stijn Hendrik Marc
    Rudheath Way
    Rudheath
    CW9 7LN Northwich
    Chelford House
    Cheshire
    England
    Administrateur
    Rudheath Way
    Rudheath
    CW9 7LN Northwich
    Chelford House
    Cheshire
    England
    EnglandBelgian192132560001
    MARSH, Darren Paul
    Rudheath Way
    Rudheath
    CW9 7LN Northwich
    Chelford House
    Cheshire
    England
    Administrateur
    Rudheath Way
    Rudheath
    CW9 7LN Northwich
    Chelford House
    Cheshire
    England
    EnglandBritish191893900003
    BADDELEY, Robert Gregory
    2 Devisdale Grange
    Groby Road Bowdon
    WA14 2BY Altrincham
    Cheshire
    Secrétaire
    2 Devisdale Grange
    Groby Road Bowdon
    WA14 2BY Altrincham
    Cheshire
    British28024220004
    TYLER, Michael
    8 Green Road
    CT7 9JZ Birchington
    Kent
    Secrétaire
    8 Green Road
    CT7 9JZ Birchington
    Kent
    British66927520001
    WILLIAMSON, Alexandra Dilys
    Greenbank Lane
    CW8 1HW Northwich
    Hartford Manor
    Cheshire
    United Kingdom
    Secrétaire
    Greenbank Lane
    CW8 1HW Northwich
    Hartford Manor
    Cheshire
    United Kingdom
    British100325220002
    ATKINSON, Richard Westaway
    Smithy Lane Farm
    Rainow
    SK10 5UP Macclesfield
    Cheshire
    Administrateur
    Smithy Lane Farm
    Rainow
    SK10 5UP Macclesfield
    Cheshire
    EnglandBritish111861370001
    BADDELEY, Robert Gregory
    Greenbank Lane
    CW8 1HW Northwich
    Hartford Manor
    Cheshire
    United Kingdom
    Administrateur
    Greenbank Lane
    CW8 1HW Northwich
    Hartford Manor
    Cheshire
    United Kingdom
    Great BritainBritish28024220020
    BALI, Navneet
    Greenbank Lane
    CW8 1HW Northwich
    Hartford Manor
    Cheshire
    United Kingdom
    Administrateur
    Greenbank Lane
    CW8 1HW Northwich
    Hartford Manor
    Cheshire
    United Kingdom
    United KingdomBritish83088120002
    BRIGHT, Neil Irvine
    Greenbank Lane
    CW8 1HW Northwich
    Hartford Manor
    Cheshire
    United Kingdom
    Administrateur
    Greenbank Lane
    CW8 1HW Northwich
    Hartford Manor
    Cheshire
    United Kingdom
    United KingdomBritish180993450001
    CARMICHAEL, Robert Neil Bruce
    82 Stanhope Mews East
    SW7 5QT London
    Administrateur
    82 Stanhope Mews East
    SW7 5QT London
    United KingdomBritish65088590001
    CREW, James Robert
    123 Hale Road
    Hale
    WA15 9HQ Altrincham
    Cheshire
    Administrateur
    123 Hale Road
    Hale
    WA15 9HQ Altrincham
    Cheshire
    British15842470001
    GASTER, David
    Camden House
    218 Tonbridge Road
    ME18 5NX Wateringbury
    Kent
    Administrateur
    Camden House
    218 Tonbridge Road
    ME18 5NX Wateringbury
    Kent
    British80205980001
    INWOOD, Ian
    10 Westcott Way
    Cheam
    SM2 7JY Sutton
    Surrey
    Administrateur
    10 Westcott Way
    Cheam
    SM2 7JY Sutton
    Surrey
    British67467320001
    LANDAU, David Aaron
    38 North Audley Street
    Mayfair
    W1K 6ZN London
    Administrateur
    38 North Audley Street
    Mayfair
    W1K 6ZN London
    United KingdomBritish10648180003
    MAY, Timothy William
    Greenbank Lane
    CW8 1HW Northwich
    Hartford Manor
    Cheshire
    United Kingdom
    Administrateur
    Greenbank Lane
    CW8 1HW Northwich
    Hartford Manor
    Cheshire
    United Kingdom
    EnglandBritish27408660003
    SINGH, Sarvindra
    5 Somerset Gardens
    Highgate Gardens
    N6 5EQ London
    Administrateur
    5 Somerset Gardens
    Highgate Gardens
    N6 5EQ London
    EnglandBritish43283210001
    TYLER, Michael
    8 Green Road
    CT7 9JZ Birchington
    Kent
    Administrateur
    8 Green Road
    CT7 9JZ Birchington
    Kent
    United KingdomBritish66927520001

    STARVILLAS LIMITED a-t-elle des charges ?

    Charges
    ClassificationDatesStatutDétails
    Supplemental deed to the debenture and made between eurocamp PLC (the parent) (1) eurocamp hotel services limited and others (the original subsidiaries)
    Créé le 05 nov. 1998
    Livré le 12 nov. 1998
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company and keyline continental limited to the chargee or any of them on any account whatsoever (whether under any of the facility agreements, the facility documents or otherwise)
    Brèves mentions
    Property k/a 92,94 and 96 lind road sutton surrey SM1 4PL t/n SGL208675 SGL9759 and SGL309921. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personnes ayant droit
    • National Westminster Bank PLC
    Transactions
    • 12 nov. 1998Enregistrement d'une charge (395)
    • 19 sept. 2000Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Debenture
    Créé le 12 août 1993
    Livré le 20 août 1993
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personnes ayant droit
    • Barclays Bank PLC
    Transactions
    • 20 août 1993Enregistrement d'une charge (395)
    • 11 nov. 1998Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Legal charge
    Créé le 25 avr. 1989
    Livré le 04 mai 1989
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Freehold property k/a 25/27 high street chesterton cambridge title no. Cb 13402.
    Personnes ayant droit
    • Midland Bank PLC
    Transactions
    • 04 mai 1989Enregistrement d'une charge
    • 13 oct. 1998Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Legal charge
    Créé le 25 avr. 1989
    Livré le 04 mai 1989
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Freehold land to the rear of 25/27 high street chesterton cambridge title no cb 15461.
    Personnes ayant droit
    • Midland Bank PLC
    Transactions
    • 04 mai 1989Enregistrement d'une charge
    • 09 déc. 1993Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Fixed and floating charge
    Créé le 13 févr. 1989
    Livré le 21 févr. 1989
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Fixed & floating charge on all undertaking and all property and assets present and future including book & other debts uncalled capital.
    Personnes ayant droit
    • Midland Bank PLC
    Transactions
    • 21 févr. 1989Enregistrement d'une charge
    • 09 déc. 1993Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Legal charge
    Créé le 07 sept. 1987
    Livré le 18 sept. 1987
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Land at the rear of 25/27, high street, chesterton, cambridgeshire title no cb 15461.
    Personnes ayant droit
    • Barclays Bank PLC
    Transactions
    • 18 sept. 1987Enregistrement d'une charge
    Legal charge
    Créé le 01 juil. 1987
    Livré le 15 juil. 1987
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    25/27 high street chesterton cambridge cambridgeshire title no cb 13402.
    Personnes ayant droit
    • Barclays Bank PLC
    Transactions
    • 15 juil. 1987Enregistrement d'une charge
    Debenture
    Créé le 01 juil. 1987
    Livré le 15 juil. 1987
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personnes ayant droit
    • Barclays Bank PLC
    Transactions
    • 15 juil. 1987Enregistrement d'une charge
    • 19 mars 1992Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Legal mortgage
    Créé le 26 janv. 1978
    Livré le 13 févr. 1978
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    25 & 27 high st, chesterton, cambridge and land at rear thereof title no cb 13402 and cb 15461. floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Personnes ayant droit
    • National Westminster Bank PLC
    Transactions
    • 13 févr. 1978Enregistrement d'une charge
    • 19 mars 1992Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)

    Source de données

    • Companies House du Royaume-Uni
      Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers.
    • Licence: CC0