STALEY PROPERTIES INVESTMENT LIMITED

STALEY PROPERTIES INVESTMENT LIMITED

  • Vue d'ensemble
  • Résumé
  • Objet social
  • Adresse
  • Comptes
  • Dépôts
  • Dirigeants
  • Personnes ayant un contrôle significatif
  • Charges
  • Insolvabilité
  • Source de données
  • Vue d'ensemble

    Nom de la sociétéSTALEY PROPERTIES INVESTMENT LIMITED
    Statut de la sociétéDissoute
    Forme juridiqueSociété à responsabilité limitée
    Numéro de société 00834719
    JuridictionAngleterre/Pays de Galles
    Date de création
    Date de cessation d'activité

    Résumé

    A des PSCs super sécurisésNon
    A des chargesOui
    A un historique d'insolvabilitéOui
    Le siège social est contestéNon

    Quel est l'objet de STALEY PROPERTIES INVESTMENT LIMITED ?

    • Autre location et exploitation de biens immobiliers propres ou loués (68209) / Activités immobilières

    Où se situe STALEY PROPERTIES INVESTMENT LIMITED ?

    Adresse du siège social
    41 Greek Street
    SK3 8AX Stockport
    Cheshire
    Adresse du siège social non livrableNon

    Quels sont les derniers comptes de STALEY PROPERTIES INVESTMENT LIMITED ?

    Derniers comptes
    Derniers comptes arrêtés au31 mars 2015

    Quels sont les derniers dépôts pour STALEY PROPERTIES INVESTMENT LIMITED ?

    Dépôts
    DateDescriptionDocumentType

    Gazette finale dissoute à la suite d'une liquidation

    1 pagesGAZ2

    Retour de la réunion finale dans une liquidation volontaire des membres

    11 pagesLIQ13

    Déclaration des reçus et paiements des liquidateurs jusqu'à 02 nov. 2019

    11 pagesLIQ03

    Déclaration des reçus et paiements des liquidateurs jusqu'à 02 nov. 2018

    9 pagesLIQ03

    Changement d'adresse du siège social de Booth Street Chambers Booth Street Ashton-Under-Lyne OL6 7LQ England à 41 Greek Street Stockport Cheshire SK3 8AX le 23 nov. 2017

    2 pagesAD01

    Nomination d'un liquidateur volontaire

    1 pages600

    Résolutions

    Resolutions
    2 pagesRESOLUTIONS
    Résolutions
    CatégorieDateDescriptionType
    liquidation

    Résolution spéciale pour la liquidation au 03 nov. 2017

    LRESSP

    Déclaration de solvabilité

    7 pagesLIQ01

    La procédure de radiation d'office a été suspendue

    1 pagesDISS16(SOAS)

    Premier avis au Bulletin officiel pour la radiation d'office

    1 pagesGAZ1

    Changement d'adresse du siège social de Cheethams House 96 Market Street Stalybridge Cheshire SK15 2AB à Booth Street Chambers Booth Street Ashton-Under-Lyne OL6 7LQ le 20 févr. 2017

    1 pagesAD01

    Déclaration de confirmation établie le 06 déc. 2016 avec mises à jour

    7 pagesCS01

    Période comptable précédente prolongée du 31 mars 2016 au 30 sept. 2016

    1 pagesAA01

    Déclaration annuelle jusqu'au 06 déc. 2015 avec liste complète des actionnaires

    5 pagesAR01
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    capital04 janv. 2016

    État du capital au 04 janv. 2016

    • Capital: GBP 75
    SH01

    Modification des coordonnées de l'administrateur Ms Catherine Atkinson le 06 déc. 2014

    2 pagesCH01

    Comptes d'exonération totale pour petite entreprise établis au 31 mars 2015

    8 pagesAA

    Cessation de la nomination de Geoffrey Lees Eckersall en tant que directeur le 05 août 2015

    1 pagesTM01

    Déclaration annuelle jusqu'au 06 déc. 2014 avec liste complète des actionnaires

    6 pagesAR01
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    capital08 déc. 2014

    État du capital au 08 déc. 2014

    • Capital: GBP 75
    SH01

    Comptes d'exonération totale pour petite entreprise établis au 31 mars 2014

    8 pagesAA

    Déclaration annuelle jusqu'au 06 déc. 2013 avec liste complète des actionnaires

    6 pagesAR01
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    capital10 déc. 2013

    État du capital au 10 déc. 2013

    • Capital: GBP 75
    SH01

    Comptes d'exonération totale pour petite entreprise établis au 31 mars 2013

    8 pagesAA

    Déclaration annuelle jusqu'au 06 déc. 2012 avec liste complète des actionnaires

    6 pagesAR01

    Comptes d'exonération totale pour petite entreprise établis au 31 mars 2012

    8 pagesAA

    Comptes d'exonération totale pour petite entreprise établis au 31 mars 2011

    7 pagesAA

    Déclaration annuelle jusqu'au 06 déc. 2011 avec liste complète des actionnaires

    6 pagesAR01

    Qui sont les dirigeants de STALEY PROPERTIES INVESTMENT LIMITED ?

    Dirigeants
    NomNommé leDate de démissionRôleAdresseIdentification de la sociétéPays de résidenceNationalitéDate de naissanceProfessionNuméro
    ATKINSON, Catherine
    Astley Grove
    SK15 1NL Stalybridge
    7
    Cheshire
    United Kingdom
    Administrateur
    Astley Grove
    SK15 1NL Stalybridge
    7
    Cheshire
    United Kingdom
    EnglandBritish156363950001
    DAWSON, Amanda
    Avondale Road
    Carlton
    NG4 1AF Nottingham
    28
    England
    Administrateur
    Avondale Road
    Carlton
    NG4 1AF Nottingham
    28
    England
    EnglandBritish156364030001
    DAWSON, Hillary
    Studd Street
    N1 0QJ London
    6
    United Kingdom
    Administrateur
    Studd Street
    N1 0QJ London
    6
    United Kingdom
    EnglandBritish156363540001
    ECKERSALL, Geoffrey Lees
    2 Heather Grove
    Hollingworth
    SK14 8JL Hyde
    Cheshire
    Secrétaire
    2 Heather Grove
    Hollingworth
    SK14 8JL Hyde
    Cheshire
    British9521400001
    ATKINSON, Catherine
    89 Spring Bank
    SK15 2EQ Stalybridge
    Cheshire
    Administrateur
    89 Spring Bank
    SK15 2EQ Stalybridge
    Cheshire
    British79383550002
    DAWSON, Christine
    6 Crabtree Avenue
    Disley
    SK12 2DD Stockport
    Cheshire
    Administrateur
    6 Crabtree Avenue
    Disley
    SK12 2DD Stockport
    Cheshire
    British71750010001
    DAWSON, Philip
    Par Wood
    4 Stanley Hall Lane
    SK12 2JT Disley Via Stockport
    Cheshire
    Administrateur
    Par Wood
    4 Stanley Hall Lane
    SK12 2JT Disley Via Stockport
    Cheshire
    British7797640001
    ECKERSALL, Geoffrey Lees
    2 Heather Grove
    Hollingworth
    SK14 8JL Hyde
    Cheshire
    Administrateur
    2 Heather Grove
    Hollingworth
    SK14 8JL Hyde
    Cheshire
    EnglandBritish9521400001

    Qui sont les personnes ayant un contrôle significatif sur STALEY PROPERTIES INVESTMENT LIMITED ?

    Personnes ayant un contrôle significatif
    NomNotifié leAdresseCessé
    Mrs Catherine Atkinson
    Greek Street
    SK3 8AX Stockport
    41
    Cheshire
    06 avr. 2016
    Greek Street
    SK3 8AX Stockport
    41
    Cheshire
    Non
    Nationalité: British
    Pays de résidence: England
    Nature du contrôle
    • La personne détient, directement ou indirectement, plus de 25 % mais pas plus de 50 % des actions de la société.
    Ms Hillary Dawson
    Greek Street
    SK3 8AX Stockport
    41
    Cheshire
    06 avr. 2016
    Greek Street
    SK3 8AX Stockport
    41
    Cheshire
    Non
    Nationalité: British
    Pays de résidence: England
    Nature du contrôle
    • La personne détient, directement ou indirectement, plus de 25 % mais pas plus de 50 % des actions de la société.
    Miss Amanda Dawson
    Greek Street
    SK3 8AX Stockport
    41
    Cheshire
    06 avr. 2016
    Greek Street
    SK3 8AX Stockport
    41
    Cheshire
    Non
    Nationalité: British
    Pays de résidence: England
    Nature du contrôle
    • La personne détient, directement ou indirectement, plus de 25 % mais pas plus de 50 % des actions de la société.

    STALEY PROPERTIES INVESTMENT LIMITED a-t-elle des charges ?

    Charges
    ClassificationDatesStatutDétails
    Mortgage
    Créé le 01 juil. 2010
    Livré le 03 juil. 2010
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    F/H property k/a denham house grosvenor street stalybridge t/no. GM243488 together with all buildings & fixtures (including trade fixtures). Fixed plant & machinery by way of fixed charge, all present & future book & other debts, floating charge over all moveable plant machinery, implements, utensils, furniture & equipment by way of assignment. The goodwill of the business (if any), the full benefit of all licences & guarantees.
    Personnes ayant droit
    • Lloyds Tsb Bank PLC
    Transactions
    • 03 juil. 2010Enregistrement d'une charge (MG01)
    • 24 févr. 2011Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (MG02)
    Mortgage
    Créé le 01 juil. 2010
    Livré le 03 juil. 2010
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    F/H property the boars head now k/a cheethams house 96 market street stalybridge t/no. GM476089 together with all buildings & fixtures (including trade fixtures). Fixed plant & machinery by way of fixed charge, all present & future book & other debts, floating charge over all moveable plant machinery, implements, utensils, furniture & equipment by way of assignment. The goodwill of the business (if any), the full benefit of all licences & guarantees.
    Personnes ayant droit
    • Lloyds Tsb Bank PLC
    Transactions
    • 03 juil. 2010Enregistrement d'une charge (MG01)
    • 24 févr. 2011Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (MG02)
    Legal charge
    Créé le 09 sept. 1996
    Livré le 10 sept. 1996
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    The property k/a 80 newton road newton hyde t/n GM69627.
    Personnes ayant droit
    • Tsb Bank PLC
    Transactions
    • 10 sept. 1996Enregistrement d'une charge (395)
    • 24 févr. 2011Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (MG02)
    Legal charge
    Créé le 09 sept. 1996
    Livré le 10 sept. 1996
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    The property k/a 19 higher tame street stalybridge t/n GM563299.
    Personnes ayant droit
    • Tsb Bank PLC
    Transactions
    • 10 sept. 1996Enregistrement d'une charge (395)
    • 24 févr. 2011Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (MG02)
    Legal charge
    Créé le 02 mai 1995
    Livré le 16 mai 1995
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    F/H property situate and k/as denham house grosvenor street stalybridge cheshire.t/no.GM243488.
    Personnes ayant droit
    • Tsb Bank PLC
    Transactions
    • 16 mai 1995Enregistrement d'une charge (395)
    • 24 févr. 2011Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (MG02)
    Legal charge
    Créé le 10 janv. 1995
    Livré le 13 janv. 1995
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    F/H premises k/a 10 portland place mottram road stalybridge cheshire t/n GM312058.
    Personnes ayant droit
    • Tsb Bank PLC
    Transactions
    • 13 janv. 1995Enregistrement d'une charge (395)
    • 24 févr. 2011Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (MG02)
    Legal charge
    Créé le 10 janv. 1995
    Livré le 13 janv. 1995
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    F/H property k/a 96 market street stalybridge t/n GM476089.
    Personnes ayant droit
    • Tsb Bank PLC
    Transactions
    • 13 janv. 1995Enregistrement d'une charge (395)
    • 24 févr. 2011Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (MG02)
    Legal charge
    Créé le 09 janv. 1995
    Livré le 10 janv. 1995
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    5 and 7 portland place mottram road stalybridge cheshire t/n gm 300318 and gm 69445. see the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Tsb Bank PLC
    Transactions
    • 10 janv. 1995Enregistrement d'une charge (395)
    • 24 févr. 2011Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (MG02)
    Legal charge
    Créé le 05 sept. 1991
    Livré le 11 sept. 1991
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Supermarket and shops situate at the square, keyworth, nottingham.
    Personnes ayant droit
    • Tsb Bank PLC
    Transactions
    • 11 sept. 1991Enregistrement d'une charge
    • 24 févr. 2011Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (MG02)
    Legal charge
    Créé le 28 juil. 1986
    Livré le 06 août 1986
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    F/H property k/a 4 and 18 gordon terrace stalybridge manchester.
    Personnes ayant droit
    • Tsb England and Walesand Its Custodian Trustees
    Transactions
    • 06 août 1986Enregistrement d'une charge
    • 24 févr. 2011Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (MG02)
    Legal charge
    Créé le 28 juil. 1986
    Livré le 06 août 1986
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    216/218 katherine street ashton under lyne greater manchester title no la 49551.
    Personnes ayant droit
    • Tsb England and Walesand Its Custodian Trustees
    Transactions
    • 06 août 1986Enregistrement d'une charge
    • 24 févr. 2011Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (MG02)
    Legal charge
    Créé le 28 juil. 1986
    Livré le 06 août 1986
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    F/H property k/a 87 market street stalybridge manchester.
    Personnes ayant droit
    • T S B England and Walesand Its Custodian Trustees
    Transactions
    • 06 août 1986Enregistrement d'une charge
    • 24 févr. 2011Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (MG02)
    Legal charge
    Créé le 28 juil. 1986
    Livré le 06 août 1986
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Land in bridge street, peel street and duke street, stalybridge manchester title no:- sh 372021.
    Personnes ayant droit
    • T S B England and Walesand Its Custodian Trustees
    Transactions
    • 06 août 1986Enregistrement d'une charge
    • 24 févr. 2011Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (MG02)
    Legal charge
    Créé le 28 juil. 1986
    Livré le 06 août 1986
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    F/H property k/a 17 stamford street stalybridge manchester.
    Personnes ayant droit
    • T S B England and Walesand Its Custodian Trustees
    Transactions
    • 06 août 1986Enregistrement d'une charge
    • 13 mars 2002Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Legal charge
    Créé le 28 juil. 1986
    Livré le 06 août 1986
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    F/H property k/a 9A cheetham hill road dukinfield manchester.
    Personnes ayant droit
    • Tsb England and Walesand Its Custodian Trustees
    Transactions
    • 06 août 1986Enregistrement d'une charge
    • 24 févr. 2011Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (MG02)
    Legal charge
    Créé le 28 juil. 1986
    Livré le 06 août 1986
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    F/H property k/a 46 chapel street dukinfield manchester.
    Personnes ayant droit
    • Tsb England and Walesand Its Custodian Trustees
    Transactions
    • 06 août 1986Enregistrement d'une charge
    • 24 févr. 2011Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (MG02)
    Legal charge
    Créé le 28 juil. 1986
    Livré le 06 août 1986
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    212 katherine street ashton-under-lyne greater manchester title no gm 103614.
    Personnes ayant droit
    • Tsb England and Walesand Its Custodian Trustees
    Transactions
    • 06 août 1986Enregistrement d'une charge
    • 24 févr. 2011Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (MG02)
    Legal charge
    Créé le 28 juil. 1986
    Livré le 06 août 1986
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    80 and 86 ashton road newton hyde greater manchester title no gm 69627.
    Personnes ayant droit
    • Tbs England and Walesand Its Custodian Trustees
    Transactions
    • 06 août 1986Enregistrement d'une charge
    • 24 févr. 2011Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (MG02)
    Legal charge
    Créé le 28 juil. 1986
    Livré le 06 août 1986
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Land and buildings on the south side of north street ashton-under-lyne title no-gm 8925.
    Personnes ayant droit
    • Tsb England and Walesand Its Custodian Trustees
    Transactions
    • 06 août 1986Enregistrement d'une charge
    • 24 févr. 2011Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (MG02)
    Legal charge
    Créé le 28 juil. 1986
    Livré le 06 août 1986
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Clarence arcade buildings stamford street ashton under lyne greater manchester title no gm 120007.
    Personnes ayant droit
    • Tsb England and Walesand Its Custodian Trustees
    Transactions
    • 06 août 1986Enregistrement d'une charge
    • 24 févr. 2011Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (MG02)
    Mortgage debenture
    Créé le 28 juin 1986
    Livré le 04 juil. 1986
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personnes ayant droit
    • Tsb England & Wales.
    Transactions
    • 04 juil. 1986Enregistrement d'une charge
    • 13 mars 2002Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Legal mortgage
    Créé le 17 août 1982
    Livré le 07 juin 1982
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    11 portland place, stalybridge, tameside greater manchester tn no gm 240066. floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Personnes ayant droit
    • National Westminster Bank PLC
    Transactions
    • 07 juin 1982Enregistrement d'une charge
    Legal charge
    Créé le 22 avr. 1980
    Livré le 22 avr. 1980
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    F/H 17 stamford street stalyoridge greater manchester. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Personnes ayant droit
    • National Westminster Bank PLC
    Transactions
    • 22 avr. 1980Enregistrement d'une charge
    Legal mortgage
    Créé le 22 avr. 1980
    Livré le 22 avr. 1980
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    F/H 216 & 218 katherine street ashton-under-lyne tameside greater manchester & all buildings la 149551. floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Personnes ayant droit
    • National Westminster Bank PLC
    Transactions
    • 22 avr. 1980Enregistrement d'une charge
    Legal charge
    Créé le 10 oct. 1977
    Livré le 27 oct. 1977
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Part of clarence arcade buildings stamford street/delsmere st. Ashton-under-lyne title no gm 58809. floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Personnes ayant droit
    • National Westminster Bank PLC
    Transactions
    • 27 oct. 1977Enregistrement d'une charge
    • 24 févr. 2011Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (MG02)

    STALEY PROPERTIES INVESTMENT LIMITED a-t-elle des procédures d'insolvabilité ?

    Numéro de dossierDatesTypePraticiensAutre
    1
    DateType
    03 nov. 2017Commencement of winding up
    26 févr. 2021Dissolved on
    Members voluntary liquidation
    NomRôleAdresseNommé leCessé le
    Andrew Bland
    41 Greek Street
    SK3 8AX Stockport
    Cheshire
    practitioner
    41 Greek Street
    SK3 8AX Stockport
    Cheshire

    Source de données

    • Companies House du Royaume-Uni
      Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers.
    • Licence: CC0