CAPITAL BANK LEASING 3 LIMITED

CAPITAL BANK LEASING 3 LIMITED

  • Vue d'ensemble
  • Résumé
  • Objet social
  • Adresse
  • Dénominations sociales précédentes
  • Comptes
  • Déclaration de confirmation
  • Dépôts
  • Dirigeants
  • Personnes ayant un contrôle significatif
  • Charges
  • Insolvabilité
  • Source de données
  • Vue d'ensemble

    Nom de la sociétéCAPITAL BANK LEASING 3 LIMITED
    Statut de la sociétéLiquidation
    Forme juridiqueSociété à responsabilité limitée
    Numéro de société 00836962
    JuridictionAngleterre/Pays de Galles
    Date de création

    Résumé

    A des PSCs super sécurisésNon
    A des chargesOui
    A un historique d'insolvabilitéOui
    Le siège social est contestéNon

    Quel est l'objet de CAPITAL BANK LEASING 3 LIMITED ?

    • Crédit-bail (64910) / Activités financières et d'assurance

    Où se situe CAPITAL BANK LEASING 3 LIMITED ?

    Adresse du siège social
    1 More London Place
    SE1 2AF London
    Adresse du siège social non livrableNon

    Quels étaient les noms précédents de CAPITAL BANK LEASING 3 LIMITED ?

    Dénominations sociales précédentes
    Nom de la sociétéDeJusqu'au
    NWS 3 LIMITED08 févr. 196508 févr. 1965

    Quels sont les derniers comptes de CAPITAL BANK LEASING 3 LIMITED ?

    En retardOui
    Prochains comptes
    Fin de la prochaine période comptable le31 mars 2019
    Date d'échéance des prochains comptes31 déc. 2019
    Derniers comptes
    Derniers comptes arrêtés au31 mars 2018

    Quel est le statut de la dernière déclaration de confirmation pour CAPITAL BANK LEASING 3 LIMITED ?

    En retardOui
    Dernière déclaration de confirmation établie jusqu'au01 févr. 2020
    Date d'échéance de la prochaine déclaration de confirmation15 févr. 2020
    Dernière déclaration de confirmation
    Prochaine déclaration de confirmation établie jusqu'au01 févr. 2019
    En retardOui

    Quels sont les derniers dépôts pour CAPITAL BANK LEASING 3 LIMITED ?

    Dépôts
    DateDescriptionDocumentType

    Déclaration des reçus et paiements des liquidateurs jusqu'à 30 oct. 2024

    9 pagesLIQ03
    YDI9O3HT

    Cessation de la nomination de John Robert Turner en tant que directeur le 30 janv. 2024

    1 pagesTM01
    ACWK9FX4

    Déclaration des reçus et paiements des liquidateurs jusqu'à 30 oct. 2023

    9 pagesLIQ03
    YCGO9AW0

    Nomination de Nicholas Andrew Williams en tant qu'administrateur le 28 oct. 2022

    2 pagesAP01
    XBJHMLZU

    Cessation de la nomination de Richard Andrew Jones en tant que directeur le 28 oct. 2022

    1 pagesTM01
    XBJHMLWI

    Déclaration des reçus et paiements des liquidateurs jusqu'à 30 oct. 2022

    9 pagesLIQ03
    YBHTNQ20

    Déclaration des reçus et paiements des liquidateurs jusqu'à 30 oct. 2021

    10 pagesLIQ03
    YAID94WH

    Déclaration des reçus et paiements des liquidateurs jusqu'à 30 oct. 2020

    9 pagesLIQ03
    Y9VJYM7U

    Cessation de la nomination de Alyson Elizabeth Mulholland en tant que secrétaire le 08 sept. 2020

    1 pagesTM02
    X9DAFI5L

    Les registres ont été transférés au lieu d'inspection enregistré Cawley House Chester Business Park Chester Cheshire CH4 9FB

    2 pagesAD03
    A8HVW195

    Changement d'adresse du siège social de Charterhall House Charterhall Drive Chester Cheshire CH88 3AN à 1 More London Place London SE1 2AF le 15 nov. 2019

    2 pagesAD01
    A8HVW19L

    L'adresse d'inspection du registre a été modifiée à Cawley House Chester Business Park Chester Cheshire CH4 9FB

    2 pagesAD02
    A8HVW19D

    Nomination d'un liquidateur volontaire

    3 pages600
    A8HVW19T

    Résolutions

    Resolutions
    1 pagesRESOLUTIONS
    Résolutions
    CatégorieDateDescriptionType
    liquidation

    Résolution spéciale pour la liquidation au 31 oct. 2019

    LRESSP

    Déclaration de solvabilité

    5 pagesLIQ01
    A8HVW134

    Modification des coordonnées du secrétaire Alyson Elizabeth Mulholland le 04 mars 2019

    1 pagesCH03
    X84Y3P3T

    Déclaration de confirmation établie le 01 févr. 2019 sans mise à jour

    3 pagesCS01
    X7YLQG08

    Modification des coordonnées de l'administrateur Mr Richard Andrew Jones le 25 janv. 2019

    2 pagesCH01
    X7XVEUIB

    Modification des coordonnées de l'administrateur Mr John Robert Turner le 04 janv. 2019

    2 pagesCH01
    X7WRNZR7

    Comptes annuels établis au 31 mars 2018

    21 pagesAA
    S7LHLDQG

    Cessation de la nomination de Gerard Ashley Fox en tant que directeur le 24 juil. 2018

    1 pagesTM01
    X7AYNDHL

    Cessation de la nomination de Andrew John Kemp en tant que directeur le 24 juil. 2018

    1 pagesTM01
    X7AYNDFE

    Modification des coordonnées de l'administrateur Mr Andrew John Kemp le 06 avr. 2018

    2 pagesCH01
    X73H5HE3

    Déclaration de confirmation établie le 01 févr. 2018 avec mises à jour

    4 pagesCS01
    X6Z6A5D6

    Comptes annuels établis au 31 mars 2017

    22 pagesAA
    A6LN4MV6

    Qui sont les dirigeants de CAPITAL BANK LEASING 3 LIMITED ?

    Dirigeants
    NomNommé leDate de démissionRôleAdresseIdentification de la sociétéPays de résidenceNationalitéDate de naissanceProfessionNuméro
    WILLIAMS, Nicholas Andrew
    Cheadle Heath
    SK3 0RB Stockport
    Heathside Park
    Cheshire
    United Kingdom
    Administrateur
    Cheadle Heath
    SK3 0RB Stockport
    Heathside Park
    Cheshire
    United Kingdom
    United KingdomBritishDirector301976570001
    GITTINS, Paul
    House
    Charterhall Drive
    CH88 3AN Chester
    Tower
    United Kingdom
    Secrétaire
    House
    Charterhall Drive
    CH88 3AN Chester
    Tower
    United Kingdom
    British45660860003
    JOHNSON, Michelle Antoinette Angela
    Tower House
    Charterhall Drive
    CH88 3AN Chester
    1st Floor East
    England
    England
    Secrétaire
    Tower House
    Charterhall Drive
    CH88 3AN Chester
    1st Floor East
    England
    England
    212718920001
    MULHOLLAND, Alyson Elizabeth
    Chester Business Park
    CH4 9FB Chester
    Cawley House
    United Kingdom
    Secrétaire
    Chester Business Park
    CH4 9FB Chester
    Cawley House
    United Kingdom
    239870800001
    NIXON, Raymond
    Holly House The Steadings
    Wicker Lane, Guilden Sutton
    CH3 7EL Chester
    Cheshire
    Secrétaire
    Holly House The Steadings
    Wicker Lane, Guilden Sutton
    CH3 7EL Chester
    Cheshire
    British36433110016
    BALLINGALL, Stuart James
    39 Craigleith Drive
    EH4 3JU Edinburgh
    Midlothian
    Administrateur
    39 Craigleith Drive
    EH4 3JU Edinburgh
    Midlothian
    BritishChartered Accountant118506820001
    BARCLAY, William Gordon
    The Coulin
    122 Stanstead Road
    CR3 6AE Caterham
    Surrey
    Administrateur
    The Coulin
    122 Stanstead Road
    CR3 6AE Caterham
    Surrey
    BritishDirector33196560002
    BLACKWELL, Timothy Mark
    Tresillian Terrace
    CF10 5BH Cardiff
    St William House
    United Kingdom
    Administrateur
    Tresillian Terrace
    CF10 5BH Cardiff
    St William House
    United Kingdom
    EnglandBritishDirector124967310001
    BOCHENSKI, Anthony Joseph John
    Greenacres
    Bryn Offa Lane
    CH7 6RQ Mold
    Flintshire
    Administrateur
    Greenacres
    Bryn Offa Lane
    CH7 6RQ Mold
    Flintshire
    United KingdomBritishCompany Solicitor145644720001
    BROWN, John Sydney
    15 Newick Avenue
    Little Aston
    B74 3DA Sutton Coldfield
    West Midlands
    Administrateur
    15 Newick Avenue
    Little Aston
    B74 3DA Sutton Coldfield
    West Midlands
    United KingdomBritishCompany Director58961420001
    BUSH, Claude Harry
    51 Church Croft
    Dodleston
    CH4 9NT Chester
    Cheshire
    Administrateur
    51 Church Croft
    Dodleston
    CH4 9NT Chester
    Cheshire
    BritishCompany Director427540002
    CHESSMAN, Steven David Russell
    Charterhall Drive
    CH88 3AN Chester
    Tower House
    United Kingdom
    Administrateur
    Charterhall Drive
    CH88 3AN Chester
    Tower House
    United Kingdom
    EnglandBritishSales Director135147710001
    EDWARDS, Jayson
    Tresillian Terrace
    CF10 5BH Cardiff
    St William House
    United Kingdom
    Administrateur
    Tresillian Terrace
    CF10 5BH Cardiff
    St William House
    United Kingdom
    WalesBritishAccountant165227870001
    FERGUSON, Gordon
    St Vincent Street
    G2 5ER Glasgow
    110
    United Kingdom
    Administrateur
    St Vincent Street
    G2 5ER Glasgow
    110
    United Kingdom
    ScotlandBritishHead Of Operations87681450001
    FOX, Gerard Ashley
    London Wall
    EC2Y 5AJ London
    125
    United Kingdom
    Administrateur
    London Wall
    EC2Y 5AJ London
    125
    United Kingdom
    EnglandBritishBanker179100520001
    GRACE, Adrian Thomas
    Charterhall Drive
    CH88 3AN Chester
    Charterhall House
    Cheshire
    Administrateur
    Charterhall Drive
    CH88 3AN Chester
    Charterhall House
    Cheshire
    BritishManaging Director128752720001
    GRIFFITHS, Michael John David, Mr.
    House
    Charterhall Drive
    CH88 3AN Chester
    Tower
    United Kingdom
    Administrateur
    House
    Charterhall Drive
    CH88 3AN Chester
    Tower
    United Kingdom
    United KingdomBritishDirector95344900001
    HAMMOND, John Sidney
    65 Poulton Road
    Spital
    L63 9LD Bebington
    Merseyside
    Administrateur
    65 Poulton Road
    Spital
    L63 9LD Bebington
    Merseyside
    BritishAssistant General Manager102290001
    HARE, Robert Brown
    13 Balgreen Avenue
    EH12 5SX Edinburgh
    Lothian
    Administrateur
    13 Balgreen Avenue
    EH12 5SX Edinburgh
    Lothian
    BritishDirector64474720003
    HARRIS, Kevin Charles
    London Wall
    EC2Y 5AJ London
    125
    United Kingdom
    Administrateur
    London Wall
    EC2Y 5AJ London
    125
    United Kingdom
    United KingdomBritishDirector170091040001
    JONES, Richard Andrew
    37 South Gyle Crescent
    EH12 9DS Edinburgh
    Ettrick House
    United Kingdom
    Administrateur
    37 South Gyle Crescent
    EH12 9DS Edinburgh
    Ettrick House
    United Kingdom
    United KingdomBritishDirector130118640005
    KEMP, Andrew John
    Canons House
    Canons Way
    BS1 5LL Bristol
    Ground Floor
    United Kingdom
    Administrateur
    Canons House
    Canons Way
    BS1 5LL Bristol
    Ground Floor
    United Kingdom
    EnglandBritishDirector222042280001
    LITTLER, Roy
    3 The Paddock
    Curzon Park
    CH4 8AE Chester
    Cheshire
    Administrateur
    3 The Paddock
    Curzon Park
    CH4 8AE Chester
    Cheshire
    BritishDeputy Managing Director2211250001
    MERCER, John Alexander
    Llwyn-Y-Cyll
    Lixwm
    CH8 8LY Holywell
    Clwyd
    Administrateur
    Llwyn-Y-Cyll
    Lixwm
    CH8 8LY Holywell
    Clwyd
    BritishManaging Director4672880001
    MORRISSEY, John Michael
    House
    Charterhall Drive
    CH88 3AN Chester
    Tower
    United Kingdom
    Administrateur
    House
    Charterhall Drive
    CH88 3AN Chester
    Tower
    United Kingdom
    EnglandBritishChartered Accountant94094650001
    PERRY, Michael Richard
    10 The Paddock
    Willaston
    CW5 7HJ Nantwich
    Cheshire
    Administrateur
    10 The Paddock
    Willaston
    CW5 7HJ Nantwich
    Cheshire
    BritishCompany Director102300002
    REID, George Gibson
    46/1 Morningside Park
    EH10 5HA Edinburgh
    Lothian
    Administrateur
    46/1 Morningside Park
    EH10 5HA Edinburgh
    Lothian
    BritishAccountant95498730001
    RITCHIE, Carol Ann
    34 Hob Hey Lane
    Culcheth
    WA3 4NW Warrington
    Cheshire
    Administrateur
    34 Hob Hey Lane
    Culcheth
    WA3 4NW Warrington
    Cheshire
    EnglandBritishChief Accountant46402710001
    SKINNER, Trevor John
    2 Tudor Court
    B95 4AP Henly In Arden
    Warwickshire
    Administrateur
    2 Tudor Court
    B95 4AP Henly In Arden
    Warwickshire
    BritishAssistant General Manager427570015
    STAPLES, Martin Kenneth
    1 Douglas Drive
    Crossford
    KY12 8PB Dunfermline
    Fife
    Administrateur
    1 Douglas Drive
    Crossford
    KY12 8PB Dunfermline
    Fife
    ScotlandBritishAccountant110383950001
    SUTTON, Christopher
    Orchard Brae
    EH4 1PF Edinburgh
    Finance House
    United Kingdom
    Administrateur
    Orchard Brae
    EH4 1PF Edinburgh
    Finance House
    United Kingdom
    ScotlandBritishConsumer Finance Director130660440002
    TOWN, Lindsay John
    10 Ferndale
    TN2 3PB Tunbridge Wells
    Kent
    Administrateur
    10 Ferndale
    TN2 3PB Tunbridge Wells
    Kent
    EnglandBritishManaging Director64287260001
    TRACE, James Owen
    House
    Charterhall Drive
    CH88 3AN Chester
    Tower
    United Kingdom
    Administrateur
    House
    Charterhall Drive
    CH88 3AN Chester
    Tower
    United Kingdom
    EnglandBritishSenior Manager159477760001
    TURNER, John Robert
    Gresham Street
    EC2V 7AE London
    10
    United Kingdom
    Administrateur
    Gresham Street
    EC2V 7AE London
    10
    United Kingdom
    EnglandBritishDirector76185650001
    WEBSTER, Alistair Linn
    7 Ettrick Road
    EH10 5BJ Edinburgh
    Administrateur
    7 Ettrick Road
    EH10 5BJ Edinburgh
    ScotlandBritishAccountant60101190002

    Qui sont les personnes ayant un contrôle significatif sur CAPITAL BANK LEASING 3 LIMITED ?

    Personnes ayant un contrôle significatif
    NomNotifié leAdresseCessé
    EH1 1YZ Edinburgh
    The Mound
    United Kingdom
    06 avr. 2016
    EH1 1YZ Edinburgh
    The Mound
    United Kingdom
    Non
    Forme juridiquePublic Limited Company
    Pays d'enregistrementScotland
    Autorité légaleUnited Kingdom (Scotland)
    Lieu d'enregistrementCompanies House
    Numéro d'enregistrementSc327000
    Nature du contrôle
    • La personne détient, directement ou indirectement, plus de 75 % des actions de la société.
    • La personne détient, directement ou indirectement, plus de 75 % des droits de vote dans la société.
    • La personne détient, directement ou indirectement, le droit de nommer ou de révoquer une majorité des membres du conseil d'administration de la société.

    CAPITAL BANK LEASING 3 LIMITED a-t-elle des charges ?

    Charges
    ClassificationDatesStatutDétails
    Letter of charge
    Créé le 19 juin 1996
    Livré le 10 juil. 1996
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    All monies standing to the credit of any account or accounts in the banks books.
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transactions
    • 10 juil. 1996Enregistrement d'une charge (395)
    • 24 mai 1997Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Letter of charge
    Créé le 20 févr. 1995
    Livré le 22 févr. 1995
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All moneys due or to become due from the principal debtors (as defined) or any of them to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    All moneyd standing to the credit of the company with the bank.
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transactions
    • 22 févr. 1995Enregistrement d'une charge (395)
    • 09 août 1996Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Letter of charge
    Créé le 13 déc. 1994
    Livré le 23 déc. 1994
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All moneys due or to become due from all the companys named therein to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    All moneys standing to the credit of any account of the company with the bank.
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transactions
    • 23 déc. 1994Enregistrement d'une charge (395)
    • 22 févr. 1995Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Letter of charge
    Créé le 12 août 1993
    Livré le 20 août 1993
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All moneys due or to become due from the company and/or all orany of the companies named in the charge to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    All moneys standing to the credit of any account of the company with the bank.
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transactions
    • 20 août 1993Enregistrement d'une charge (395)
    • 23 déc. 1994Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Deed of covenant
    Créé le 20 mars 1987
    Livré le 25 mars 1987
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    £4,200,000 and all other moneys due or to become due from the company and/or sealink U.K. limited to the chargee under the terms of a financial agreement dated 31 jan 86 the mortgage and this deed both of even date (each as may from time to time be amended)
    Brèves mentions
    All the rights title interest and benefits in and under:- a) M.V. "st. Cecilia" registered at the port of london under official no. 712850B) the earnings and insurances of the vessel and any compensation payable in respect of requisition for title or other compulsory acquisition of the vessel.
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transactions
    • 25 mars 1987Enregistrement d'une charge
    • 05 juin 1995Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Statutory mortgage
    Créé le 20 mars 1987
    Livré le 25 mars 1987
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on an account current under the terms of a deed of covenant of even date and regulated by a financial agreement dated 31 jan 86 (each as may from time to time be amneded)
    Brèves mentions
    64/64TH shares of and in M.V. "st. Cecilia" registered at the port of london under official no. 712850.
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transactions
    • 25 mars 1987Enregistrement d'une charge
    • 05 juin 1995Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Shipowners agreement
    Créé le 31 janv. 1986
    Livré le 03 févr. 1986
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    For further securing all monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of a financial agreement dated 31.1.86
    Brèves mentions
    Any moneys payable to the company (see doc M54).
    Personnes ayant droit
    • The Secretary of State for Trade and Industry.
    Transactions
    • 03 févr. 1986Enregistrement d'une charge
    • 05 juin 1995Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Financial agreement
    Créé le 31 janv. 1986
    Livré le 03 févr. 1986
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    £4,200,000 and all monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the charge.
    Brèves mentions
    All the company's beneficial interest and all its benefits rights and title including all parts of the vessel and all monies payable to the company (see doc M53).
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transactions
    • 03 févr. 1986Enregistrement d'une charge
    • 05 juin 1995Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)

    CAPITAL BANK LEASING 3 LIMITED a-t-elle des procédures d'insolvabilité ?

    Numéro de dossierDatesTypePraticiensAutre
    1
    DateType
    31 oct. 2019Commencement of winding up
    29 oct. 2019Declaration of solvency sworn on
    Members voluntary liquidation
    NomRôleAdresseNommé leCessé le
    Samantha Keen
    1 More London Place
    SE1 2AF London
    practitioner
    1 More London Place
    SE1 2AF London
    Richard Barker
    1 More London Place
    SE1 2AF London
    practitioner
    1 More London Place
    SE1 2AF London

    Source de données

    • Companies House du Royaume-Uni
      Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers.
    • Licence: CC0