CAPITAL BANK LEASING 3 LIMITED
Vue d'ensemble
Nom de la société | CAPITAL BANK LEASING 3 LIMITED |
---|---|
Statut de la société | Liquidation |
Forme juridique | Société à responsabilité limitée |
Numéro de société | 00836962 |
Juridiction | Angleterre/Pays de Galles |
Date de création |
Résumé
A des PSCs super sécurisés | Non |
---|---|
A des charges | Oui |
A un historique d'insolvabilité | Oui |
Le siège social est contesté | Non |
Où se situe CAPITAL BANK LEASING 3 LIMITED ?
Adresse du siège social | 1 More London Place SE1 2AF London |
---|---|
Adresse du siège social non livrable | Non |
Quels sont les derniers comptes de CAPITAL BANK LEASING 3 LIMITED ?
En retard | Oui |
---|---|
Prochains comptes | |
Fin de la prochaine période comptable le | 31 mars 2019 |
Date d'échéance des prochains comptes | 31 déc. 2019 |
Derniers comptes | |
Derniers comptes arrêtés au | 31 mars 2018 |
Quel est le statut de la dernière déclaration de confirmation pour CAPITAL BANK LEASING 3 LIMITED ?
En retard | Oui |
---|---|
Dernière déclaration de confirmation établie jusqu'au | 01 févr. 2020 |
Date d'échéance de la prochaine déclaration de confirmation | 15 févr. 2020 |
Dernière déclaration de confirmation | |
Prochaine déclaration de confirmation établie jusqu'au | 01 févr. 2019 |
En retard | Oui |
Quels sont les derniers dépôts pour CAPITAL BANK LEASING 3 LIMITED ?
Date | Description | Document | Type | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Déclaration des reçus et paiements des liquidateurs jusqu'à 30 oct. 2024 | 9 pages | LIQ03 | ||||||||||
Cessation de la nomination de John Robert Turner en tant que directeur le 30 janv. 2024 | 1 pages | TM01 | ||||||||||
Déclaration des reçus et paiements des liquidateurs jusqu'à 30 oct. 2023 | 9 pages | LIQ03 | ||||||||||
Nomination de Nicholas Andrew Williams en tant qu'administrateur le 28 oct. 2022 | 2 pages | AP01 | ||||||||||
Cessation de la nomination de Richard Andrew Jones en tant que directeur le 28 oct. 2022 | 1 pages | TM01 | ||||||||||
Déclaration des reçus et paiements des liquidateurs jusqu'à 30 oct. 2022 | 9 pages | LIQ03 | ||||||||||
Déclaration des reçus et paiements des liquidateurs jusqu'à 30 oct. 2021 | 10 pages | LIQ03 | ||||||||||
Déclaration des reçus et paiements des liquidateurs jusqu'à 30 oct. 2020 | 9 pages | LIQ03 | ||||||||||
Cessation de la nomination de Alyson Elizabeth Mulholland en tant que secrétaire le 08 sept. 2020 | 1 pages | TM02 | ||||||||||
Les registres ont été transférés au lieu d'inspection enregistré Cawley House Chester Business Park Chester Cheshire CH4 9FB | 2 pages | AD03 | ||||||||||
Changement d'adresse du siège social de Charterhall House Charterhall Drive Chester Cheshire CH88 3AN à 1 More London Place London SE1 2AF le 15 nov. 2019 | 2 pages | AD01 | ||||||||||
L'adresse d'inspection du registre a été modifiée à Cawley House Chester Business Park Chester Cheshire CH4 9FB | 2 pages | AD02 | ||||||||||
Nomination d'un liquidateur volontaire | 3 pages | 600 | ||||||||||
Résolutions Resolutions | 1 pages | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
Déclaration de solvabilité | 5 pages | LIQ01 | ||||||||||
Modification des coordonnées du secrétaire Alyson Elizabeth Mulholland le 04 mars 2019 | 1 pages | CH03 | ||||||||||
Déclaration de confirmation établie le 01 févr. 2019 sans mise à jour | 3 pages | CS01 | ||||||||||
Modification des coordonnées de l'administrateur Mr Richard Andrew Jones le 25 janv. 2019 | 2 pages | CH01 | ||||||||||
Modification des coordonnées de l'administrateur Mr John Robert Turner le 04 janv. 2019 | 2 pages | CH01 | ||||||||||
Comptes annuels établis au 31 mars 2018 | 21 pages | AA | ||||||||||
Cessation de la nomination de Gerard Ashley Fox en tant que directeur le 24 juil. 2018 | 1 pages | TM01 | ||||||||||
Cessation de la nomination de Andrew John Kemp en tant que directeur le 24 juil. 2018 | 1 pages | TM01 | ||||||||||
Modification des coordonnées de l'administrateur Mr Andrew John Kemp le 06 avr. 2018 | 2 pages | CH01 | ||||||||||
Déclaration de confirmation établie le 01 févr. 2018 avec mises à jour | 4 pages | CS01 | ||||||||||
Comptes annuels établis au 31 mars 2017 | 22 pages | AA | ||||||||||
Qui sont les dirigeants de CAPITAL BANK LEASING 3 LIMITED ?
Nom | Nommé le | Date de démission | Rôle | Adresse | Identification de la société | Pays de résidence | Nationalité | Date de naissance | Profession | Numéro |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WILLIAMS, Nicholas Andrew | Administrateur | Cheadle Heath SK3 0RB Stockport Heathside Park Cheshire United Kingdom | United Kingdom | British | Director | 301976570001 | ||||
GITTINS, Paul | Secrétaire | House Charterhall Drive CH88 3AN Chester Tower United Kingdom | British | 45660860003 | ||||||
JOHNSON, Michelle Antoinette Angela | Secrétaire | Tower House Charterhall Drive CH88 3AN Chester 1st Floor East England England | 212718920001 | |||||||
MULHOLLAND, Alyson Elizabeth | Secrétaire | Chester Business Park CH4 9FB Chester Cawley House United Kingdom | 239870800001 | |||||||
NIXON, Raymond | Secrétaire | Holly House The Steadings Wicker Lane, Guilden Sutton CH3 7EL Chester Cheshire | British | 36433110016 | ||||||
BALLINGALL, Stuart James | Administrateur | 39 Craigleith Drive EH4 3JU Edinburgh Midlothian | British | Chartered Accountant | 118506820001 | |||||
BARCLAY, William Gordon | Administrateur | The Coulin 122 Stanstead Road CR3 6AE Caterham Surrey | British | Director | 33196560002 | |||||
BLACKWELL, Timothy Mark | Administrateur | Tresillian Terrace CF10 5BH Cardiff St William House United Kingdom | England | British | Director | 124967310001 | ||||
BOCHENSKI, Anthony Joseph John | Administrateur | Greenacres Bryn Offa Lane CH7 6RQ Mold Flintshire | United Kingdom | British | Company Solicitor | 145644720001 | ||||
BROWN, John Sydney | Administrateur | 15 Newick Avenue Little Aston B74 3DA Sutton Coldfield West Midlands | United Kingdom | British | Company Director | 58961420001 | ||||
BUSH, Claude Harry | Administrateur | 51 Church Croft Dodleston CH4 9NT Chester Cheshire | British | Company Director | 427540002 | |||||
CHESSMAN, Steven David Russell | Administrateur | Charterhall Drive CH88 3AN Chester Tower House United Kingdom | England | British | Sales Director | 135147710001 | ||||
EDWARDS, Jayson | Administrateur | Tresillian Terrace CF10 5BH Cardiff St William House United Kingdom | Wales | British | Accountant | 165227870001 | ||||
FERGUSON, Gordon | Administrateur | St Vincent Street G2 5ER Glasgow 110 United Kingdom | Scotland | British | Head Of Operations | 87681450001 | ||||
FOX, Gerard Ashley | Administrateur | London Wall EC2Y 5AJ London 125 United Kingdom | England | British | Banker | 179100520001 | ||||
GRACE, Adrian Thomas | Administrateur | Charterhall Drive CH88 3AN Chester Charterhall House Cheshire | British | Managing Director | 128752720001 | |||||
GRIFFITHS, Michael John David, Mr. | Administrateur | House Charterhall Drive CH88 3AN Chester Tower United Kingdom | United Kingdom | British | Director | 95344900001 | ||||
HAMMOND, John Sidney | Administrateur | 65 Poulton Road Spital L63 9LD Bebington Merseyside | British | Assistant General Manager | 102290001 | |||||
HARE, Robert Brown | Administrateur | 13 Balgreen Avenue EH12 5SX Edinburgh Lothian | British | Director | 64474720003 | |||||
HARRIS, Kevin Charles | Administrateur | London Wall EC2Y 5AJ London 125 United Kingdom | United Kingdom | British | Director | 170091040001 | ||||
JONES, Richard Andrew | Administrateur | 37 South Gyle Crescent EH12 9DS Edinburgh Ettrick House United Kingdom | United Kingdom | British | Director | 130118640005 | ||||
KEMP, Andrew John | Administrateur | Canons House Canons Way BS1 5LL Bristol Ground Floor United Kingdom | England | British | Director | 222042280001 | ||||
LITTLER, Roy | Administrateur | 3 The Paddock Curzon Park CH4 8AE Chester Cheshire | British | Deputy Managing Director | 2211250001 | |||||
MERCER, John Alexander | Administrateur | Llwyn-Y-Cyll Lixwm CH8 8LY Holywell Clwyd | British | Managing Director | 4672880001 | |||||
MORRISSEY, John Michael | Administrateur | House Charterhall Drive CH88 3AN Chester Tower United Kingdom | England | British | Chartered Accountant | 94094650001 | ||||
PERRY, Michael Richard | Administrateur | 10 The Paddock Willaston CW5 7HJ Nantwich Cheshire | British | Company Director | 102300002 | |||||
REID, George Gibson | Administrateur | 46/1 Morningside Park EH10 5HA Edinburgh Lothian | British | Accountant | 95498730001 | |||||
RITCHIE, Carol Ann | Administrateur | 34 Hob Hey Lane Culcheth WA3 4NW Warrington Cheshire | England | British | Chief Accountant | 46402710001 | ||||
SKINNER, Trevor John | Administrateur | 2 Tudor Court B95 4AP Henly In Arden Warwickshire | British | Assistant General Manager | 427570015 | |||||
STAPLES, Martin Kenneth | Administrateur | 1 Douglas Drive Crossford KY12 8PB Dunfermline Fife | Scotland | British | Accountant | 110383950001 | ||||
SUTTON, Christopher | Administrateur | Orchard Brae EH4 1PF Edinburgh Finance House United Kingdom | Scotland | British | Consumer Finance Director | 130660440002 | ||||
TOWN, Lindsay John | Administrateur | 10 Ferndale TN2 3PB Tunbridge Wells Kent | England | British | Managing Director | 64287260001 | ||||
TRACE, James Owen | Administrateur | House Charterhall Drive CH88 3AN Chester Tower United Kingdom | England | British | Senior Manager | 159477760001 | ||||
TURNER, John Robert | Administrateur | Gresham Street EC2V 7AE London 10 United Kingdom | England | British | Director | 76185650001 | ||||
WEBSTER, Alistair Linn | Administrateur | 7 Ettrick Road EH10 5BJ Edinburgh | Scotland | British | Accountant | 60101190002 |
Qui sont les personnes ayant un contrôle significatif sur CAPITAL BANK LEASING 3 LIMITED ?
Nom | Notifié le | Adresse | Cessé | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bank Of Scotland Plc | 06 avr. 2016 | EH1 1YZ Edinburgh The Mound United Kingdom | Non | ||||||||||
| |||||||||||||
Nature du contrôle
|
CAPITAL BANK LEASING 3 LIMITED a-t-elle des charges ?
Classification | Dates | Statut | Détails | |
---|---|---|---|---|
Letter of charge | Créé le 19 juin 1996 Livré le 10 juil. 1996 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever | |
Brèves mentions All monies standing to the credit of any account or accounts in the banks books. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
Letter of charge | Créé le 20 févr. 1995 Livré le 22 févr. 1995 | Totalement satisfaite | Montant garanti All moneys due or to become due from the principal debtors (as defined) or any of them to the chargee on any account whatsoever | |
Brèves mentions All moneyd standing to the credit of the company with the bank. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
Letter of charge | Créé le 13 déc. 1994 Livré le 23 déc. 1994 | Totalement satisfaite | Montant garanti All moneys due or to become due from all the companys named therein to the chargee on any account whatsoever | |
Brèves mentions All moneys standing to the credit of any account of the company with the bank. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
Letter of charge | Créé le 12 août 1993 Livré le 20 août 1993 | Totalement satisfaite | Montant garanti All moneys due or to become due from the company and/or all orany of the companies named in the charge to the chargee on any account whatsoever | |
Brèves mentions All moneys standing to the credit of any account of the company with the bank. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
Deed of covenant | Créé le 20 mars 1987 Livré le 25 mars 1987 | Totalement satisfaite | Montant garanti £4,200,000 and all other moneys due or to become due from the company and/or sealink U.K. limited to the chargee under the terms of a financial agreement dated 31 jan 86 the mortgage and this deed both of even date (each as may from time to time be amended) | |
Brèves mentions All the rights title interest and benefits in and under:- a) M.V. "st. Cecilia" registered at the port of london under official no. 712850B) the earnings and insurances of the vessel and any compensation payable in respect of requisition for title or other compulsory acquisition of the vessel. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
Statutory mortgage | Créé le 20 mars 1987 Livré le 25 mars 1987 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from the company to the chargee on an account current under the terms of a deed of covenant of even date and regulated by a financial agreement dated 31 jan 86 (each as may from time to time be amneded) | |
Brèves mentions 64/64TH shares of and in M.V. "st. Cecilia" registered at the port of london under official no. 712850. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
Shipowners agreement | Créé le 31 janv. 1986 Livré le 03 févr. 1986 | Totalement satisfaite | Montant garanti For further securing all monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of a financial agreement dated 31.1.86 | |
Brèves mentions Any moneys payable to the company (see doc M54). | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
Financial agreement | Créé le 31 janv. 1986 Livré le 03 févr. 1986 | Totalement satisfaite | Montant garanti £4,200,000 and all monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the charge. | |
Brèves mentions All the company's beneficial interest and all its benefits rights and title including all parts of the vessel and all monies payable to the company (see doc M53). | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
|
CAPITAL BANK LEASING 3 LIMITED a-t-elle des procédures d'insolvabilité ?
Numéro de dossier | Dates | Type | Praticiens | Autre | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
| Members voluntary liquidation |
|
Source de données
- Companies House du Royaume-Uni
Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers. - Licence: CC0